RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED

RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRICHARDSONS WESTGARTH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00067599
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHARDSONS WESTGARTH P L C29 ott 190029 ott 1900

    Quali sono gli ultimi bilanci di RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 23 set 2022

    7 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di George Clinton Jones come amministratore in data 16 dic 2021

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 set 2021

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    4 pagineSH20

    Stato del capitale al 20 dic 2020

    • Capitale: GBP 0.10
    3 pagineSH19

    legacy

    4 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Peter Whiting come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Barrie Clive Salter come amministratore in data 14 dic 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr David Gross come amministratore in data 14 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kakha Avaliani come amministratore in data 14 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Henry Gross come segretario in data 01 ott 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Ciara Milne come segretario in data 01 ott 2018

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ciara Milne come amministratore in data 16 lug 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GROSS, David Henry
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Segretario
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    251144510001
    GROSS, David
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandAmerican253044410001
    SALTER, Barrie Clive
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish253495610001
    WHITING, Peter
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish256986430001
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Segretario
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    British108483890002
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Spa Mews
    Boston Spa
    LS23 6TR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Spa Mews
    Boston Spa
    LS23 6TR Leeds
    West Yorkshire
    British7474650002
    MARJORIBANKS, Richard John Bradley
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    178398790001
    MIDDIS, Kevin John
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Segretario
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    British81620510001
    MILNE, Ciara
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    212823850001
    SPENCER, Joanne Louise
    22 Lidgett Way
    Royston
    S71 4FD Barnsley
    South Yorkshire
    Segretario
    22 Lidgett Way
    Royston
    S71 4FD Barnsley
    South Yorkshire
    British83985870001
    ARMSTRONG, Gregory Francis John
    5 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    Amministratore
    5 Barnetts Grove
    DY10 3HG Kidderminster
    Worcestershire
    British9444610001
    AVALIANI, Kakha
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    EnglandBritish152448300001
    DEAN, Alan Martin
    Bollindale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Bollindale South Road
    Hale
    WA14 3HT Altrincham
    Cheshire
    British62800840003
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish108483890002
    HURST, Philip John
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    British9447640003
    JONES, George Clinton
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish70121220002
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish7474650008
    MACDONALD, Alexander Scott
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish3480700001
    MIDDIS, Kevin John
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Amministratore
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    EnglandBritish81620510001
    MILNE, Ciara
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm Road
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish209116720001
    PAYTON, Roger Louis
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    Amministratore
    Little Bedwell Essendon
    Cucumber Lane
    AL9 6JA Hatfield
    Hertfordshire
    British1866960001
    RINGWOOD, George
    26 Dower Chase
    Escrick
    YO4 6JF York
    North Yorkshire
    Amministratore
    26 Dower Chase
    Escrick
    YO4 6JF York
    North Yorkshire
    British9298090001
    SKELTON, Nichola
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Valley Farm
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish161424200001
    TAINTON, John Samuel
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    Amministratore
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    British9305720001
    TAYLOR, Paul
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British50931220001
    TIPLADY, John Eason
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    British3480680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Kloeckner Metals Uk Holdings Limited
    Valley Farm Road
    LS10 1SD Leeds
    Kmuk
    England
    06 apr 2016
    Valley Farm Road
    LS10 1SD Leeds
    Kmuk
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006, Uk Gaap Inc Frs 101
    Luogo di registrazioneCompanies House - Cardiff
    Numero di registrazione5310738
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 16 mar 2005
    Consegnato il 19 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the chargee as security agent and trustee for the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 ott 1994
    Consegnato il 31 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at drum road, drum industrial estate, chester-le-street, county durham and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 mag 1992
    Consegnato il 03 giu 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a premises at tunstall road, biddulph, stafford and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Licence to underlet
    Creato il 31 ott 1986
    Consegnato il 17 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £4,500 deposited pursuant to a licence to underlet dated 31/10/86.
    Persone aventi diritto
    • W P Pension Trustees Limited
    • W P Group Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 17 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 1984
    Consegnato il 30 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the south of elm road shoeburyness southend on sea, essex. Title no ex 189555 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 17 apr 1984
    Consegnato il 30 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the south side of vanguard way, shoeburyness, southend on sea, essex. Title no. Ex 170499 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of easthampstead road, bracknell berkshire title no. Bk 123332 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as land lying to the east of easthampstead road bracknell, berkshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 53565 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north side of easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 83638 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 149899 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 01 mar 1984
    Consegnato il 12 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 rosemount easthampstead road, bracknell, berkshire title no. Bk 150306 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 29 set 1983
    Consegnato il 10 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale thereof fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RICHARDSONS WESTGARTH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 set 2021Inizio della liquidazione
    18 mar 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0