B L H REALISATIONS LIMITED

B L H REALISATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB L H REALISATIONS LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00072141
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B L H REALISATIONS LIMITED?

    • (2922) /

    Dove si trova B L H REALISATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di B L H REALISATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUTTERLEY LIMITED23 feb 200723 feb 2007
    BUTTERLEY OFFSHORE ENGINEERING LIMITED02 nov 200602 nov 2006
    BUTTERLEY LIMITED11 feb 200211 feb 2002
    BUTTERLEY ENGINEERING LIMITED02 gen 198502 gen 1985
    A. B. CRANES LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    ADAMSON BUTTERLEY LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    JOHN SMITH(KEIGHLEY),LIMITED12 dic 190112 dic 1901

    Quali sono gli ultimi bilanci di B L H REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 apr 2008
    Scadenza dei prossimi bilanci il28 feb 2009
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2007

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per B L H REALISATIONS LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 giu 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 giu 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per B L H REALISATIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per B L H REALISATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    5 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ott 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 apr 2013

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ott 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 apr 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ott 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 apr 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 05 ott 2010

    6 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    1 pagine4.33

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da * Engineering Works Ripley Derbyshire DE5 3BQ* in data 16 ott 2009

    1 pagineAD01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    5 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    27 pagine2.23B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed butterley LIMITED\certificate issued on 15/05/09
    3 pagineCERTNM

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    1 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    21 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di B L H REALISATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MEADE, Christopher Martyn
    Hays Mews
    W1J 5QA London
    40
    Amministratore
    Hays Mews
    W1J 5QA London
    40
    Untied KingdomBritishDirector72314540001
    OHANDJANIAN, Demis Armen
    219 Clifton Road
    CV21 3QW Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    219 Clifton Road
    CV21 3QW Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector118283730001
    SEWARD, Douglas Arthur
    Welford Grange
    Naseby Road, Welford
    NN6 6HZ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Welford Grange
    Naseby Road, Welford
    NN6 6HZ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishDirector70987430001
    AMES, Richard Adam
    2 Chatsworth Avenue
    S40 3JU Chesterfield
    Derbyshire
    Segretario
    2 Chatsworth Avenue
    S40 3JU Chesterfield
    Derbyshire
    British110891570001
    BROOKES, Peter
    Clifton Road
    Matlock Bath
    DE4 3PW Matlock
    17
    Derbyshire
    Segretario
    Clifton Road
    Matlock Bath
    DE4 3PW Matlock
    17
    Derbyshire
    BritishAccountant129450530001
    BUSH, Nicolette Jemima
    Brook Farm Cottage
    West Kington
    SN14 7JQ Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Brook Farm Cottage
    West Kington
    SN14 7JQ Chippenham
    Wiltshire
    British91446630002
    MANN, Michelle Loraine
    12 Coombe Close
    Blaise Dell Henbury
    BS10 7XG Bristol
    Segretario
    12 Coombe Close
    Blaise Dell Henbury
    BS10 7XG Bristol
    BritishAccountant73352790001
    MCQUEEN, Melanie Ann
    Lane End
    Station Road, South Cerney
    GL7 5UB Cirencester
    Gloucestershire
    Segretario
    Lane End
    Station Road, South Cerney
    GL7 5UB Cirencester
    Gloucestershire
    British113373410001
    MORRISON, John
    4 Ridgestone Avenue
    Hemsworth
    WF9 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    4 Ridgestone Avenue
    Hemsworth
    WF9 4JH Pontefract
    West Yorkshire
    BritishAccountant85292710001
    OAKEY, Anthony Louis
    4 Hathersage Rise
    Ravenshead
    NG15 9DX Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    4 Hathersage Rise
    Ravenshead
    NG15 9DX Nottingham
    Nottinghamshire
    British10567070001
    OHANDJANIAN, Demis Armen
    219 Clifton Road
    CV21 3QW Rugby
    Warwickshire
    Segretario
    219 Clifton Road
    CV21 3QW Rugby
    Warwickshire
    BritishFinancial Controller118283730001
    WARD, Nicolette Jemima
    Brook Farm Cottage
    West Kington
    SN14 7JQ Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    Brook Farm Cottage
    West Kington
    SN14 7JQ Chippenham
    Wiltshire
    BritishSecretary91446630001
    ATHERTON, Edwin David
    The Forge
    Bowns Hill, Crich
    DE4 5DG Matlock
    Derbyshire
    Amministratore
    The Forge
    Bowns Hill, Crich
    DE4 5DG Matlock
    Derbyshire
    BritishCivil Engineer67893750001
    BARLOW, Peter Malcolm
    School Lane
    DE45 1RZ Baslow
    Derwent House
    Derbyshire
    Uk
    Amministratore
    School Lane
    DE45 1RZ Baslow
    Derwent House
    Derbyshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector187340190001
    BONFIELD, Julian Leslie
    19 Caernarvon Close
    Swanwick
    DE55 1EG Alfreton
    Derbyshire
    Amministratore
    19 Caernarvon Close
    Swanwick
    DE55 1EG Alfreton
    Derbyshire
    BritishChartered Engineer67893850001
    CASTLEDINE, Colin Victor
    The Cottage
    Creamery Lane, Parwich
    DE6 1QB Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    The Cottage
    Creamery Lane, Parwich
    DE6 1QB Ashbourne
    Derbyshire
    BritishDirector85611490001
    COLLINS, Edward Vincent
    2 Bickford Close
    Lapley
    ST19 9JZ Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    2 Bickford Close
    Lapley
    ST19 9JZ Stafford
    Staffordshire
    BritishDirector10567080001
    EXON, John
    6 Waltham Road
    Ravenshead
    NG15 9FP Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Waltham Road
    Ravenshead
    NG15 9FP Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector112268310001
    HAWLEY, Melvyn
    Avenue Farm Old Hay Lane
    Dore
    S17 3AT Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Avenue Farm Old Hay Lane
    Dore
    S17 3AT Sheffield
    South Yorkshire
    BritishDirector1451530001
    MAYHEAD, Clive Douglas
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    Amministratore
    The Grange
    Bagwell Lane
    RG27 8DB Winchfield
    Hampshire
    BritishDirector10567100002
    MCGRATH, Damien Paul
    The Slipway
    Manorial Road
    CH64 6QW Parkgate
    Cheshire
    Amministratore
    The Slipway
    Manorial Road
    CH64 6QW Parkgate
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Director106356880001
    MEADE, Martyn
    Industries House
    SN16 0JC Sherston
    Wiltshire
    Amministratore
    Industries House
    SN16 0JC Sherston
    Wiltshire
    BritishDirector72314540002
    MERCER, David Andrew
    9 Harrow Road
    Leighton Buzzard
    LU7 4UF Beds
    Amministratore
    9 Harrow Road
    Leighton Buzzard
    LU7 4UF Beds
    BritishDirector121117960001
    MICKLEBURGH, Brinsley
    Asmari
    16 Third Avenue
    CO13 9EG Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    Asmari
    16 Third Avenue
    CO13 9EG Frinton On Sea
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65970640001
    MICKLEBURGH, Brinsley
    Asmari
    16 Third Avenue
    CO13 9EG Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    Asmari
    16 Third Avenue
    CO13 9EG Frinton On Sea
    Essex
    United KingdomBritishChartered Accountant65970640001
    MYRONKO, Melvyn Robert
    167 Longedge Lane
    S42 6PR Wingerworth
    Chesterfield
    Amministratore
    167 Longedge Lane
    S42 6PR Wingerworth
    Chesterfield
    EnglandBritishHead Of Engineering60185220002
    OAKEY, Anthony Louis
    4 Hathersage Rise
    Ravenshead
    NG15 9DX Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    4 Hathersage Rise
    Ravenshead
    NG15 9DX Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector10567070001
    THOMPSON, Michael Andre
    Chestnut House
    Church Road West Hanningfield
    CM2 8UJ Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Chestnut House
    Church Road West Hanningfield
    CM2 8UJ Chelmsford
    Essex
    EnglandBritishDirector117868900001

    B L H REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattels mortgage
    Creato il 21 giu 2006
    Consegnato il 22 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattela plant and machinery being airchannel spraybooths & extraction unit s/nos 58274 63169 airchannel compressed air system s/nos 2645390001 2915640001 hodge clemco blast room equipment s/nos blast pot 1 5359 blast pot 2 - 5358 for details of further chattels charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limiyed & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 01 giu 2005
    Consegnato il 02 giu 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 11 ott 2000
    Consegnato il 17 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Debenture
    Creato il 14 feb 1989
    Consegnato il 21 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 feb 1990Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental trust deed
    Creato il 19 mag 1980
    Consegnato il 29 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000,000 15 3/4 per cent debenture stock 1990/1995 of noreross limited supplemental to a trust deed dated 1ST october 1975.
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 29 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 22 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    B L H REALISATIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    06 ott 2009Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alistair Gareth Wardell
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Neil Tombs
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    2
    DataTipo
    06 ott 2009Inizio della liquidazione
    24 mag 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alistair Gareth Wardell
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    11-13 Penhill Road
    CF11 9UP Cardiff
    Neil Tombs
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    Enterprise House
    B3 2HJ 115 Edmund Street
    Birmingham
    David James Bennett
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham
    Praticante
    Enterprise House 115 Edmund Street
    B3 2HJ Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0