FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED

FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00072813
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Millbank Tower
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PLUMPTON RACECOURSE P L C(THE)17 feb 190217 feb 1902

    Quali sono gli ultimi bilanci di FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    The sole member resolved to wind up the company voluntarily. 20/08/2015
    RES13

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Anthony Brian Kelly come amministratore in data 23 lug 2015

    1 pagineTM01

    Stato del capitale al 01 dic 2014

    • Capitale: GBP 0.25
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2014

    Stato del capitale al 20 ott 2014

    • Capitale: GBP 198,664
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Stuart Robertson il 07 ago 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Kevin Stuart Robertson come amministratore

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 ott 2013

    Stato del capitale al 29 ott 2013

    • Capitale: GBP 198,664
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    11 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Robert Renton come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Ian Renton il 12 giu 2012

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Robert Ian Renton come amministratore

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 12C Lancaster Park Needwood Burton on Trent Staffs DE13 9PD* in data 18 mag 2012

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Rachel Nelson come segretario

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANGRIDGE, Megan Joy
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    Segretario
    Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    42
    Kent
    United Kingdom
    169114650001
    NAHUM, Stephane Abraham Joseph
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    Amministratore
    21a Kensington High Street
    W8 5NP London
    United KingdomFrench99292580014
    O'DRISCOLL, Patrick Colin
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    EnglandIrish75571770002
    ROBERTSON, Kevin Stuart
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    EnglandBritish189098720001
    GRIGGS, Clifford Ernest
    Meadow Down
    Rookery Way
    RH16 Haywards Heath
    West Sussex
    Segretario
    Meadow Down
    Rookery Way
    RH16 Haywards Heath
    West Sussex
    British14204190001
    KELLY, Anthony Brian
    Merrimeet
    Kerves Lane
    RH13 6ET Horsham
    West Sussex
    Segretario
    Merrimeet
    Kerves Lane
    RH13 6ET Horsham
    West Sussex
    British66203340003
    NELSON, Rachel Anne
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    Segretario
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    British128053130001
    O'CONNELL, Daniel Gerard
    20 Croft Way
    TN13 2JX Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    20 Croft Way
    TN13 2JX Sevenoaks
    Kent
    Irish37434170003
    STOKES, Mark Bryan
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74798060005
    CLARKE, Simon William
    Newchurch
    Hoar Cross
    DE13 8RL Burton-On-Trent
    Lower Lynbrook Farm
    Staffordshire
    Amministratore
    Newchurch
    Hoar Cross
    DE13 8RL Burton-On-Trent
    Lower Lynbrook Farm
    Staffordshire
    United KingdomBritish19863530002
    CLARKE, Stanley William, Sir
    The Knoll
    Main Street
    DE13 8AB Barton Under Needwood
    Staffordshire
    Amministratore
    The Knoll
    Main Street
    DE13 8AB Barton Under Needwood
    Staffordshire
    British9443230001
    GRIGGS, Clifford Ernest
    Meadow Down
    Rookery Way
    RH16 Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Meadow Down
    Rookery Way
    RH16 Haywards Heath
    West Sussex
    British14204190001
    HARRINGTON, Julie Anne
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    Amministratore
    12c Lancaster Park Needwood
    Burton On Trent
    DE13 9PD Staffs
    EnglandBritish118654280002
    KELLY, Anthony Brian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    United KingdomBritish66203340004
    KERMAN, Anthony David
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    Amministratore
    5 Saint Jamess Square
    SW1Y 4JU London
    United KingdomBritish72531870002
    KERMAN, Isidore
    79 New Cavendish Street
    W1M 8AQ London
    Amministratore
    79 New Cavendish Street
    W1M 8AQ London
    British35542530002
    PRATT, Adrian John Charles
    Orchard Lodge Dewhurst Lane
    TN5 6QE Wadhurst
    East Sussex
    Amministratore
    Orchard Lodge Dewhurst Lane
    TN5 6QE Wadhurst
    East Sussex
    United KingdomBritish141615280001
    RENTON, Robert Ian
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    Amministratore
    21-24 Millbank
    SW1P 4QP London
    Millbank Tower
    England
    England
    EnglandBritish133733440001
    STOKES, Mark Bryan
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Ridge Farm
    172 Harvestfields Way Roughley
    B75 5TJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74798060005
    STREET, Rodney Grant
    1 Walnut Walk
    Victoria Park
    WS13 8FA Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Walnut Walk
    Victoria Park
    WS13 8FA Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish65390550002
    WATES, Andrew Trace Allan
    Henfold House
    Henfold Lane
    RH5 4RW Beare Green
    Surrey
    Amministratore
    Henfold House
    Henfold Lane
    RH5 4RW Beare Green
    Surrey
    EnglandBritish151631820001

    FONTWELL PARK (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 20 ago 2007
    Consegnato il 24 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of a security interest to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 ago 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Amendment agreement relating to a mortgage debenture dated 20 december 2002 and
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 05 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC as Agent and Trustee for the Lenders
    Transazioni
    • 05 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over deposits
    Creato il 24 feb 2003
    Consegnato il 27 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A first fixed charge over any sums deposited or to be deposited by the company in any deposit account of the company held with the bank at any of its branches.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 27 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 dic 2002
    Consegnato il 31 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 31 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 giu 2002
    Consegnato il 13 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 set 1992
    Consegnato il 02 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Horserace Betting Levy Board
    Transazioni
    • 02 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1992
    Consegnato il 19 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the north of the land from streat to east chilington plumpton and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 set 1991
    Consegnato il 21 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 29 ago 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1987
    Consegnato il 12 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate at and shortly k/a plumpton racecourse, plumpton, east sussex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Horserace Betting Levy Board.
    Transazioni
    • 12 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0