PHILIP & TACEY,LIMITED

PHILIP & TACEY,LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHILIP & TACEY,LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00075919
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHILIP & TACEY,LIMITED?

    • fabbricazione di articoli di cartoleria (17230) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PHILIP & TACEY,LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Findel House
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHILIP & TACEY,LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per PHILIP & TACEY,LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 17 dic 2021

    • Capitale: GBP 10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 17 dic 2021

    • Capitale: GBP 1,590,430
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 16 dic 2021

    • Capitale: GBP 1,610,430
    4 pagineSH01

    Soddisfazione dell'onere 000759190017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 000759190016 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Martin David Jones come amministratore in data 16 apr 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Whittaker come amministratore in data 16 apr 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Murdoch Caldwell come amministratore in data 16 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Ashcroft come amministratore in data 16 apr 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Ashcroft come segretario in data 16 apr 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Chris David Mahady come amministratore in data 16 apr 2021

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Findel House Gregory Street Hyde Cheshire Sk14 $Hr United Kingdom a Findel House Gregory Street Hyde Cheshire SK14 4HR in data 14 mag 2021

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Church Bridge House Henry Street Accrington BB5 4EE United Kingdom a Findel House Gregory Street Hyde Cheshire Sk14 $Hr in data 14 mag 2021

    1 pagineAD01

    Memorandum e Statuto

    18 pagineMA

    Chi sono gli amministratori di PHILIP & TACEY,LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Martin David
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish202929240001
    MAHADY, Chris David
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish283179270001
    WHITTAKER, Mark
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish90423740002
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Gregory Street
    SK14 4TH Hyde
    2
    Cheshire
    United Kingdom
    165368980001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Segretario
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    British14333000007
    HORSFIELD, Ian James
    Griffin House Zion Road
    SP11 7EN Andover
    Hampshire
    Segretario
    Griffin House Zion Road
    SP11 7EN Andover
    Hampshire
    British47448200001
    JARVIS, Ernest Arthur
    Forest Edge Straight Mile
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    Segretario
    Forest Edge Straight Mile
    Ampfield
    SO51 9BA Romsey
    Hampshire
    British12774730001
    ASHCROFT, Mark
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113691350001
    BOLTON, Ivan Joseph, Dr
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Amministratore
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish14333000007
    CALDWELL, Stuart Murdoch
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Findel House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish229000880001
    CHAPMAN, Keith
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Flasby
    BD23 3PX Skipton
    Flasby Hall
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish143093130001
    CLAXTON, Peter Robert
    3 Rose Cottage
    Moddershall
    ST15 8TG Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    3 Rose Cottage
    Moddershall
    ST15 8TG Stone
    Staffordshire
    British65714940001
    DUTTON, David Brian
    Marsden Old Vicarage
    20 Station Road
    HD7 6DG Marsden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Marsden Old Vicarage
    20 Station Road
    HD7 6DG Marsden
    West Yorkshire
    United KingdomBritish153319990001
    HINTON, Christopher David
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    Amministratore
    Henry Street
    Church
    BB5 4EH Accrington
    Church Bridge House
    Lancashire
    EnglandBritish68474940001
    JARVIS, Ernest Arthur
    49 Newton Lane
    SO51 8GX Romsey
    Hampshire
    Amministratore
    49 Newton Lane
    SO51 8GX Romsey
    Hampshire
    United KingdomBritish12774730002
    JOLLY, Patrick Edmund
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    Amministratore
    Hill Top Farm
    Hill Top Lane Skipton Road,
    BB18 6JN Earby
    Lancashire
    EnglandBritish75327660001
    KOWALSKI, Timothy John
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Amministratore
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    UkBritish153335190003
    MAUDSLEY, Philip Binns
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    United KingdomBritish15967010001
    SIDDLE, Roger William John
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    Amministratore
    2 Gregory Street
    SK14 4HR Hyde
    Cheshire
    England
    EnglandBritish46903210001
    SWEENEY, Pippa
    40 Garrick Road
    KT12 5PA Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    40 Garrick Road
    KT12 5PA Walton On Thames
    Surrey
    British83850210002
    TACEY, Charles Arthur
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    British12774740001
    TACEY, John Walter Frank
    Nakuru Red Post Lane
    Weyhill
    SP11 0PY Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Nakuru Red Post Lane
    Weyhill
    SP11 0PY Andover
    Hampshire
    British2191970001
    TACEY, Jon
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Waylands
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0BD Andover
    Hampshire
    EnglandBritish62240540001
    TACEY, Noel Christopher
    Bramble End
    Burlescombe
    EX16 7JW Tiverton
    Devon
    Amministratore
    Bramble End
    Burlescombe
    EX16 7JW Tiverton
    Devon
    EnglandBritish12774720003
    TACEY, Paul John Thornton
    7 Queen Alexandra Road
    SP2 9LL Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    7 Queen Alexandra Road
    SP2 9LL Salisbury
    Wiltshire
    British55132040001
    VAUGHAN, Gerald David
    Little Talboys
    Main Street Keevil
    BA14 6LM Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Little Talboys
    Main Street Keevil
    BA14 6LM Trowbridge
    Wiltshire
    British57879940002

    Chi sono le persone con controllo significativo di PHILIP & TACEY,LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Henry Street
    BB5 4EE Accrington
    Church Bridge House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00675502
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PHILIP & TACEY,LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2021
    Consegnato il 22 apr 2021
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Studio Retail Group PLC (As Lender)
    Transazioni
    • 22 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2021
    Consegnato il 19 apr 2021
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Endless LLP
    Transazioni
    • 19 apr 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 15 dic 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 gen 2015
    Consegnato il 27 gen 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental security agreement
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £440,000 inter-group loan agreement.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession to the security agreement
    Creato il 16 lug 2010
    Consegnato il 29 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, investments, shares, credit balances, insurances, other contracts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 29 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 nov 1999
    Consegnato il 17 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 14 set 1987
    Consegnato il 01 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage 130 new st, andover, hants and the goodwill of the business.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 07 mar 1985
    Consegnato il 14 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H factory 1 north way walworth estate andover hampshire area 43,000 sq. Ft.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 08 ago 1972
    Consegnato il 15 ago 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    130, new street, andover, hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 apr 1972
    Consegnato il 27 apr 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at northway walworth industrial estate, andover, hants.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on building agreement
    Creato il 08 feb 1971
    Consegnato il 26 feb 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the interest of the company in a building agreement dated 11/1/71 see doc 147.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 25 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 feb 1971
    Consegnato il 26 feb 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital by way of fixed & floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1970
    Consegnato il 14 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    313 merton rd S.W. 18. 155015 & 193643.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 28 nov 1962
    Consegnato il 30 nov 1962
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,800
    Brevi particolari
    Land on the n side of burr rd., Wandsworth, london land and buildings in merton rd, wandsworth, london.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 30 nov 1962Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 14 ago 1958
    Consegnato il 21 ago 1958
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7000
    Brevi particolari
    Land and buildings in merton road and burr road wandsworth london title no 155015 and 193643 comprised in the prior mortgage dated 8 january 1957.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 21 ago 1958Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 08 gen 1957
    Consegnato il 10 gen 1957
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000
    Brevi particolari
    313 merton road, wandsworth, london title nos 155015 and 193643.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Co LTD
    Transazioni
    • 10 gen 1957Registrazione di un'ipoteca
    • 19 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 set 1924
    Consegnato il 24 set 1924
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys etc
    Brevi particolari
    Undertaking assets property & goodwill present & future including uncalled capital for time being.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 set 1924Registrazione di un'ipoteca
    • 04 set 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0