BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC

BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00077576
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOKE TOOL ENGINEERING (HOLDINGS) PUBLIC LIMITED COMPANY03 giu 190303 giu 1903

    Quali sono gli ultimi bilanci di BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore

    2 pagine3.6

    Varie

    Form 3.2 - statement of affairs
    6 pagineMISC

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    33 pagine3.10

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    11 pagine363s

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio consolidato redatto al 30 set 2000

    37 pagineAA

    legacy

    8 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARNOLD, Michael John
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Brockhill
    Naunton
    GL54 3AF Cheltenham
    Gloucestershire
    British48184650002
    COLLINS, Mark William Gerard
    9 Wentworth Avenue
    Whirlowdale Park
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    9 Wentworth Avenue
    Whirlowdale Park
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    British48975410001
    GILL, Paul Michael
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    British30172320001
    ABELL, John David
    Elm House
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    Elm House
    Elmer Street North
    NG31 6RE Grantham
    Lincolnshire
    British71975220002
    BODDINGTON, Robert Christopher Hance
    53 Blenheim Crescent
    W11 2EG London
    Amministratore
    53 Blenheim Crescent
    W11 2EG London
    United KingdomBritish18934930001
    CHILDS, Michael Paul
    Lynwood Cross Hill
    Gringley On The Hill
    DN10 4RE Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lynwood Cross Hill
    Gringley On The Hill
    DN10 4RE Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritish11518120002
    COLLINS, Mark William Gerard
    9 Wentworth Avenue
    Whirlowdale Park
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    9 Wentworth Avenue
    Whirlowdale Park
    S11 9QX Sheffield
    South Yorkshire
    British48975410001
    DASHPER, John Keith
    Todwick Grange
    Todwick
    S26 1JQ Nr. Sheffield
    The Grange
    South Yorkshire
    England
    Amministratore
    Todwick Grange
    Todwick
    S26 1JQ Nr. Sheffield
    The Grange
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritish136128860001
    FRIEND, Bernard Ernest
    Pharos Fishery Road
    Bray
    SL6 1UN Maidenhead
    Berks
    Amministratore
    Pharos Fishery Road
    Bray
    SL6 1UN Maidenhead
    Berks
    British2884770001
    GILL, Paul Michael
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    10 Ringinglow Road
    S11 7PP Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish30172320001
    JONES, Idris
    Quarry House Farm
    High Flatts Upper Denby
    HD8 8XY Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Quarry House Farm
    High Flatts Upper Denby
    HD8 8XY Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish75368790001
    MORRIS, Robert Ridley
    Shore Cottage
    Tanners Lane, East End
    SO41 5SP Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Shore Cottage
    Tanners Lane, East End
    SO41 5SP Lymington
    Hampshire
    United KingdomBritish1585190002
    OWEN, Alfred David
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    Mill Dam House Mill Lane
    Aldridge
    WS9 0NB Walsall
    West Midlands
    EnglandBritish7038720001
    RIDLEY, Glyn
    The Whitehouse 51 Loughborough Road
    Hathern
    LE12 5HY Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    The Whitehouse 51 Loughborough Road
    Hathern
    LE12 5HY Loughborough
    Leicestershire
    British12259200001

    BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Continuing unconditional guarantee created outside the united kingdom and comprising property situated outside the united kingdom
    Creato il 14 feb 1994
    Consegnato il 05 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cardinal eg saws corporation to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All property, assets, rights and interest of the company of any kind or description. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lake Shore National Bank
    Transazioni
    • 05 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 apr 1992
    Consegnato il 28 apr 1992
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital etc.. (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 nov 1987
    Consegnato il 21 nov 1987
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property at unit 6 london road biggleswade bedfordshire title no bd 121032.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 dic 1985
    Consegnato il 17 dic 1985
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece of land near to park road ratby, leicestershire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 ott 1982
    Consegnato il 21 ott 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands and premises being land and buildings on the north west side of and on the south east side of park road ratby leicester title no. Lt 118592.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge over all book debts
    Creato il 12 lug 1982
    Consegnato il 14 lug 1982
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts and other debts owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
      • Numero di pratica 2
    Mortgage
    Creato il 23 apr 1980
    Consegnato il 13 mag 1980
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H lands and premises being precision works worthing road sheffield together with all fixtures etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 22 gen 1980
    Consegnato il 22 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands and premises being 388A moonwood road leeds together with all fixtures etc title no yk 910.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 nov 1979
    Consegnato il 18 dic 1979
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land & premises:- box ives mill wheetley, halifax, west yorks, together with fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1979Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 12 mag 1976
    Consegnato il 20 mag 1976
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory premises at hellaby industrial estate hellaby rotherham together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1976Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 30 apr 1976
    Consegnato il 11 mag 1976
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the (see doc 210). undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 02 feb 2002Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 22 dic 2003Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
    • 16 dic 2006Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1

    BROOKE INDUSTRIAL HOLDINGS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 apr 1976Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    William Scott Martin
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Praticante
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Charles Graham John King
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    2
    DataTipo
    12 lug 1982Data dello strumento
    Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Hunter Kelly
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    P O Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    William Scott Martin
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Praticante
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Charles Graham John King
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds
    Praticante
    Ernst & Young
    Po Box 61
    LS1 2JN Cloth Hall Court
    14 King Street Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0