RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED

RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRALEIGH INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00078153
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TI RALEIGH (INTERNATIONAL) LIMITED31 dic 197731 dic 1977
    RALEIGH INDUSTRIES (INTERNATIONAL) LIMITED17 lug 190317 lug 1903

    Quali sono gli ultimi bilanci di RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Adam Joseph Stubbins come segretario in data 01 mar 2024

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Nomina di Mr Adam Joseph Stubbins come segretario in data 24 nov 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stuart Atkins come segretario in data 24 nov 2023

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Lee Stephen Kidger come amministratore in data 04 ago 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Philippa Wibberley come amministratore in data 04 ago 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Accell Global Bv come amministratore in data 20 giu 2023

    2 pagineAP02

    Cessazione della carica di Anthonie Hilbert Anbeek come amministratore in data 20 giu 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee Kidger il 01 feb 2023

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 23 nov 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2019, non revisionato

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Lee Kidger come amministratore in data 01 lug 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philippa Wibberley come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WIBBERLEY, Philippa
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish203202500001
    ACCELL GLOBAL BV
    Industrieweg
    8444ar Heerenveen
    4
    Netherlands
    Amministratore
    Industrieweg
    8444ar Heerenveen
    4
    Netherlands
    Forma giuridicaBESLOTEN VENNOOTSCHAP
    Tipo di documento di identificazioneAltra persona giuridica o impresa
    Autorità legaleDUTCH CIVIL CODE
    Numero di registrazione857984081
    310707160001
    ATKINS, Stuart
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    196324330001
    BIRD, Catherine Anne
    29 Hall Croft
    NG9 1EL Beeston
    Nottingham
    Segretario
    29 Hall Croft
    NG9 1EL Beeston
    Nottingham
    British95128680001
    BOOTH, Lyne
    22 Milton Road
    DE7 8NU Ilkeston
    Derbyshire
    Segretario
    22 Milton Road
    DE7 8NU Ilkeston
    Derbyshire
    British74497280001
    CHOLERTON, Hugh Nevil
    48 Burnside Drive
    Bramcote Hills
    NG9 3EE Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    48 Burnside Drive
    Bramcote Hills
    NG9 3EE Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803710001
    FATKIN, David Anthony
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British49698200001
    GODDARD, Simon John
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    British9733060001
    GOULDTHORP, Mark Aidan
    10 Olive Grove
    Burton Joyce
    NG14 5FG Nottingham
    Segretario
    10 Olive Grove
    Burton Joyce
    NG14 5FG Nottingham
    British78952750002
    GRAHAM, Alan Norman
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    170918330001
    STUBBINS, Adam Joseph
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    316366040001
    TESSYMAN, Keith Francis
    18 Oak Tree Drive
    Gedling
    NG4 4DA Nottingham
    Segretario
    18 Oak Tree Drive
    Gedling
    NG4 4DA Nottingham
    British24873820001
    WALKER, Timothy
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803780003
    ANBEEK, Anthonie Hilbert
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch245587790001
    BLOK, Jeroen Maria Snijders
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch180302150001
    DARNTON, Phillip Leyland
    75 Limerston Street
    SW10 0BL London
    Amministratore
    75 Limerston Street
    SW10 0BL London
    United KingdomBritish48864380001
    FATKIN, David Anthony
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Fairways Sycamore Lane
    Bleasby
    NG14 7GJ Nottingham
    Nottinghamshire
    British49698200001
    FEENEMA, Gerard Jacob
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch225902350001
    FILS-AIME, Reggie
    8 Gault Avenue
    Westport
    IRISH Connecticut
    Ct 06880
    Usa
    Amministratore
    8 Gault Avenue
    Westport
    IRISH Connecticut
    Ct 06880
    Usa
    American65981880001
    FINDEN-CROFTS, Alan John
    Willowhayne House Tamarisk Way
    Willowhayne Estate East Preston
    BN16 2TE Little Hampton
    West Sussex
    Amministratore
    Willowhayne House Tamarisk Way
    Willowhayne Estate East Preston
    BN16 2TE Little Hampton
    West Sussex
    British1546980003
    GODDARD, Simon John
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    45 Ullswater Crescent
    Bramcote
    NG9 3BE Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish9733060001
    GOULDTHORP, Mark Aidan
    Main Street
    Oxton
    NG25 0SD Southwell
    Carrick House
    Nottinghamshire
    England
    Amministratore
    Main Street
    Oxton
    NG25 0SD Southwell
    Carrick House
    Nottinghamshire
    England
    United KingdomBritish78952750004
    HANCOCK, Michael William
    De Cortenaer
    Biesdelsalaan 1-A2
    FOREIGN 6881 Ca Velp (Gld)
    Netherlands
    Amministratore
    De Cortenaer
    Biesdelsalaan 1-A2
    FOREIGN 6881 Ca Velp (Gld)
    Netherlands
    British17107510001
    HANDLEY, Christopher John
    9 Egerton Road
    Woodthorpe
    NG5 4FF Nottingham
    Nottinghsmshire
    Amministratore
    9 Egerton Road
    Woodthorpe
    NG5 4FF Nottingham
    Nottinghsmshire
    British31694220002
    JONES, Mervyn Bernard
    Oak Tree Court
    Tollerton
    NG12 4HJ Nottingham
    Greenacres
    United Kingdom
    Amministratore
    Oak Tree Court
    Tollerton
    NG12 4HJ Nottingham
    Greenacres
    United Kingdom
    United KingdomEnglish90496990003
    KIDGER, Lee Stephen
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish271948180002
    MACNAUGHTON, John Godfrey
    3 Kingston Hall
    NG11 0DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    3 Kingston Hall
    NG11 0DJ Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish90496950001
    REYNOLDS, Michael John
    24 Main Street
    LE14 4QW Saltby
    Leicestershire
    Amministratore
    24 Main Street
    LE14 4QW Saltby
    Leicestershire
    United KingdomBritish95504810001
    SYBESMA, Hielke Hayo
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch181817310001
    TAKENS, Rene Jan
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    NetherlandsDutch180304610001
    THOMAS, Eric Robert
    252 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AG Nottingham
    Amministratore
    252 Melton Road
    Edwalton
    NG12 4AG Nottingham
    British9733070001
    TODD, Mark James
    2 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    Amministratore
    2 Esk Hause Close
    West Bridgford
    NG2 6SG Nottingham
    British54190140002
    WALKER, Timothy
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Zulla Road
    Mapperley Park
    NG3 5BY Nottingham
    Nottinghamshire
    British8803780003
    WIBBERLEY, Philippa
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish203202500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Raleigh Holdings Ltd
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    136
    England
    06 apr 2016
    Church Street
    Eastwood
    NG16 3HT Nottingham
    136
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione00076181
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RALEIGH INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 28 feb 2013
    Consegnato il 12 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the right title and interest from time to time in under and to all inventory together with all related rights and by way of floating charge all present and future trade receivables and inventory see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abn Amro Bank N.V.
    Transazioni
    • 12 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 feb 2010
    Consegnato il 26 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 22 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security agent) (whether for its own account or as trustee for the secured beneficiaries) or any of the other secured beneficiaries under or pursuant to the finance documents (including the debenture)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital intellectual property rights buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 22 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Subordination agreement
    Creato il 06 mar 1997
    Consegnato il 21 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future liabilities (actual or contingent) payable or owing by derby holding B.V. (the "borrower") to the chargee under or in connection with the senior credit agreement, the subordination agreement, each inter-group guarantee, the fee letter, novation certificate, deed of accession or any other document designated as a finance document by banque nationale de paris (the "agent") and the borrower, (each such document being a "finance document") together with all such sums being referred to as the "senior debt"
    Brevi particolari
    All present and future liabilities of the borrower to the company the "junior debt".
    Persone aventi diritto
    • The "Senior Creditors" as Defined Therein
    Transazioni
    • 21 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 mar 1992
    Consegnato il 04 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 04 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture & guarantee
    Creato il 03 apr 1987
    Consegnato il 23 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company derby international corporation S.A. and/or raleigh ireland limited under or in respect of the "secured liabilities" as defined in the charge.
    Brevi particolari
    For full details see form 395 and continuation sheet relevant to this charge.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank Ireland Limited.
    Transazioni
    • 23 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    A debenture & guarantee
    Creato il 03 apr 1987
    Consegnato il 14 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing all moneys due or to become due from raleigh international limited and/or derby international corporation S.A. and/or raleigh industries limited and/or sturmey-archer limited to the chargee under the terms of two facility letters dated 3RD april '87
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 14 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 26 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0