NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00080028 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ground Floor West One London Road CM14 4QW Brentwood Essex England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 nov 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 01 nov 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 29 mag 2022 al 28 mag 2022 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 mag 2023 al 29 nov 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mag 2022 al 29 mag 2022 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mag 2022 al 30 mag 2022 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 nov 2021 al 31 mag 2022 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Chief Operating Officer Karen Anita Mcewan come amministratore in data 04 mag 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Jonathan Miller come amministratore in data 24 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Indigo Corporate Secretary Limited come segretario in data 14 mar 2022 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Peat come segretario in data 14 mar 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 nov 2020 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Martin Mccoll Limited come persona con controllo significativo il 09 dic 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP United Kingdom a Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QW in data 09 dic 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 24 nov 2019 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Mccoll's House Ashwells Road Brentwood Essex CM15 9st a Ground Floor West One London Road Brentwood Essex CM14 4QP in data 10 set 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Giles Matthew Oliver David come amministratore in data 09 lug 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIGO CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Rectory Grove SS9 2HL Leigh On Sea Monometer House Essex United Kingdom |
| 281695990002 | ||||||||||
| BUTLER, Stuart Clive | Amministratore | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | 127794710001 | |||||||||
| DAVID, Giles Matthew Oliver | Amministratore | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | 187907210001 | |||||||||
| MCEWAN, Karen Anita | Amministratore | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | 272054760001 | |||||||||
| BARNES, Christopher Howard | Segretario | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||||||
| GOSNELL, Michael James | Segretario | The Birches 1 Lowfield Close GU18 5QT Lightwater Surrey | British | 10496160001 | ||||||||||
| MILLER, Simon Jonathan | Segretario | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 88269280005 | ||||||||||
| PEAT, Rachel | Segretario | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | 256013730001 | |||||||||||
| TAYLOR, Philip John Graham | Segretario | Cherry Tree House 19 Hill Road GU27 2JN Haslemere Surrey | British | 10082610001 | ||||||||||
| TEDDER, Kingsley John | Segretario | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 101631010002 | ||||||||||
| YOUNG, Bernadette Clare | Segretario | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | 237935070001 | |||||||||||
| AGUSS, Martyn James | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 107991420002 | |||||||||
| BELL, Robbie Ian | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 97384120002 | |||||||||
| COX, Allister Russell | Amministratore | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | 31500810002 | |||||||||
| CULLENS, Alan | Amministratore | 4 Alexandra House Queens Hill Lodge SL5 7EQ Ascot Berkshire | United Kingdom | British | 6875310002 | |||||||||
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 181763320002 | |||||||||
| GREEN, Steven | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 209349290001 | |||||||||
| HANNA, Robert Houston | Amministratore | Cherry Garth Stokesheath Road Oxshott KT22 0PS Leatherhead Surrey | British | 10082620001 | ||||||||||
| LANCASTER, James | Amministratore | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 147052660001 | |||||||||
| MILLER, Simon Jonathan | Amministratore | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex England | England | British | 88269280005 | |||||||||
| TAYLOR, Philip John Graham | Amministratore | Cherry Tree House 19 Hill Road GU27 2JN Haslemere Surrey | British | 10082610001 | ||||||||||
| WILKINSON, Stephen William | Amministratore | Martin Mccoll House Ashwells Road, CM15 9ST Pilgrims Hatch, Brentwood Essex | United Kingdom | British | 101631100002 | |||||||||
| WOOLHOUSE, Anthony Peter | Amministratore | Wellbourne Vicarage Hill GU9 8HG Farnham Surrey | British | 10496200001 | ||||||||||
| WYATT, Peter Robert Michael | Amministratore | Frogs Close Clayford Lane TA22 9RH Dulverton West Somerset | British | 10082630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Mccoll Limited | 06 apr 2016 | One London Road CM14 4QW Brentwood Ground Floor West Essex United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NSS NEWSAGENTS RETAIL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 28 nov 1998 Consegnato il 08 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 31 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement | Creato il 08 lug 1965 Consegnato il 28 lug 1965 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito See increase of 450 per annum on the rack rent payable and due from the company to the chargee under the terms of a lease dt 18TH december 1957. | |
Brevi particolari 17 atilgate parade tilgate crawley in the county of sussex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0