COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)

COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00088079
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    Indirizzo della sede legale
    2 Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Dissolution by c/order effective 30/12/2015 manual gazette issued.
    1 pagineMISC

    Ordinanza giudiziaria

    Dis by c/order 30/12/15 man gaz
    5 pagineOC

    Gazzetta ufficiale finale sciolta per decreto

    pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Steven Roger Western il 30 nov 2015

    2 pagineCH01

    Ridenominazione delle azioni. Stato del capitale 08 set 2015

    • Capitale: USD 27,000,000
    4 pagineSH14

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2015

    Stato del capitale al 12 mag 2015

    • Capitale: GBP 18,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 30 dic 2014

    21 pagineAA

    Nomina di Patrick Cogavin come amministratore in data 09 set 2014

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Theo Wilkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mag 2014

    Stato del capitale al 16 mag 2014

    • Capitale: GBP 18,000,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    21 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Theo James Rickus Wilkes come amministratore

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Gareth Nokes come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Clive Paul Thomas il 05 lug 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Steven Roger Western come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Thomas Nichols come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    34 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEXTALL, Siobhan
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Segretario
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    146390320001
    COGAVIN, Patrick Eamon
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    Avaya House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish191149500001
    THOMAS, Clive Paul
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    United KingdomBritish170854570001
    TURNER, Alan John
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    United KingdomBritish103211340004
    WESTERN, Steven Roger
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    EnglandBritish98436900002
    PEECOCK, Bernard Joseph
    Fir Tree Road
    KT17 3LF Epsom Downs
    279
    Surrey
    Segretario
    Fir Tree Road
    KT17 3LF Epsom Downs
    279
    Surrey
    British129499980001
    YOUNG, Peter Victor
    37 Monks Drive
    W3 0EB London
    Segretario
    37 Monks Drive
    W3 0EB London
    British8447460001
    MILTON AVIS BUSINESS SERVICES LLP
    Datam House
    48 Maddox Street
    W1S 1QB London
    Segretario
    Datam House
    48 Maddox Street
    W1S 1QB London
    100670330001
    BARFOD, Anne Mette
    Inageniorvaenget
    DK 3520 Farum
    60
    Denmark
    Amministratore
    Inageniorvaenget
    DK 3520 Farum
    60
    Denmark
    Danish80262470004
    BARFOD, Anne Mette
    Odderbjegvej 2
    Smorum
    2765
    Denmark
    Amministratore
    Odderbjegvej 2
    Smorum
    2765
    Denmark
    Danish80262470001
    BOE MORTENSEN, Soren
    5 Vildbjergvej
    Slangerup Dk3550
    FOREIGN Denmark
    Amministratore
    5 Vildbjergvej
    Slangerup Dk3550
    FOREIGN Denmark
    Danish41188310002
    CONSTANTI, Doros George
    87 Vera Avenue
    Grange Park
    N21 1RN London
    Amministratore
    87 Vera Avenue
    Grange Park
    N21 1RN London
    British93161870002
    CORINTH-HANSEN, Leif
    Alsikemarken 29
    2860 Soeborg
    Denmark
    Amministratore
    Alsikemarken 29
    2860 Soeborg
    Denmark
    Danish64587420001
    DALLY, Rebecca Rosa
    The Old Chapel
    Byfleets Lane, Warnham
    RH12 3PD Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    The Old Chapel
    Byfleets Lane, Warnham
    RH12 3PD Horsham
    West Sussex
    British109314710001
    DENNING, Charles Henry David
    Bewl Bridge Farm
    TN3 8JJ Lamberhurst
    Kent
    Amministratore
    Bewl Bridge Farm
    TN3 8JJ Lamberhurst
    Kent
    British67471000001
    GRAY, Stephen John Ogilvie
    Running Tide
    Smugglers Lane
    PO18 8QP Bosham
    West Sussex
    Amministratore
    Running Tide
    Smugglers Lane
    PO18 8QP Bosham
    West Sussex
    British58434770001
    HORNSBERG, Jan
    Mosegaardsvej 25e
    Gentofte
    Dk 2820
    Amministratore
    Mosegaardsvej 25e
    Gentofte
    Dk 2820
    Danish62270640001
    JERVING, Peter Werner
    106 Gassehaven
    Dk - 2840 Holte
    FOREIGN
    Denmark
    Amministratore
    106 Gassehaven
    Dk - 2840 Holte
    FOREIGN
    Denmark
    Danish12574190001
    JOHNSTON, Robert Keith
    88 Grove Park Road
    SE9 4QB London
    Amministratore
    88 Grove Park Road
    SE9 4QB London
    British52493860001
    KARAFOULIDIS, Michail
    Flat B + C
    229 Ladbroke Grove
    W10 6HG London
    Amministratore
    Flat B + C
    229 Ladbroke Grove
    W10 6HG London
    EnglandBritish/Greek120125580001
    KNIE-ANDERSEN, Bent
    Holmegaardsvej 36
    FOREIGN Dk - 2920 Charlottenlund
    Denmark
    Amministratore
    Holmegaardsvej 36
    FOREIGN Dk - 2920 Charlottenlund
    Denmark
    Danish8447480001
    MACKENZIE, Duncan Stewart
    The Old Police Station Ferry Road
    KT7 0XZ Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Old Police Station Ferry Road
    KT7 0XZ Thames Ditton
    Surrey
    British44221170001
    NICHOLS, Thomas James
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    EnglandBritish129335930001
    NOKES, Gareth Howard John
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    EnglandEnglish141023860001
    PETZOLD, Matthew Andrew
    The Forge Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    Amministratore
    The Forge Roundhurst
    GU27 3BN Haslemere
    Surrey
    United KingdomBritish15738490002
    POTTER, Grahame John
    18 Hillway
    Highgate
    N6 6QA London
    Amministratore
    18 Hillway
    Highgate
    N6 6QA London
    British8447500001
    POULSEN, Claus
    Mikkelborg Alle 15
    2980 Kokkedal
    FOREIGN 2980 Denmark
    Amministratore
    Mikkelborg Alle 15
    2980 Kokkedal
    FOREIGN 2980 Denmark
    Danish36188870001
    STOKHOLM, Jesper Rosenberg, Vive-Chairman
    Vedbak Strandvej 486
    2950 Vedbak
    Denmark
    Amministratore
    Vedbak Strandvej 486
    2950 Vedbak
    Denmark
    Danish55075480001
    THOMPSON, David Anthony
    1453 London Road
    SS9 1SB Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    1453 London Road
    SS9 1SB Leigh On Sea
    Essex
    British44221140002
    THORSEN, Mark Jakob
    19 Tjornebakken
    Copenhagen
    Denmark
    Amministratore
    19 Tjornebakken
    Copenhagen
    Denmark
    Danish41188160001
    WILKES, Theo James Rickus
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    Amministratore
    Avaya House
    Cathedral Hill
    GU2 7YL Guildford
    2
    Surrey
    England
    United KingdomBritish172126980001
    WITT, Frans Henrik
    157 Ordrup Jagvej
    Charlottenlund
    Dk-2920
    Denmark
    Amministratore
    157 Ordrup Jagvej
    Charlottenlund
    Dk-2920
    Denmark
    Danish80018950001

    COPENHAGEN REINSURANCE COMPANY (U.K.) LIMITED(THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 25 nov 1991
    Consegnato il 02 dic 1991
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of any agreement on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the chargor's rights, title and interest an and to all securities which are held by, to the order, for the account or under the control or direction of the bank (see 395 for full details of charge).
    Persone aventi diritto
    • Citibank, N.A.
    Transazioni
    • 02 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deposit charge
    Creato il 20 feb 1990
    Consegnato il 05 mar 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the crdit agreement dated 20/2/90
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the right, title nad interest of the company (see 395 ref M27 or full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    A rein insurance deposit agreement.
    Creato il 09 nov 1989
    Consegnato il 24 nov 1989
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever uncer the terms of the charge
    Brevi particolari
    All monies at the date of the reinsurance deposit agreement or at any time thereafter during the rulesistance of the security constitutes by the reinsurance deposited. (See 395 ref 7 for full details). Floating charge on securities deposited with the bank or its agents and rights and benefits arising therefrom.
    Persone aventi diritto
    • Citibank, N.A.
    • Bank of Montreal.
    Transazioni
    • 24 nov 1989Registrazione di un'ipoteca
    Charge all the clubs property both present & future including its uncalled capital for the time being.
    Creato il 01 ott 1984
    Consegnato il 18 ott 1984
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums standing in the the account at the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank Na
    Transazioni
    • 18 ott 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0