GAUCHO GRILL LIMITED

GAUCHO GRILL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGAUCHO GRILL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00093289
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GAUCHO GRILL LIMITED?

    • Ristoranti con licenza (56101) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova GAUCHO GRILL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Four Brindley Place
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GAUCHO GRILL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GAUCHO GRILL PLC27 apr 200127 apr 2001
    GIOMA RESTAURANTS PLC21 lug 199821 lug 1998
    PARAMBE P.L.C.08 mag 190708 mag 1907

    Quali sono gli ultimi bilanci di GAUCHO GRILL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per GAUCHO GRILL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    18 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    17 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    31 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    31 pagineAM03

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    9 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Fourth Floor 7-9 Swallow Street London W1B 4DE a Four Brindley Place Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 02 ago 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 000932890016 in pieno

    1 pagineMR04

    Memorandum e Statuto

    13 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Documents/facilities agreement/company business 15/06/2018
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 000932890019, creata il 18 giu 2018

    18 pagineMR01

    Nomina di Mr Oliver James Meakin come amministratore in data 29 gen 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Paul Mason come amministratore in data 09 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Zeev Godik come amministratore in data 09 nov 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 lug 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Seconda presentazione per la cessazione di Gary Mann come amministratore

    5 pagineRP04TM01

    Seconda presentazione per la cessazione di Gary Mann come segretario

    5 pagineRP04TM02

    Nomina di Mr Frank Bandura come amministratore in data 24 feb 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gary Mann come amministratore in data 24 feb 2017

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    03 apr 2017Clarification A second filed TM01 was registered on 03/04/2017.

    Nomina di Mr Frank Bandura come segretario in data 24 feb 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gary Mann come segretario in data 24 feb 2017

    2 pagineTM02
    Note
    DataNota
    03 apr 2017Clarification A second filed TM02 was registered on 03/04/2017.

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GAUCHO GRILL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BANDURA, Frank
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Segretario
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    226381610001
    BANDURA, Frank
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Amministratore
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    EnglandBritish70536440002
    MASON, Paul
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Amministratore
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    United KingdomBritish141310720001
    MEAKIN, Oliver James
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    Amministratore
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four Brindley Place
    EnglandBritish126343920001
    COULTHARD, Simon David
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    Segretario
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    British97883290001
    JOHAL, Manjinder
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    Segretario
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    British80892350001
    MANN, Gary
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Segretario
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    182802060001
    MCLEAN, Charles Robert William
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Segretario
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    British102833990002
    VAN TONGEREN, Steven
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Segretario
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Dutch60695810002
    CANTRADE INVESTMENTS LIMITED
    4 Chiswell Street
    Finsbury Square
    EC1Y 4UP London
    Segretario
    4 Chiswell Street
    Finsbury Square
    EC1Y 4UP London
    4852550003
    COULTHARD, Simon David
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    Amministratore
    25 Downs Road
    EN1 1PB Enfield
    British97883290001
    DAVENPORT, David Talbot Henry
    Rectory Park
    TN12 8EH Horsmonden
    Kent
    Amministratore
    Rectory Park
    TN12 8EH Horsmonden
    Kent
    British8945080001
    DAY, Richard Anthony Bingley
    Church Farmhouse Church Road
    Stambourne
    CO9 4NR Halstead
    Essex
    Amministratore
    Church Farmhouse Church Road
    Stambourne
    CO9 4NR Halstead
    Essex
    EnglandBritish14473230003
    GEENEMANS, Siewert Jan
    Wite Singel 33
    Leiden
    Nl 2311
    The Netherlands
    Amministratore
    Wite Singel 33
    Leiden
    Nl 2311
    The Netherlands
    Dutch71831900002
    GODIK, Zeev
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Amministratore
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    EnglandDutch78064190005
    HORLICK, Nicola Karina Christina
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Amministratore
    30 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    British53458480002
    JOHAL, Manjinder
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    Amministratore
    7 Danes Court
    1 Saint Edmunds Terrace
    NW8 7QR London
    British80892350001
    LEWIS, Leonard Richard
    Ridge End House Marlow Common
    SL7 2QS Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ridge End House Marlow Common
    SL7 2QS Marlow
    Buckinghamshire
    British35093260001
    MANN, Gary
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    Amministratore
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor 7-9
    EnglandBritish182641140001
    MCLEAN, Charles Robert William
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    Amministratore
    2 Lilyfields Chase
    Ewhurst
    GU6 7RX Cranleigh
    EnglandBritish102833990002
    RITCHIE, David Cowan
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    48 Dick Place
    EH9 2JB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish26865440001
    ROWLATT, James Arthur
    Cut Mill Cottage
    Hinton St Mary
    DT10 1NA Sturminster Newton
    Dorset
    Amministratore
    Cut Mill Cottage
    Hinton St Mary
    DT10 1NA Sturminster Newton
    Dorset
    British36257720001
    STOREY, Donald
    105 Cambridge Gardens
    W10 6JE London
    Amministratore
    105 Cambridge Gardens
    W10 6JE London
    British111399690001
    VAN TONGEREN, Steven
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Amministratore
    64 Buckingham Gate
    Flat 4
    SW1E 6AR London
    Dutch60695810002

    Chi sono le persone con controllo significativo di GAUCHO GRILL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Malbec Bidco Limited
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor, 7-9
    England
    06 apr 2016
    Swallow Street
    W1B 4DE London
    Fourth Floor, 7-9
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneRegistrar Of Companies For England And Wales
    Numero di registrazione06451551
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    GAUCHO GRILL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 giu 2018
    Consegnato il 21 giu 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All current and future material land (except for any floating charge leasehold property) and intellectual property (except for any floating charge intellectual property) and the specified intellectual property owned by the company, in each case as specified (and defined) in the deed of accession and charge registered by this form MR01 and including, amongst others, trademarks numbered 2574715 and 2527499. for more details please refer to the deed of accession and charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 21 giu 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 apr 2016
    Consegnato il 22 apr 2016
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 22 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 feb 2016
    Consegnato il 23 feb 2016
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 mag 2014
    Consegnato il 28 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Cau.reg no.2527499 Reg on 1 october 2009 class 43:. gaucho.reg no.2427464 Reg on 18 july 2006 class 43:. gaucho.reg no.2550529 Reg on 14 july 2006 class 43:. gaucho.reg no.2574715 Reg on 10 march 2011 class 41:.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 09 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental agreement
    Creato il 25 ago 2010
    Consegnato il 02 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A security interest in the totality of shares it holds in gaucho lebanon sarl, together with any and all rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A pledge of shares agreement
    Creato il 18 ago 2010
    Consegnato il 26 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    As security for the prompt and complete payment of the secured liabilities pledged and granted a security interest in the totality of shares it holds in gaucho lebanon sarl together with any and all rights attached see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 26 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Creato il 20 dic 2007
    Consegnato il 29 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the pledgor or the company or both as obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The present shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 29 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2007
    Consegnato il 19 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement for the pledge of shares
    Creato il 03 ago 2006
    Consegnato il 18 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its shares and share rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation as Agent of and Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 18 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A supplemental deed to a debenture dated 2 august 2006
    Creato il 02 ago 2006
    Consegnato il 15 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any obligor to the finance parties (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever and all other monies due or to become due from any charging company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent of and Trustee for the Other Finance Parties (Thetrustee)
    Transazioni
    • 15 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of intellectual property rights
    Creato il 17 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first ranking right of pledge over all ip rights and to the extent it concerns future ip rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge of shares
    Creato il 17 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledgor has granted to the pledgee a first ranking right of pledge over the shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 gen 2005
    Consegnato il 29 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 29 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2002
    Consegnato il 23 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 02 dic 1985
    Consegnato il 09 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from parambe collection limited and ceycon securirties limited to the chargee. On any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & the Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 apr 1913
    Consegnato il 05 apr 1913
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £400
    Brevi particolari
    Undertaking, property and assets, present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Mrs E. Blair
    Transazioni
    • 05 apr 1913Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 06 ago 1909
    Consegnato il 06 ago 1909
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • No Trustees
    Transazioni
    • 06 ago 1909Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 27 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 09 nov 1908
    Consegnato il 09 nov 1908
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • No Trustees
    Transazioni
    • 09 nov 1908Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 27 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 08 set 1908
    Consegnato il 08 set 1908
    Soddisfatta integralmente
    Brevi particolari
    The company's undertaking, stock in trade, goodwill, book debts and all other property present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • No Trustees
    Transazioni
    • 08 set 1908Registrazione di un onere per garantire una serie di obbligazioni (397)
    • 27 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GAUCHO GRILL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 lug 2018Inizio dell'amministrazione
    31 lug 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert James Harding
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Matthew David Smith
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0