PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED
Panoramica
Nome della società | PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00095855 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
PUNCH RETAILING (WILLOW) LIMITED | 23 set 1999 | 23 set 1999 |
ALLIED DOMECQ RETAILING (WILLOW) LIMITED | 12 nov 1996 | 12 nov 1996 |
WREXHAM LAGER BREWERY COMPANY LIMITED | 07 mar 1988 | 07 mar 1988 |
WREXHAM LAGER BEER COMPANY LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
INNES SMITH,AND COMPANY LIMITED | 28 nov 1907 | 28 nov 1907 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 17 gen 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 79 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Punch Taverns (Dc) Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE in data 08 set 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Peter Dando come amministratore in data 29 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Forde come amministratore in data 29 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francesca Appleby come segretario in data 29 ago 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Edward Michael Bashforth come amministratore in data 29 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher John Moore come amministratore in data 29 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOORE, Christopher John | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136853310001 | ||||
MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | England | British | Director | 112375050001 | ||||
PATERSON, Sean Michael | Amministratore | South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Broadway Park Scotland | Scotland | British | Finance Director | 257892140001 | ||||
APPLEBY, Francesca | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191629580001 | |||||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Segretario | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | 637110001 | ||||||
GUTHRIE, Harold Alexander | Segretario | 61 The Lea ST4 8DY Stoke On Trent Staffordshire | British | 28998620001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175490300001 | |||||||
RUDD, Susan Clare | Segretario | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Segretario | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | British | 117216940001 | ||||||
TYRRELL, Helen | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161809240001 | |||||||
BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor | Amministratore | 13 Harbury Street DE13 0RX Burton On Trent Staffordshire | British | Secretary | 637110001 | |||||
CARTLIDGE, Henry | Amministratore | 4 Woodhouse Lane Woodhouse Meadow Priorslee TF2 9SX Telford Shropshire | British | Company Director | 33545670001 | |||||
CONSTANTINE, Peter Anthony | Amministratore | 83 South Rise CF14 0RG Cardiff South Glamorgan | Wales | British | Chartered Surveyor Estates Dir | 114160540001 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 152083750001 | ||||
DAVIS, Alan | Amministratore | 4 Ashley Court Ashby Road DE15 0LL Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 15364140001 | |||||
DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
ELKIN, William Irwin | Amministratore | Tudor Lodge Heritage Walk SY13 1JF Whitchurch Salop | British | Production & Dist Director | 28998630003 | |||||
FORDE, David | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | Director | 180590780001 | ||||
GUTHRIE, Harold Alexander | Amministratore | 61 The Lea ST4 8DY Stoke On Trent Staffordshire | British | Company Director | 28998620001 | |||||
JONES, Bruce Abbott | Amministratore | 1 Hall Drive DE13 8TF Hanbury Staffordshire | British | Company Director | 29595900002 | |||||
KEMP, Deborah Jane | Amministratore | 6 Station Road Hampton In Arden B92 0BJ Solihull | United Kingdom | British | Director | 79388130005 | ||||
KERSHAW, Harry | Amministratore | 5 Codham Close The Ithens Sontley Road LL13 7DZ Wrexham Clwyd | British | Company Director | 22215920001 | |||||
MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
MCLOUGHLIN, Kevin Thomas | Amministratore | Monkhide Tallarn Green SY14 7LJ Malpas Cheshire | British | Head Brewer | 51153090002 | |||||
PENDLETON, Harry | Amministratore | Ashcroft Woodlands Close Thorpe DE6 2AP Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 54398070001 | |||||
PRESTON, Neil David | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
STEVENSON, David Robert | Amministratore | 3 Tweentown Donington Le Heath LE67 2GG Coalville Leicestershire | British | Accountant | 40472950001 | |||||
TANNAHILL, David James | Amministratore | 3-4 Broadway Park EH12 9JZ Edinburgh Heineken Uk Limited United Kingdom | Scotland | British | Director | 237381690001 | ||||
WEBSTER, Ronald Edward | Amministratore | Oakmere Murieston Road Hale WA15 9SU Altrincham Cheshire | British | Packaging/Distribution Mng | 54398110001 | |||||
WILKINSON, Anthony Eric | Amministratore | Bupton Grange Longford Lane Longford DE6 3DT Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 4656080002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Uk Limited | 29 ago 2017 | Broadway Park South Gyle Broadway EH12 9JZ Edinburgh 3-4 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Punch Taverns (Dc) Holdings Limited | 06 apr 2016 | 20-22 Great Titchfield Street W1W 8BE London Elsley Court United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari A charge by way of first legal mortgage all of the company's right title interest and benefit present and future in to and under the freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge and all estates or interests in such property and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such freehold or leasehold property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 22 apr 2002 Consegnato il 08 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge | Creato il 28 giu 2000 Consegnato il 15 lug 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein) | |
Brevi particolari All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0