PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED

PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00095855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PUNCH RETAILING (WILLOW) LIMITED23 set 199923 set 1999
    ALLIED DOMECQ RETAILING (WILLOW) LIMITED12 nov 199612 nov 1996
    WREXHAM LAGER BREWERY COMPANY LIMITED07 mar 198807 mar 1988
    WREXHAM LAGER BEER COMPANY LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    INNES SMITH,AND COMPANY LIMITED 28 nov 190728 nov 1907

    Quali sono gli ultimi bilanci di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di David Forde come amministratore in data 31 lug 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 gen 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    79 paginePARENT_ACC

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Sean Michael Paterson come amministratore in data 24 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David James Tannahill come amministratore in data 24 apr 2019

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 24 ago 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 19 ago 2017

    3 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Punch Taverns (Dc) Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 set 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF a Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BE in data 08 set 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stephen Peter Dando come amministratore in data 29 ago 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Forde come amministratore in data 29 ago 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Francesca Appleby come segretario in data 29 ago 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Edward Michael Bashforth come amministratore in data 29 ago 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher John Moore come amministratore in data 29 ago 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    Amministratore
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritishFinance Director257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191629580001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    GUTHRIE, Harold Alexander
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    British28998620001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175490300001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161809240001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishSecretary637110001
    CARTLIDGE, Henry
    4 Woodhouse Lane
    Woodhouse Meadow Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Shropshire
    Amministratore
    4 Woodhouse Lane
    Woodhouse Meadow Priorslee
    TF2 9SX Telford
    Shropshire
    BritishCompany Director33545670001
    CONSTANTINE, Peter Anthony
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritishChartered Surveyor Estates Dir114160540001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DAVIS, Alan
    4 Ashley Court
    Ashby Road
    DE15 0LL Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    4 Ashley Court
    Ashby Road
    DE15 0LL Burton On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director15364140001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    ELKIN, William Irwin
    Tudor Lodge Heritage Walk
    SY13 1JF Whitchurch
    Salop
    Amministratore
    Tudor Lodge Heritage Walk
    SY13 1JF Whitchurch
    Salop
    BritishProduction & Dist Director28998630003
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrishDirector180590780001
    GUTHRIE, Harold Alexander
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    61 The Lea
    ST4 8DY Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishCompany Director28998620001
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    Amministratore
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    BritishCompany Director29595900002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    Amministratore
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritishDirector79388130005
    KERSHAW, Harry
    5 Codham Close
    The Ithens Sontley Road
    LL13 7DZ Wrexham
    Clwyd
    Amministratore
    5 Codham Close
    The Ithens Sontley Road
    LL13 7DZ Wrexham
    Clwyd
    BritishCompany Director22215920001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MCLOUGHLIN, Kevin Thomas
    Monkhide
    Tallarn Green
    SY14 7LJ Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    Monkhide
    Tallarn Green
    SY14 7LJ Malpas
    Cheshire
    BritishHead Brewer51153090002
    PENDLETON, Harry
    Ashcroft Woodlands Close
    Thorpe
    DE6 2AP Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Ashcroft Woodlands Close
    Thorpe
    DE6 2AP Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director54398070001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    STEVENSON, David Robert
    3 Tweentown
    Donington Le Heath
    LE67 2GG Coalville
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Tweentown
    Donington Le Heath
    LE67 2GG Coalville
    Leicestershire
    BritishAccountant40472950001
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritishDirector237381690001
    WEBSTER, Ronald Edward
    Oakmere Murieston Road
    Hale
    WA15 9SU Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Oakmere Murieston Road
    Hale
    WA15 9SU Altrincham
    Cheshire
    BritishPackaging/Distribution Mng54398110001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    BritishCompany Director4656080002

    Chi sono le persone con controllo significativo di PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    29 ago 2017
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    No
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleUnited Kingdom (Scotland)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc065527
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Punch Taverns (Dc) Holdings Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    06 apr 2016
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PUNCH TAVERNS (WILLOW) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 22 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A charge by way of first legal mortgage all of the company's right title interest and benefit present and future in to and under the freehold or leasehold property comprising the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge and all estates or interests in such property and all buildings trade and other fixtures fixed plant and machinery from time to time on such freehold or leasehold property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited as Trustee for the Spirit Secured Parties
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 22 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 14 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 28 giu 2000
    Consegnato il 15 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein)
    Brevi particolari
    All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited (For Itself and on Behalf of the Pr Secured Parties) "the Security Trustee" (as Defined Therein)
    Transazioni
    • 15 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 gen 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0