MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00100620 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
- (7499) /
Dove si trova MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Aurum House 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MAPPIN & WEBB LIMITED | 10 dic 1908 | 10 dic 1908 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 lug 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 01 feb 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Edwin Gerrard il 05 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Paul David Stead il 05 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Clive Sargent il 05 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Broderick il 05 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Gillian Oliff il 05 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 03 feb 2008 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 5 pagine | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288b | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 gen 2007 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 288a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLIFF, Gillian | Segretario | 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester Aurum House | British | 128108960001 | ||||||
| BRODERICK, Anthony John | Amministratore | 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester Aurum House | England | British | 98431500001 | |||||
| GERRARD, Richard Edwin | Amministratore | 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester Aurum House | England | British | 124068680001 | |||||
| SARGENT, Stephen Clive | Amministratore | 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester Aurum House | England | British | 16905350005 | |||||
| STEAD, Justin Paul David | Amministratore | 2 Elland Road Braunstone LE3 1TT Leicester Aurum House | England | Australian | 116638810003 | |||||
| FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| FISHER, Mark | Segretario | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GREGG, Terence Michael | Segretario | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| HARRINGTON, Nicholas Joseph | Segretario | 9 Kingsmead Avenue KT4 8XB Worcester Park Surrey | British | 1273670001 | ||||||
| LOBB, Andrew Mark | Segretario | 33 Lyndhurst Avenue NW7 2AD London | British | 74760630002 | ||||||
| PAGE, Elizabeth | Segretario | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
| REID, Michael John | Segretario | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| RIVERS, Paul Edward | Segretario | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | British | 62321110002 | ||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Amministratore | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | 55757700003 | |||||
| ASPREY, John Rolls | Amministratore | 166 New Bond Street W1Y 0AR London | United Kingdom | British | 68034280002 | |||||
| ATTALLAH, Naim Ibrahim | Amministratore | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | 25646240001 | |||||
| BERKMEN, Gillian | Amministratore | Orchard View 27 Woodhill Avenue SL9 8DP Gerrards Cross South Buckinghamshire | Gb | British | 92154270001 | |||||
| BROWN, Andrew Saville | Amministratore | 123 Edenfield Gardens KT4 7DX Worcester Park Surrey | United Kingdom | British | 69874610002 | |||||
| COOPER, Caroline | Amministratore | 222 Caraway 2 Cayenne Court 32 Shad Thames SE1 2PP London | British | 92733900001 | ||||||
| DAHL, Ian Xavier | Amministratore | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | 66486140001 | ||||||
| EVANS, Nicholas David | Amministratore | 6 Raddington Road W10 5TF London | United Kingdom | British | 57490310002 | |||||
| FISHER, Mark | Amministratore | The Cottage London Road SG8 9LT Royston Hertfordshire | British | 61931900002 | ||||||
| GREEN, Edward Maurice | Amministratore | 82 Portland Place W1N 3DH London | British | 47989150001 | ||||||
| GREGG, Terence Michael | Amministratore | 6 Chilterns End Close RG9 1SQ Henley On Thames Oxfordshire | British | 64357220001 | ||||||
| LOWDEN, David Soutar | Amministratore | The Squirrels Riversdale SL8 5EB Bourne End Buckinghamshire | England | British | 54836190001 | |||||
| MCCLOSKEY, Ciaran | Amministratore | Whitehouse Farm PE12 0HE Sutton St James Lincolnshire | British | 88312080001 | ||||||
| PIASECKI, Jerzy Stanislaw | Amministratore | Mill Lane Lower Shiplake RG9 3ND Henley On Thames Lockend House Oxon | England | British | 129561330001 | |||||
| PILKINGTON, Judith Mary | Amministratore | 43 The Nautilus Building 3 Myddleton Passage EC1R 1XW London | United Kingdom | British | 106791670001 | |||||
| REID, Michael John | Amministratore | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | England | Irish | 950490001 | |||||
| RIVERS, Paul Edward | Amministratore | Fox Cottage 1a Abingdon Road Tubney OX13 5QL Abingdon Oxfordshire | England | British | 62321110002 | |||||
| SIGURDSSON, Gunnar | Amministratore | 4 Greenlink Walk Kew Riverside TW9 4AF Richmond Upon Thames London | England | Icelandic | 114179720001 | |||||
| SUMMERS, Jeffrey | Amministratore | 5 Ashley Road Stoke Albany LE16 8PL Market Harborough Leicestershire | British | 127606650001 | ||||||
| WEST, James Edward | Amministratore | 4 Church Lane Stanford On Avon NN6 6JP Northampton Northamptonshire | England | British | 14107350002 |
MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of debenture | Creato il 22 nov 2005 Consegnato il 02 dic 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties | Creato il 05 giu 2001 Consegnato il 13 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined) | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 24 dic 1998 Consegnato il 02 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and the guarantee set out therein | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 29 giu 1995 Consegnato il 06 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the companies right title and interest in "the real property" as defined in form 395 together with fixed charge all of each charging companys right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security agreement) any rights or assets belonging to the company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Demise supplemental to trust deed of 15 jan 1909 registered pursuant to an order of court dated 10 december 1915 | Creato il 10 nov 1915 Consegnato il 15 dic 1915 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito An issue of £250,000 debenture stock | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets at the time of the registration of the said debenture issue being both the present demise is in substitution of certain property in norfolk street sheffield for property no 220 regent street london present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Land registry charge supplemental to trust deed dated 15 january 1909 | Creato il 22 ott 1909 Consegnato il 26 ott 1909 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 debenture stock | |
Brevi particolari Mansion house buildings queen victoria street the land comprised in land registry title no 120242 city of london. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Instrument of charge under land transfer acts 1875 & 1897 | Creato il 15 set 1909 Consegnato il 18 set 1909 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 | |
Brevi particolari 158, 160 & 162 oxford street and 1 & 2 winsley street and land comprised in the title no 88368 district london parish st.marylebone. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0