MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00100620
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Aurum House 2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MAPPIN & WEBB LIMITED10 dic 190810 dic 1908

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 lug 2010

    Stato del capitale al 13 lug 2010

    • Capitale: GBP 1,264,248
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2010

    3 pagineAA

    Bilancio redatto al 01 feb 2009

    11 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Edwin Gerrard il 05 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Justin Paul David Stead il 05 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Clive Sargent il 05 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Broderick il 05 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Gillian Oliff il 05 ott 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 03 feb 2008

    12 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 27 gen 2007

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OLIFF, Gillian
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Segretario
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    British128108960001
    BRODERICK, Anthony John
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Amministratore
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish98431500001
    GERRARD, Richard Edwin
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Amministratore
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish124068680001
    SARGENT, Stephen Clive
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Amministratore
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritish16905350005
    STEAD, Justin Paul David
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    Amministratore
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandAustralian116638810003
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    Segretario
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    LOBB, Andrew Mark
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    Segretario
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    British74760630002
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    Segretario
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Segretario
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    British62321110002
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritish55757700003
    ASPREY, John Rolls
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    Amministratore
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    United KingdomBritish68034280002
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    Amministratore
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritish25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    Amministratore
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritish92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish69874610002
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    Amministratore
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    British92733900001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    Amministratore
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    British66486140001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    Amministratore
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritish57490310002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    British61931900002
    GREEN, Edward Maurice
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    Amministratore
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    British47989150001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    LOWDEN, David Soutar
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish54836190001
    MCCLOSKEY, Ciaran
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    Amministratore
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    British88312080001
    PIASECKI, Jerzy Stanislaw
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    Amministratore
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    EnglandBritish129561330001
    PILKINGTON, Judith Mary
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    Amministratore
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    United KingdomBritish106791670001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Amministratore
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    EnglandIrish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritish62321110002
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Amministratore
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandic114179720001
    SUMMERS, Jeffrey
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    Amministratore
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    British127606650001
    WEST, James Edward
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish14107350002

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of debenture
    Creato il 22 nov 2005
    Consegnato il 02 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Islands Hf
    Transazioni
    • 02 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    Creato il 05 giu 2001
    Consegnato il 13 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 02 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    Transazioni
    • 02 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 dic 1998
    Consegnato il 02 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and the guarantee set out therein
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    Transazioni
    • 02 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companies right title and interest in "the real property" as defined in form 395 together with fixed charge all of each charging companys right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security agreement) any rights or assets belonging to the company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Demise supplemental to trust deed of 15 jan 1909 registered pursuant to an order of court dated 10 december 1915
    Creato il 10 nov 1915
    Consegnato il 15 dic 1915
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    An issue of £250,000 debenture stock
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets at the time of the registration of the said debenture issue being both the present demise is in substitution of certain property in norfolk street sheffield for property no 220 regent street london present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • W.J. Mappin
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    • E.W. Grimwade
    Transazioni
    • 15 dic 1915Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Land registry charge supplemental to trust deed dated 15 january 1909
    Creato il 22 ott 1909
    Consegnato il 26 ott 1909
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 debenture stock
    Brevi particolari
    Mansion house buildings queen victoria street the land comprised in land registry title no 120242 city of london. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • W.J. Mappin
    • E.W. Grimwade
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    Transazioni
    • 26 ott 1909Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Instrument of charge under land transfer acts 1875 & 1897
    Creato il 15 set 1909
    Consegnato il 18 set 1909
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000
    Brevi particolari
    158, 160 & 162 oxford street and 1 & 2 winsley street and land comprised in the title no 88368 district london parish st.marylebone.
    Persone aventi diritto
    • E.W.Grimwade
    • V.Alexander
    • W.J.Mappin
    • C.H. Passingham
    Transazioni
    • 18 set 1909Registrazione di un'ipoteca
    • 12 lug 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0