WILSON TUPHOLME LIMITED

WILSON TUPHOLME LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWILSON TUPHOLME LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00101451
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WILSON TUPHOLME LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WILSON TUPHOLME LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Stratford Court C/O S&U Plc Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WILSON TUPHOLME LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per WILSON TUPHOLME LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 17 nov 2021

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2021

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2020

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2019

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 6 the Quadrangle C/O S&U Plc Cranmore Avenue Shirley Solihull West Midlands B90 4LE England a 2 Stratford Court C/O S&U Plc Cranmore Boulevard Shirley Solihull B90 4QT in data 25 lug 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di S & U Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2017

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 giu 2016

    Stato del capitale al 28 giu 2016

    • Capitale: GBP 80,400
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2016

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Christopher Hugh Redford come segretario in data 31 ott 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Martin Anthony Christy come amministratore in data 31 ott 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di John William Hanson come segretario in data 31 ott 2015

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di WILSON TUPHOLME LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REDFORD, Christopher Hugh
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    Segretario
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    208557590001
    COOMBS, Anthony Michael Vincent
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    Amministratore
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    United KingdomBritishCompany Director100677940001
    COOMBS, Graham Derek Clifford
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    Amministratore
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    United KingdomBritishDirector69370910002
    REDFORD, Christopher Hugh
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    Amministratore
    Cranmore Boulevard
    Shirley
    B90 4QT Solihull
    2 Stratford Court C/O S&U Plc
    England
    United KingdomBritishCompany Director68072670007
    AMBLER, Thelma Joan
    3 Mallards Reach
    B92 7BX Solihull
    West Midlands
    Segretario
    3 Mallards Reach
    B92 7BX Solihull
    West Midlands
    British30987060001
    HANSON, John William
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    Segretario
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    BritishCompany Secretary93728770001
    MAIDEN, Edward David
    60 Creynolds Lane
    Shirley
    B90 4ER Solihull
    West Midlands
    Segretario
    60 Creynolds Lane
    Shirley
    B90 4ER Solihull
    West Midlands
    British30141660002
    BADDELEY, Kenneth John
    44 Ash Grove
    Ashbank
    ST2 9EF Stoke-On-Trent
    Staffs
    Amministratore
    44 Ash Grove
    Ashbank
    ST2 9EF Stoke-On-Trent
    Staffs
    EnglishCompany Director29872280001
    CHRISTY, Martin Anthony
    Stirches Road
    TD9 7HF Hawick
    Creg Ny Baa
    Roxburghshire
    Amministratore
    Stirches Road
    TD9 7HF Hawick
    Creg Ny Baa
    Roxburghshire
    United KingdomBritishCompany Director106283650002
    CHRISTY, Martin Anthony
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishCompany Director106283650002
    COATES, James Edwin
    14 Clifton Grove
    Beaumont Park
    NE25 9UB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    14 Clifton Grove
    Beaumont Park
    NE25 9UB Whitley Bay
    Tyne & Wear
    EnglishCompany Director28981250002
    COOMBS, Clifford Keith
    Stripes Hill House
    Warwick Road Knowle
    B93 0DT Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Stripes Hill House
    Warwick Road Knowle
    B93 0DT Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishJoint Chairman13183160001
    COOMBS, Derek Michael
    Steepleton House
    Iwerne Steepleton
    DT11 8PR Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Steepleton House
    Iwerne Steepleton
    DT11 8PR Blandford Forum
    Dorset
    United KingdomBritishChairman64301340001
    FISHER, Robert Eric John
    105 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    105 Dorridge Road
    Dorridge
    B93 8BP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant13183150001
    HANSON, John William
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle C/O S&U Plc
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector93728770001
    NOBLE, Bryan Leslie
    2 Rosewood
    Killingworth
    NE12 0FG Newcastle Upon Tyne
    Durham
    Amministratore
    2 Rosewood
    Killingworth
    NE12 0FG Newcastle Upon Tyne
    Durham
    BritishGeneral Manager49120350001
    SHAW, Glenn
    6 Bewick Drive
    NG3 7GB Bakersfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    6 Bewick Drive
    NG3 7GB Bakersfield
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director91824500001
    SOWDEN, Russell
    2 Lyndhurst Drive
    Norton
    DN6 9PZ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Lyndhurst Drive
    Norton
    DN6 9PZ Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector69633820001
    WILLIAMS, David Andre
    186 Sutton Road
    NG18 5HH Mansfield
    Nottinghamshire
    Amministratore
    186 Sutton Road
    NG18 5HH Mansfield
    Nottinghamshire
    BritishGeneral Manager35724360001

    Chi sono le persone con controllo significativo di WILSON TUPHOLME LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    S & U Plc
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle
    England
    06 apr 2016
    Cranmore Avenue
    Shirley
    B90 4LE Solihull
    6 The Quadrangle
    England
    No
    Forma giuridicaPlc
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House, Cardiff
    Numero di registrazione342025
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    WILSON TUPHOLME LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge
    Creato il 31 gen 1985
    Consegnato il 19 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (1) all monies due under all lease agreements deposited by the company with the chargee. (2) the chattels comprised in the said lease agreements. (3) all guarantees, indemnities and other securities taken by the company in connection with the said lease agreements (4) insurance in respect of chattels comprised in the said lease agreements.
    Persone aventi diritto
    • Henry Ansbacher & Co Limited.
    Transazioni
    • 19 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 31 gen 1984
    Consegnato il 20 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1. all payments and other monies due to the company and henceforth to become due under all leasing agreements. 2. the chattels comprised in the said leasing agreements. 3. all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the leasing agreements. 4. all insurances taken out by the company in respect of the details comprised in the leasing agreements.
    Persone aventi diritto
    • Ansbacher Finance Limited
    Transazioni
    • 20 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Assignment
    Creato il 31 gen 1984
    Consegnato il 16 feb 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement dated 31 jan 84
    Brevi particolari
    A vehicle head lease agreement and schedule dated 31 jan '86.
    Persone aventi diritto
    • M H Credit Corporation Limited.
    Transazioni
    • 16 feb 1984Registrazione di un'ipoteca
    Limited charge over lease agreements
    Creato il 31 gen 1983
    Consegnato il 07 feb 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All sub-hiring agreements entered to with the customers of the company relating to the motor vehicles or other goods or equipment owned by the mortgagee but let to the company under hire purchase agreement.
    Persone aventi diritto
    • Canada Permanent Court Company (UK) Limited.
    Transazioni
    • 07 feb 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 20 set 1976
    Consegnato il 30 set 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 minna road sheffield together with all fixtures see doc 134 for fuller details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 set 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second floating charge
    Creato il 02 lug 1976
    Consegnato il 09 lug 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Second floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital (see doc 133 for details).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 feb 1975
    Consegnato il 25 feb 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    290/308 pitsmoor road sheffield yorkshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 1970
    Consegnato il 29 mag 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All debts (including debts for credit sales payable by instalments) or debts due or to become due from any customer as a result of any sale of goods on sale or return.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds and Scottish Trust LTD
    Transazioni
    • 29 mag 1970Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0