WILSON TUPHOLME LIMITED
Panoramica
Nome della società | WILSON TUPHOLME LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00101451 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WILSON TUPHOLME LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova WILSON TUPHOLME LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Stratford Court C/O S&U Plc Cranmore Boulevard Shirley B90 4QT Solihull England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WILSON TUPHOLME LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per WILSON TUPHOLME LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 17 nov 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 the Quadrangle C/O S&U Plc Cranmore Avenue Shirley Solihull West Midlands B90 4LE England a 2 Stratford Court C/O S&U Plc Cranmore Boulevard Shirley Solihull B90 4QT in data 25 lug 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di S & U Plc come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Hugh Redford come segretario in data 31 ott 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Anthony Christy come amministratore in data 31 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John William Hanson come segretario in data 31 ott 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WILSON TUPHOLME LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDFORD, Christopher Hugh | Segretario | Cranmore Boulevard Shirley B90 4QT Solihull 2 Stratford Court C/O S&U Plc England | 208557590001 | |||||||
COOMBS, Anthony Michael Vincent | Amministratore | Cranmore Boulevard Shirley B90 4QT Solihull 2 Stratford Court C/O S&U Plc England | United Kingdom | British | Company Director | 100677940001 | ||||
COOMBS, Graham Derek Clifford | Amministratore | Cranmore Boulevard Shirley B90 4QT Solihull 2 Stratford Court C/O S&U Plc England | United Kingdom | British | Director | 69370910002 | ||||
REDFORD, Christopher Hugh | Amministratore | Cranmore Boulevard Shirley B90 4QT Solihull 2 Stratford Court C/O S&U Plc England | United Kingdom | British | Company Director | 68072670007 | ||||
AMBLER, Thelma Joan | Segretario | 3 Mallards Reach B92 7BX Solihull West Midlands | British | 30987060001 | ||||||
HANSON, John William | Segretario | Cranmore Avenue Shirley B90 4LE Solihull 6 The Quadrangle C/O S&U Plc West Midlands England | British | Company Secretary | 93728770001 | |||||
MAIDEN, Edward David | Segretario | 60 Creynolds Lane Shirley B90 4ER Solihull West Midlands | British | 30141660002 | ||||||
BADDELEY, Kenneth John | Amministratore | 44 Ash Grove Ashbank ST2 9EF Stoke-On-Trent Staffs | English | Company Director | 29872280001 | |||||
CHRISTY, Martin Anthony | Amministratore | Stirches Road TD9 7HF Hawick Creg Ny Baa Roxburghshire | United Kingdom | British | Company Director | 106283650002 | ||||
CHRISTY, Martin Anthony | Amministratore | Cranmore Avenue Shirley B90 4LE Solihull 6 The Quadrangle C/O S&U Plc West Midlands England | United Kingdom | British | Company Director | 106283650002 | ||||
COATES, James Edwin | Amministratore | 14 Clifton Grove Beaumont Park NE25 9UB Whitley Bay Tyne & Wear | English | Company Director | 28981250002 | |||||
COOMBS, Clifford Keith | Amministratore | Stripes Hill House Warwick Road Knowle B93 0DT Solihull West Midlands | England | British | Joint Chairman | 13183160001 | ||||
COOMBS, Derek Michael | Amministratore | Steepleton House Iwerne Steepleton DT11 8PR Blandford Forum Dorset | United Kingdom | British | Chairman | 64301340001 | ||||
FISHER, Robert Eric John | Amministratore | 105 Dorridge Road Dorridge B93 8BP Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 13183150001 | |||||
HANSON, John William | Amministratore | Cranmore Avenue Shirley B90 4LE Solihull 6 The Quadrangle C/O S&U Plc West Midlands England | United Kingdom | British | Director | 93728770001 | ||||
NOBLE, Bryan Leslie | Amministratore | 2 Rosewood Killingworth NE12 0FG Newcastle Upon Tyne Durham | British | General Manager | 49120350001 | |||||
SHAW, Glenn | Amministratore | 6 Bewick Drive NG3 7GB Bakersfield Nottinghamshire | British | Company Director | 91824500001 | |||||
SOWDEN, Russell | Amministratore | 2 Lyndhurst Drive Norton DN6 9PZ Doncaster South Yorkshire | British | Director | 69633820001 | |||||
WILLIAMS, David Andre | Amministratore | 186 Sutton Road NG18 5HH Mansfield Nottinghamshire | British | General Manager | 35724360001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di WILSON TUPHOLME LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S & U Plc | 06 apr 2016 | Cranmore Avenue Shirley B90 4LE Solihull 6 The Quadrangle England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
WILSON TUPHOLME LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Charge | Creato il 31 gen 1985 Consegnato il 19 feb 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (1) all monies due under all lease agreements deposited by the company with the chargee. (2) the chattels comprised in the said lease agreements. (3) all guarantees, indemnities and other securities taken by the company in connection with the said lease agreements (4) insurance in respect of chattels comprised in the said lease agreements. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 31 gen 1984 Consegnato il 20 feb 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 1. all payments and other monies due to the company and henceforth to become due under all leasing agreements. 2. the chattels comprised in the said leasing agreements. 3. all guarantees indemnities negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the leasing agreements. 4. all insurances taken out by the company in respect of the details comprised in the leasing agreements. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Assignment | Creato il 31 gen 1984 Consegnato il 16 feb 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement dated 31 jan 84 | |
Brevi particolari A vehicle head lease agreement and schedule dated 31 jan '86. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Limited charge over lease agreements | Creato il 31 gen 1983 Consegnato il 07 feb 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All sub-hiring agreements entered to with the customers of the company relating to the motor vehicles or other goods or equipment owned by the mortgagee but let to the company under hire purchase agreement. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 20 set 1976 Consegnato il 30 set 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 31 minna road sheffield together with all fixtures see doc 134 for fuller details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Second floating charge | Creato il 02 lug 1976 Consegnato il 09 lug 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Second floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital (see doc 133 for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 19 feb 1975 Consegnato il 25 feb 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 290/308 pitsmoor road sheffield yorkshire together with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 12 mag 1970 Consegnato il 29 mag 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All debts (including debts for credit sales payable by instalments) or debts due or to become due from any customer as a result of any sale of goods on sale or return. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0