NAMESHELL 2 LIMITED

NAMESHELL 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNAMESHELL 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00106501
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NAMESHELL 2 LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova NAMESHELL 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Windsor House
    Barnett Way
    GL4 3RT Barnwood
    Gloucester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NAMESHELL 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HEATH GROUP LIMITED20 apr 199820 apr 1998
    C.E. HEATH PUBLIC LIMITED COMPANY17 dic 190917 dic 1909

    Quali sono gli ultimi bilanci di NAMESHELL 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2004

    Quali sono le ultime deposizioni per NAMESHELL 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 feb 2011

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 dic 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 giu 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 dic 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 giu 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 dic 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 11 dic 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    11 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed heath group LIMITED\certificate issued on 02/06/05
    2 pagineCERTNM

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    12 pagineAA

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di NAMESHELL 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    Friary Court
    Crutched Friars
    EC3N 2NP London
    Segretario
    Friary Court
    Crutched Friars
    EC3N 2NP London
    43700080004
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    Amministratore
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritish72374560002
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish61928170002
    THOMAS, Robert Nigel
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    Amministratore
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    United KindgomBritish40630840002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Segretario
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    BROADHURST, Timothy Edward
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Highfield House Main Road
    Knockholt
    TN14 7NU Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish8657480001
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Amministratore
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    CLAY, John Martin
    1 Hertsfield Oast
    Staplehurst Road Marden
    TN12 9BW Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    1 Hertsfield Oast
    Staplehurst Road Marden
    TN12 9BW Tonbridge
    Kent
    British1524000003
    CROWNE, Peter Charles
    74c
    Granville Park
    SE13 7DX London
    Amministratore
    74c
    Granville Park
    SE13 7DX London
    British68603490001
    DUFFIELD, Peter William John
    Copyhold
    Eridge
    TN3 9LN Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Copyhold
    Eridge
    TN3 9LN Tunbridge Wells
    Kent
    British94820000001
    FIELDING, Richard Walter
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    West Hall
    Longburton
    DT9 5PF Sherborne
    Dorset
    United KingdomBritish77656210001
    HUGHES, Paul John
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    Amministratore
    96 Burnham Road
    SS9 2JS Leigh On Sea
    Essex
    EnglandBritish5389800001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    MACKAY, Ian Hamish Noel
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    Amministratore
    27 Percy Laurie House
    217 Upper Richmond Road
    SW15 6SY London
    British104334150001
    MACKENZIE GREEN, John Garvie
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    Amministratore
    Higher Langdon
    DT8 3NN Beaminster
    Dorset
    British34988570004
    MONEY, Anthony John
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    Bevingdon House
    Belchamp Otten
    CO10 7BE Sudbury
    Suffolk
    EnglandBritish8785440001
    MORROW, Ian, Sir
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    British1890700002
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Amministratore
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    Amministratore
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    British33862660001
    SANSOM, Richard James
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    Amministratore
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    United KingdomBritish105966060001
    SPORBORG, Christopher Henry
    Brooms Farm
    Upwick Green Albury
    SG11 2JX Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Brooms Farm
    Upwick Green Albury
    SG11 2JX Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish33747850002
    STEWART, Callum John Tyndale
    18 Hereford Square
    SW7 4TS London
    Amministratore
    18 Hereford Square
    SW7 4TS London
    British5291230007
    TOOKEY, Timothy James William
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    Amministratore
    28 Brabourne Rise
    BR3 6SG Beckenham
    Kent
    British57236570002
    WILLIAMS, Raymond Reginald
    4 Burran Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    Amministratore
    4 Burran Avenue
    Mosman
    New South Wales
    Australia
    Australian28558670001

    NAMESHELL 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 feb 2000
    Consegnato il 09 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 16TH march 1998 and
    Creato il 29 gen 1998
    Consegnato il 26 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents
    Brevi particolari
    All and whole that piece of ground along the north side of the road or street called carden place in the city parish of aberdeen and county of aberdeen.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 26 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third guarantee and debenture
    Creato il 31 dic 1997
    Consegnato il 14 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 14 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 03 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 05 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 13 set 1991
    Consegnato il 18 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 7/4/88
    Brevi particolari
    All that 5TH floor goodbard house infirmary street leeds.
    Persone aventi diritto
    • Dunn & Wilson Limited
    Transazioni
    • 18 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    NAMESHELL 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mag 2011Data di scioglimento
    12 dic 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Philip John Gorman
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester
    Praticante
    Hazlewoods
    Windsor House
    Barnett Way
    Barnwood Gloucester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0