SUTER ESTATES LIMITED

SUTER ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUTER ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00107150
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUTER ESTATES LIMITED?

    • (7020) /

    Dove si trova SUTER ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUTER ESTATES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERMETIC SECURITIES LIMITED26 gen 191026 gen 1910

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUTER ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SUTER ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    2 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE in data 08 mar 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 feb 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Vinod Bachulal Vaghela come amministratore in data 21 dic 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2011

    Stato del capitale al 03 mag 2011

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    11 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip Warner come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    11 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    13 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    15 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    17 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SUTER ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Amministratore
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    Segretario
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Segretario
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Segretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Segretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    PATON WALSH, Antony Edmund
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    Segretario
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    British43425770001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Segretario
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Segretario
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    ABELL, John David
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71975220001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Amministratore
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Amministratore
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FIRTH, Arthur Gregory
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    Amministratore
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    British17118450001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Amministratore
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    Amministratore
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    HOARE, Brian David
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    British28340230001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    REYNOLDS, Malcolm Stanley
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    Amministratore
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    British10865710001
    RIDER, Stuart Granville
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    British36675890002
    RILEY, Michael James
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    Amministratore
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    British3055390001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Amministratore
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    Amministratore
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    SUTER ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 04 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 04 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mezzanine security agreement
    Creato il 22 lug 2005
    Consegnato il 01 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Warner Estate, Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of debenture
    Creato il 16 lug 2003
    Consegnato il 21 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 dic 1998
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of admission
    Creato il 23 mar 1995
    Consegnato il 10 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus debenture
    Creato il 25 mag 1994
    Consegnato il 01 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 feb 1982
    Consegnato il 05 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set-off
    Creato il 21 mag 1981
    Consegnato il 28 mag 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1981Registrazione di un'ipoteca
    Special omnibus letter of set off
    Creato il 30 giu 1980
    Consegnato il 08 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    Special omnibus letter of set off
    Creato il 01 gen 1979
    Consegnato il 08 gen 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 24 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SUTER ESTATES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2012Data di scioglimento
    28 feb 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praticante
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0