ADARE PILLINGS LIMITED

ADARE PILLINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADARE PILLINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00120184
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADARE PILLINGS LIMITED?

    • altre attività di stampa n.c.a. (18129) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ADARE PILLINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Co Bdo Llp 1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ADARE PILLINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PILLINGS PRINTING COMPANY LIMITED15 ago 198315 ago 1983
    MARMADUKE PILLING & SONS,LIMITED10 feb 191210 feb 1912

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADARE PILLINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per ADARE PILLINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    14 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2015

    21 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2014

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 mag 2013

    20 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da * Marrons Solicitors 1 Meridian South Meridian Business Park Leicester Leicestershire LE19 1WY* in data 22 giu 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 09 mag 2012

    LRESEX

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Arthur Herbert il 04 nov 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 gen 2012

    Stato del capitale al 04 gen 2012

    • Capitale: GBP 4,202
    SH01

    Bilancio redatto al 31 ott 2010

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 ott 2009

    22 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Marrons Consultancies Limited il 06 gen 2010

    2 pagineCH04

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 apr 2008

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 apr 2007

    24 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 apr 2006

    26 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ADARE PILLINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01708508
    65475060002
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    Amministratore
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    Amministratore
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director81547240001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishAccountant96288470001
    PILLING, Muriel Joyce
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    British22257260002
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    Amministratore
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishPrinter51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    Amministratore
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director\99667360001
    HARRIS, Robert Stanley
    2 Woodlands Close
    PR9 9PN Southport
    Merseyside
    Amministratore
    2 Woodlands Close
    PR9 9PN Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishSenior Executive113919560001
    HOYLE, James Herbert
    12 Guildway
    HX2 7RR Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Guildway
    HX2 7RR Halifax
    West Yorkshire
    BritishWorks Director105124940001
    LACEY, Janice Clare
    121 Commercial Road
    Skelmanthorpe
    HD8 9DX Huddersfield
    Amministratore
    121 Commercial Road
    Skelmanthorpe
    HD8 9DX Huddersfield
    BritishSales Director34941350001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    Amministratore
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAccountant96288470001
    MARSH, Edward William
    1 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    Amministratore
    1 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    BritishCommercial Director40368550001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PILLING, Derek Frank Marmaduke
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector7143260002
    PILLING, John Edgar
    70 Meadowvale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    70 Meadowvale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector22257290002
    PILLING, Kenneth Marmaduke
    100 Green Lane
    Greetland
    HX4 8BL Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    100 Green Lane
    Greetland
    HX4 8BL Halifax
    West Yorkshire
    BritishTaxi Business Proprietor22257270001
    PILLING, Marmaduke
    67 Victoria Road
    HX5 0QA Elland
    West Yorkshire
    Amministratore
    67 Victoria Road
    HX5 0QA Elland
    West Yorkshire
    BritishRetired22257330001
    PILLING, Muriel Joyce
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    BritishSecretary22257260002
    PILLING, Richard David
    Water Hill Springs Water Hill Lane
    Warley
    HX2 7SG Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Water Hill Springs Water Hill Lane
    Warley
    HX2 7SG Halifax
    West Yorkshire
    BritishManaging Director22257310002
    STANLEY, Richard
    8/9 Cockhill Lane
    Shelf
    HX3 7LP Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    8/9 Cockhill Lane
    Shelf
    HX3 7LP Halifax
    West Yorkshire
    BritishSales Director Creative22257300001
    WADSWORTH, John David
    211 Oakwood Lane
    Roundhay
    LS8 2PE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    211 Oakwood Lane
    Roundhay
    LS8 2PE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSales Director-Printing22257320001

    ADARE PILLINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 11 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior loan agreement and /or the senior note documents (all as defined) to which such charging company is a party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a pillings printing premises being land on the north side of elland lane elland west yorkshire t/no: WYK417419.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    Creato il 30 ago 2000
    Consegnato il 08 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    Transazioni
    • 08 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattles mortgage
    Creato il 27 apr 1998
    Consegnato il 29 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 used heidelberg web-8 five unit press manufactured in 1987 serial no 402 103.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Group Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 apr 1996
    Consegnato il 09 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks Plcsin It's Capacity as Trustee for the Beneficiarie
    Transazioni
    • 09 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2003Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 31ST july 1992 issued by the company
    Creato il 05 set 1995
    Consegnato il 13 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    Fixed charge over all rights,title and interest in a factoring or invoice discounting deed dated 1/8/95...................all book/other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge over book debts
    Creato il 01 ago 1995
    Consegnato il 05 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement leasing agreement or otherwise in any manner whatsoever including all liabilities in connection with or under guarantees indemnities documentary or other credits or any instruments whatsoever from time to time assumed or entered into
    Brevi particolari
    First the ultimate balance due or owing to the company by tih under any factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company and the balance due or owing to the company by tih under a factoring agreement dated 1 august 1995 and secondly all other book and other debts due or owing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Corporate mortgage
    Creato il 13 mag 1994
    Consegnato il 20 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities for the time being owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 5TH april 1994 including any modification or replacement thereof
    Brevi particolari
    8 unit didde machine serial no. 450-0025. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 02 ott 1992
    Consegnato il 08 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,487.98 under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All rights title interest in and to all sums payable under the insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 08 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 1992
    Consegnato il 07 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC.
    Transazioni
    • 07 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land situate near to the cross elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land situate near to westgate elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land with the petrol store on part thereof situate of northgate elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land and premises situate off westgate elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land with the two garages on part thereof situate off northgate elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and building on the north side of westgate elland west yorkshire t/n wyk 247044.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 1991
    Consegnato il 03 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of westgate elland west yorkshire t/n wyk 149637.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1988
    Consegnato il 27 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot of land of elland lane, elland west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 01 ott 1912
    Consegnato il 04 ott 1912
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £720
    Brevi particolari
    Land and premises known as the london house, the cross, elland, yorks.
    Persone aventi diritto
    • Halifax Equitable Benefit Building Society
    Transazioni
    • 04 ott 1912Registrazione di un'ipoteca
    • 09 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ADARE PILLINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mag 2012Inizio della liquidazione
    12 ott 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Mark James Shaw
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0