EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00122207 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EUROPEAN MOTOR HOLDINGS PLC | 28 ott 1991 | 28 ott 1991 |
CARGO CONTROL PLC | 20 ott 1989 | 20 ott 1989 |
JANTAR PLC | 21 giu 1989 | 21 giu 1989 |
JANTAR P.L.C. | 24 mag 1912 | 24 mag 1912 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Andrew Dale come amministratore in data 29 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 20 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Thomas Andrew Dale come amministratore in data 04 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come amministratore in data 04 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Dr Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 01 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Louise Catlin come amministratore in data 21 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Catlin il 01 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Inchcape Uk Corporate Management Limited il 01 apr 2018 | 3 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford Oxfordshire OX5 1HT a First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN in data 06 apr 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Inchcape International Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Louise Catlin come amministratore in data 23 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Peter Wheatley il 29 gen 2016 | 3 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED | Segretario | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham United Kingdom |
| 100307260072 | ||||||||||
WHEATLEY, Martin Peter | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Company Secretary | 55180460002 | ||||||||
BEACHAM, Mark Derrick | Segretario | Austwick Lane Emerson Valley MK4 2DR Milton Keynes 11 Buckinghamshire United Kingdom | British | 135313320001 | ||||||||||
ABRAHAMS, Roger Graham | Amministratore | 59 Brampton Grove NW4 4AH London | United Kingdom | British | Solicitor | 126200540001 | ||||||||
BECK, David Richard | Amministratore | RG8 0JY Goring On Thames The Temple Berkshire | United Kingdom | British | Business Consultant | 138403420001 | ||||||||
BENSON, Stuart Howard | Amministratore | Hill End South Hill Avenue Harrow On The Hill HA1 3PA Harrow Middlesex | British | Solicitor | 9292600001 | |||||||||
BIRCH, James Edward | Amministratore | Waters Reach Mill Lane Little Budworth CW6 9DB Tarporley Cheshire | English | Director | 25690560001 | |||||||||
BIZLEY, John Geoffrey | Amministratore | Cinderford Hellingley BN27 4HL Hailsham East Sussex | British | Director | 35551880001 | |||||||||
CASEY, Joseph Laurence | Amministratore | 31 Kenwood Drive BR3 6QX Beckenham Kent | Usa | Managing Director | 51323410001 | |||||||||
CATLIN, Claire Louise | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Company Director | 270101940001 | ||||||||
COWIE, Thomas, Sir | Amministratore | Broadwood Hall DH7 0TD Lanchester County Durham | United Kingdom | British | Company Director | 142033700001 | ||||||||
DALE, Thomas Andrew | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | Company Director | 260286850001 | ||||||||
HANCOX, Elizabeth Louise, Dr | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | United Kingdom | British | Company Director | 210216760001 | ||||||||
JEARY, Anton Clive | Amministratore | Park Square Solihull Parkway B37 7YN Birmingham Business Park First Floor, Unit 3140 Birmingham | England | British | Accountant | 169892630001 | ||||||||
LOCK, Spencer | Amministratore | The Dower House Itchen Abbas SO21 1BQ Winchester Hampshire | England | British | Company Director | 92493930001 | ||||||||
MCCLUSKEY, Ross | Amministratore | Langford Lane Kidlington OX5 1HT Oxford Inchcape House Oxfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 165677350002 | ||||||||
MCCORMACK, Connor | Amministratore | New College House Alchester Road OX26 1UN Chesterton Oxfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 108832810002 | ||||||||
MILLIKEN, Katherine | Amministratore | Flat 4 23 Sunderland Terrace W2 5PA London | British | Solicitor | 99442150001 | |||||||||
PALMER, Richard Terence | Amministratore | Littlethorpe Cleeve Road RG8 9BJ Goring | England | British | Chief Executive | 16571890002 | ||||||||
PATON, Hamish Kinloch | Amministratore | Days Orchard 28 School Road Penn HP10 8EF High Wycombe Buckinghamshire | British | General Manager | 49687450001 | |||||||||
PUTNAM, Roger George, Professor | Amministratore | Further Hill Grange Ullenhall B95 5PN Henley-In-Arden Warwickshire | United Kingdom | British | Company Director | 7516000001 | ||||||||
RICHMOND, Barbara Mary | Amministratore | Apartmant 1003 8 Dean Ryle Street SW1P 4DA London | United Kingdom | British | Company Director | 152559820001 | ||||||||
RONCHETTI, Marc Arthur | Amministratore | New Road Croxley Green WD3 3EP Rickmansworth 22 Hertfordshire | England | British | Accountant | 123180830001 | ||||||||
SMITH, Roger John | Amministratore | Gilvers AL3 8AD Markyate Hertfordshire | England | British | Director Of Companies | 14247350001 | ||||||||
WILSON, Ann Chrisette | Amministratore | The Kingswood Ridgemount Road SL5 9RW Sunningdale Berkshire | England | British | Finance Director | 14811650002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inchcape International Holdings Limited | 06 apr 2016 | St James's Square SW1Y 5LP London 22a England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Agreement | Creato il 28 set 1992 Consegnato il 07 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £195,389.22 under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All rights title interest in and to all sums payable under the insurances. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 nov 1991 Consegnato il 18 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Credit agreement | Creato il 05 dic 1990 Consegnato il 17 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £38688.20 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All rights title and in and to all sums payable under the insurance see form 395 (ref 162) for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 mar 1990 Consegnato il 02 apr 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings on the east side of groat road, aycliffe industrial estate newton aycliffe county durham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of charge | Creato il 19 feb 1990 Consegnato il 01 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies now or hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 09 gen 1990 Consegnato il 11 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of first fixed charge, the debt represented by all sums which are or shall hereafter be standing to the credit of the deposit account numbered 37295001 held with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 20 ott 1989 Consegnato il 27 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0