EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED

EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00122207
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor, Unit 3140 Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROPEAN MOTOR HOLDINGS PLC28 ott 199128 ott 1991
    CARGO CONTROL PLC20 ott 198920 ott 1989
    JANTAR PLC21 giu 198921 giu 1989
    JANTAR P.L.C.24 mag 191224 mag 1912

    Quali sono gli ultimi bilanci di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Thomas Andrew Dale come amministratore in data 29 gen 2020

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 20 set 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas Andrew Dale come amministratore in data 04 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anton Clive Jeary come amministratore in data 04 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Dr Elizabeth Louise Hancox come amministratore in data 01 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Claire Louise Catlin come amministratore in data 21 set 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Claire Louise Catlin il 01 set 2018

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Inchcape Uk Corporate Management Limited il 01 apr 2018

    3 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da Inchcape House Langford Lane Kidlington Oxford Oxfordshire OX5 1HT a First Floor, Unit 3140 Park Square Solihull Parkway Birmingham Business Park Birmingham B37 7YN in data 06 apr 2018

    2 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 giu 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Inchcape International Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Nomina di Mrs Claire Louise Catlin come amministratore in data 23 set 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 22 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2016

    Stato del capitale al 23 giu 2016

    • Capitale: GBP 1.2
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Martin Peter Wheatley il 29 gen 2016

    3 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INCHCAPE UK CORPORATE MANAGEMENT LIMITED
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United Kingdom
    Segretario
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5200589
    100307260072
    WHEATLEY, Martin Peter
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Amministratore
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Secretary55180460002
    BEACHAM, Mark Derrick
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Austwick Lane
    Emerson Valley
    MK4 2DR Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British135313320001
    ABRAHAMS, Roger Graham
    59 Brampton Grove
    NW4 4AH London
    Amministratore
    59 Brampton Grove
    NW4 4AH London
    United KingdomBritishSolicitor126200540001
    BECK, David Richard
    RG8 0JY Goring On Thames
    The Temple
    Berkshire
    Amministratore
    RG8 0JY Goring On Thames
    The Temple
    Berkshire
    United KingdomBritishBusiness Consultant138403420001
    BENSON, Stuart Howard
    Hill End South Hill Avenue
    Harrow On The Hill
    HA1 3PA Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    Hill End South Hill Avenue
    Harrow On The Hill
    HA1 3PA Harrow
    Middlesex
    BritishSolicitor9292600001
    BIRCH, James Edward
    Waters Reach Mill Lane
    Little Budworth
    CW6 9DB Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Waters Reach Mill Lane
    Little Budworth
    CW6 9DB Tarporley
    Cheshire
    EnglishDirector25690560001
    BIZLEY, John Geoffrey
    Cinderford Hellingley
    BN27 4HL Hailsham
    East Sussex
    Amministratore
    Cinderford Hellingley
    BN27 4HL Hailsham
    East Sussex
    BritishDirector35551880001
    CASEY, Joseph Laurence
    31 Kenwood Drive
    BR3 6QX Beckenham
    Kent
    Amministratore
    31 Kenwood Drive
    BR3 6QX Beckenham
    Kent
    UsaManaging Director51323410001
    CATLIN, Claire Louise
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Amministratore
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishCompany Director270101940001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Amministratore
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritishCompany Director142033700001
    DALE, Thomas Andrew
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Amministratore
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United KingdomBritishCompany Director260286850001
    HANCOX, Elizabeth Louise, Dr
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Amministratore
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    United KingdomBritishCompany Director210216760001
    JEARY, Anton Clive
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    Amministratore
    Park Square
    Solihull Parkway
    B37 7YN Birmingham Business Park
    First Floor, Unit 3140
    Birmingham
    EnglandBritishAccountant169892630001
    LOCK, Spencer
    The Dower House
    Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    The Dower House
    Itchen Abbas
    SO21 1BQ Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director92493930001
    MCCLUSKEY, Ross
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    Oxfordshire
    Amministratore
    Langford Lane
    Kidlington
    OX5 1HT Oxford
    Inchcape House
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director165677350002
    MCCORMACK, Connor
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    Amministratore
    New College House
    Alchester Road
    OX26 1UN Chesterton
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director108832810002
    MILLIKEN, Katherine
    Flat 4
    23 Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    Amministratore
    Flat 4
    23 Sunderland Terrace
    W2 5PA London
    BritishSolicitor99442150001
    PALMER, Richard Terence
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    Amministratore
    Littlethorpe
    Cleeve Road
    RG8 9BJ Goring
    EnglandBritishChief Executive16571890002
    PATON, Hamish Kinloch
    Days Orchard 28 School Road
    Penn
    HP10 8EF High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Days Orchard 28 School Road
    Penn
    HP10 8EF High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager49687450001
    PUTNAM, Roger George, Professor
    Further Hill Grange
    Ullenhall
    B95 5PN Henley-In-Arden
    Warwickshire
    Amministratore
    Further Hill Grange
    Ullenhall
    B95 5PN Henley-In-Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director7516000001
    RICHMOND, Barbara Mary
    Apartmant 1003
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    Amministratore
    Apartmant 1003
    8 Dean Ryle Street
    SW1P 4DA London
    United KingdomBritishCompany Director152559820001
    RONCHETTI, Marc Arthur
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Road
    Croxley Green
    WD3 3EP Rickmansworth
    22
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant123180830001
    SMITH, Roger John
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    Amministratore
    Gilvers
    AL3 8AD Markyate
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector Of Companies14247350001
    WILSON, Ann Chrisette
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    Amministratore
    The Kingswood Ridgemount Road
    SL5 9RW Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritishFinance Director14811650002

    Chi sono le persone con controllo significativo di EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Inchcape International Holdings Limited
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    06 apr 2016
    St James's Square
    SW1Y 5LP London
    22a
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom (England) Companies House
    Numero di registrazione3580629
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    EUROPEAN MOTOR HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Agreement
    Creato il 28 set 1992
    Consegnato il 07 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £195,389.22 under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All rights title interest in and to all sums payable under the insurances.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 07 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 set 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 nov 1991
    Consegnato il 18 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 28/10/91
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Svenska Handelsbanken
    Transazioni
    • 18 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 05 dic 1990
    Consegnato il 17 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £38688.20 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All rights title and in and to all sums payable under the insurance see form 395 (ref 162) for details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 17 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 mar 1990
    Consegnato il 02 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on the east side of groat road, aycliffe industrial estate newton aycliffe county durham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 19 feb 1990
    Consegnato il 01 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 gen 1990
    Consegnato il 11 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge, the debt represented by all sums which are or shall hereafter be standing to the credit of the deposit account numbered 37295001 held with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Sevenska Handelsbanken London Branch
    Transazioni
    • 11 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 20 ott 1989
    Consegnato il 27 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 giu 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0