BANDT PROPERTIES LIMITED

BANDT PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBANDT PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00124326
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BANDT PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Capital Tower
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROWN & TAWSE LIMITED09 giu 198609 giu 1986
    G.B.PARKES,LIMITED19 set 191219 set 1912

    Quali sono gli ultimi bilanci di BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale al 05 ago 2022

    • Capitale: GBP 1.10
    5 pagineSH19
    Note
    DataNota
    05 ago 2022Clarification This form is a second filing of the SH19 registered on 25/07/2022

    Stato del capitale al 25 lug 2022

    • Capitale: GBP 1
    6 pagineSH19
    Note
    DataNota
    05 ago 2022Clarification A second filed SH19 was registered on 05/08/22.

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 giu 2021 al 28 giu 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 29 dic 2020 al 29 giu 2021

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Jeremy Mark White come amministratore in data 29 lug 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony Kenneth Smythe come amministratore in data 30 lug 2021

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come amministratore in data 04 feb 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Christopher James Edwards come amministratore in data 03 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come segretario in data 02 feb 2021

    1 pagineTM02

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2019 al 29 dic 2019

    1 pagineAA01

    Modifica dei dettagli di Bandt Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 dic 2020

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da Interserve House Ruscombe Park Twyford Reading Berkshire RG10 9JU a Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT in data 04 dic 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 001243260010

    2 pagineMR05

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 001243260012

    2 pagineMR05

    Chi sono gli amministratori di BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EDWARDS, Christopher James
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Amministratore
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishGeneral Counsel And Corporate Secretary279311610001
    WHITE, Jeremy Mark
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Amministratore
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishChartered Accountant284537740001
    ASHFORTH, Phillip John
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    Segretario
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    British1311000004
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    British47884750003
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Segretario
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    241570590001
    BUTLER, Richard John
    23a Wharf Hill
    SO23 9NQ Winchester
    Hampshire
    Segretario
    23a Wharf Hill
    SO23 9NQ Winchester
    Hampshire
    British62923710002
    HARDING, Ian
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    Segretario
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    BritishChartered Accountant35278190002
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Segretario
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    249821440001
    ASHFORTH, Phillip John
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    Amministratore
    Woodside 17 Garth Road
    TN13 1RT Sevenoaks
    Kent
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant1311000004
    BRADBURY, Trevor
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Secretary47884750003
    BRETT, Alan John
    A 15 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HF Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    A 15 Park Lane
    Old Basing
    RG24 7HF Basingstoke
    Hampshire
    BritishSteel Stockholder124080001
    BRIERLEY, John
    23 Strawberry Lane
    SK9 6AQ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    23 Strawberry Lane
    SK9 6AQ Wilmslow
    Cheshire
    BritishSteel Stockholder15800730001
    BUSH, Daniel
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishSolicitor182845350001
    CLITHEROE, David Maurice
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    Amministratore
    3 Norman Court
    Oadby
    LE2 4UD Leicester
    BritishChartered Accountant49800090001
    FELL, James Thomas
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishGroup Financial Controller178128810002
    FORD, William
    The Old School House
    4 Vine Court Road
    TN13 3UU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    The Old School House
    4 Vine Court Road
    TN13 3UU Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Director47272920001
    GASPARRO, Christopher Nicholas
    93 Hill Crest
    KT13 8AS Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    93 Hill Crest
    KT13 8AS Weybridge
    Surrey
    IrishDirector13861940001
    GISBY, Robin William
    47 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Amministratore
    47 Frewin Road
    SW18 3LR London
    BritishCompany Director20233460001
    HARDIMAN, Peter Michael Joseph
    31 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    Amministratore
    31 Claybank Drive
    Tottington
    BL8 4BU Bury
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector47304300001
    HARDIMAN, Peter Joseph
    12 De Burgh Place
    Clare
    CO10 8QL Sudbury
    Suffolk
    Amministratore
    12 De Burgh Place
    Clare
    CO10 8QL Sudbury
    Suffolk
    BritishSteel Stockholder15800740001
    HARDING, Ian
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant35278190002
    HARTLEY, Edwin Bennett
    8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    BritishSteel Stockholder6118800001
    HUNT, Richard John
    1 Rawlings Court
    MK17 9QB Woburn
    Bedfordshire
    Amministratore
    1 Rawlings Court
    MK17 9QB Woburn
    Bedfordshire
    United KingdomBritishCompany Director87620300001
    JENKINS, Patrick John
    16 Ripley Road
    Willesborough
    TN24 0JP Ashford
    Kent
    Amministratore
    16 Ripley Road
    Willesborough
    TN24 0JP Ashford
    Kent
    BritishSteel Stockholder15800750001
    JONES, Timothy Charles
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector81110720001
    KENNEDY, James Mcmillan
    63 Arden Grove
    Kilsyth
    G65 9LZ Glasgow
    Amministratore
    63 Arden Grove
    Kilsyth
    G65 9LZ Glasgow
    BritishDirector47128910001
    LEE, Malcolm Stuart
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    Orchard Gate, Ashley Hill Place
    Cockpole Green
    RG10 8NL Wargrave
    Berkshire
    BritishGroup Finance Director12264540006
    LYNCH, Valerie Ann
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    Amministratore
    6 Charvil House Road
    Charvil
    RG10 9RD Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Secretary68872030002
    MARRIOTT, David Ernest Staines
    7 Alwyne Avenue
    Shenfield
    CM15 8QT Brentwood
    Essex
    Amministratore
    7 Alwyne Avenue
    Shenfield
    CM15 8QT Brentwood
    Essex
    BritishAccountant15800710001
    MCDONALD, Andrew John
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    Amministratore
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    EnglandBritishCompany Secretary164670820001
    PARKES, David George
    Bowling Green House
    Evenley
    NN13 5SA Brackley
    Northamptonshire
    Amministratore
    Bowling Green House
    Evenley
    NN13 5SA Brackley
    Northamptonshire
    BritishSteel Stockholder43077220001
    RAE, Douglas Keith
    Millview Farm
    Mark Lane Fulwood
    S10 4PY Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Millview Farm
    Mark Lane Fulwood
    S10 4PY Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSteel Stockholder35386640001
    RAE, Ian Bell
    1 Elm Grove Park
    Broughty Ferry
    DD5 3QW Dundee
    Angus
    Amministratore
    1 Elm Grove Park
    Broughty Ferry
    DD5 3QW Dundee
    Angus
    United KingdomBritishSteel Stockholder15800700002
    RINGROSE, Adrian Michael
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Interserve House
    Ruscombe Park Twyford
    RG10 9JU Reading
    Berkshire
    EnglandBritishDirector232006700001
    RUTTER, Richard Charles
    27 Clifton Road
    SO22 5BU Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    27 Clifton Road
    SO22 5BU Winchester
    Hampshire
    BritishDirector72723760003

    Chi sono le persone con controllo significativo di BANDT PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bandt Holdings Limited
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    06 apr 2016
    91 Waterloo Road
    SE1 8RT London
    Capital Tower
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUk Company Law
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03064794
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    BANDT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2020
    Consegnato il 15 mar 2020
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 mar 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 mag 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 14 ott 2019
    Consegnato il 23 ott 2019
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 23 ott 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 mag 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 15 mar 2019
    Consegnato il 19 mar 2019
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 mar 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 mag 2020Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 01 mag 2018
    Consegnato il 03 mag 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Glas Trust Corporation Limited (As Security Agent & Trustee for Secured Parties)
    Transazioni
    • 03 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 mar 1998
    Consegnato il 25 mar 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 11 set 1996
    Consegnato il 11 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (or any of them) under or pursuant to the finance documents and all other liabilities, actual or contingent, now existing or hereafter incurred by the company under or pursuant to any of the finance documents
    Brevi particolari
    By way of first ranking legal mortgage all of the property being f/h- land lying to west of muklow hill halesowen dudley west midlands t/n-WM564678. F/h land being land and buildings on the northerly side of ambrose street openshaw manchester greater manchester t/n-GM704892 together with all buildings trade and other fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 11 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 21 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each "chargor" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 08 mag 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 14 ago 1997Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust agreement
    Creato il 29 giu 1995
    Consegnato il 06 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the "obligors" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined
    Brevi particolari
    The trust property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 06 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trust agreement
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 28 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the operative documents as defined
    Brevi particolari
    The trust property being the rights and the proceeds as defined see form 395 ref M557C.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 28 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 ott 1992
    Consegnato il 16 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the operative documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including book debts (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 16 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of off set
    Creato il 25 apr 1989
    Consegnato il 15 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 20 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ott 1981
    Consegnato il 16 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital all buildings fixtures fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0