BANDT PROPERTIES LIMITED
Panoramica
Nome della società | BANDT PROPERTIES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00124326 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BANDT PROPERTIES LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova BANDT PROPERTIES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BANDT PROPERTIES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BROWN & TAWSE LIMITED | 09 giu 1986 | 09 giu 1986 |
G.B.PARKES,LIMITED | 19 set 1912 | 19 set 1912 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BANDT PROPERTIES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per BANDT PROPERTIES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2022 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 05 ago 2022
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale al 25 lug 2022
| 6 pagine | SH19 | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 29 giu 2021 al 28 giu 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 29 dic 2020 al 29 giu 2021 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Jeremy Mark White come amministratore in data 29 lug 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anthony Kenneth Smythe come amministratore in data 30 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come amministratore in data 04 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher James Edwards come amministratore in data 03 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come segretario in data 02 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 dic 2019 al 29 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Bandt Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 dic 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Interserve House Ruscombe Park Twyford Reading Berkshire RG10 9JU a Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT in data 04 dic 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 17 ago 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 001243260010 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 001243260012 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BANDT PROPERTIES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDWARDS, Christopher James | Amministratore | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | General Counsel And Corporate Secretary | 279311610001 | ||||
WHITE, Jeremy Mark | Amministratore | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Chartered Accountant | 284537740001 | ||||
ASHFORTH, Phillip John | Segretario | Woodside 17 Garth Road TN13 1RT Sevenoaks Kent Kent | British | 1311000004 | ||||||
BRADBURY, Trevor | Segretario | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | British | 47884750003 | ||||||
BUSH, Daniel | Segretario | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | 241570590001 | |||||||
BUTLER, Richard John | Segretario | 23a Wharf Hill SO23 9NQ Winchester Hampshire | British | 62923710002 | ||||||
HARDING, Ian | Segretario | Jasmine Cottage Eglinton Road Tilford GU10 2DH Farnham Surrey | British | Chartered Accountant | 35278190002 | |||||
MCDONALD, Andrew John | Segretario | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | 249821440001 | |||||||
ASHFORTH, Phillip John | Amministratore | Woodside 17 Garth Road TN13 1RT Sevenoaks Kent Kent | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 1311000004 | ||||
BRADBURY, Trevor | Amministratore | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Company Secretary | 47884750003 | ||||
BRETT, Alan John | Amministratore | A 15 Park Lane Old Basing RG24 7HF Basingstoke Hampshire | British | Steel Stockholder | 124080001 | |||||
BRIERLEY, John | Amministratore | 23 Strawberry Lane SK9 6AQ Wilmslow Cheshire | British | Steel Stockholder | 15800730001 | |||||
BUSH, Daniel | Amministratore | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Solicitor | 182845350001 | ||||
CLITHEROE, David Maurice | Amministratore | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | Chartered Accountant | 49800090001 | |||||
FELL, James Thomas | Amministratore | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Group Financial Controller | 178128810002 | ||||
FORD, William | Amministratore | The Old School House 4 Vine Court Road TN13 3UU Sevenoaks Kent | British | Company Director | 47272920001 | |||||
GASPARRO, Christopher Nicholas | Amministratore | 93 Hill Crest KT13 8AS Weybridge Surrey | Irish | Director | 13861940001 | |||||
GISBY, Robin William | Amministratore | 47 Frewin Road SW18 3LR London | British | Company Director | 20233460001 | |||||
HARDIMAN, Peter Michael Joseph | Amministratore | 31 Claybank Drive Tottington BL8 4BU Bury Lancashire | United Kingdom | British | Director | 47304300001 | ||||
HARDIMAN, Peter Joseph | Amministratore | 12 De Burgh Place Clare CO10 8QL Sudbury Suffolk | British | Steel Stockholder | 15800740001 | |||||
HARDING, Ian | Amministratore | Jasmine Cottage Eglinton Road Tilford GU10 2DH Farnham Surrey | England | British | Chartered Accountant | 35278190002 | ||||
HARTLEY, Edwin Bennett | Amministratore | 8 Mainwaring Road Over Peover WA16 8TR Knutsford Cheshire | British | Steel Stockholder | 6118800001 | |||||
HUNT, Richard John | Amministratore | 1 Rawlings Court MK17 9QB Woburn Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 87620300001 | ||||
JENKINS, Patrick John | Amministratore | 16 Ripley Road Willesborough TN24 0JP Ashford Kent | British | Steel Stockholder | 15800750001 | |||||
JONES, Timothy Charles | Amministratore | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Director | 81110720001 | ||||
KENNEDY, James Mcmillan | Amministratore | 63 Arden Grove Kilsyth G65 9LZ Glasgow | British | Director | 47128910001 | |||||
LEE, Malcolm Stuart | Amministratore | Orchard Gate, Ashley Hill Place Cockpole Green RG10 8NL Wargrave Berkshire | British | Group Finance Director | 12264540006 | |||||
LYNCH, Valerie Ann | Amministratore | 6 Charvil House Road Charvil RG10 9RD Reading Berkshire | England | British | Company Secretary | 68872030002 | ||||
MARRIOTT, David Ernest Staines | Amministratore | 7 Alwyne Avenue Shenfield CM15 8QT Brentwood Essex | British | Accountant | 15800710001 | |||||
MCDONALD, Andrew John | Amministratore | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | England | British | Company Secretary | 164670820001 | ||||
PARKES, David George | Amministratore | Bowling Green House Evenley NN13 5SA Brackley Northamptonshire | British | Steel Stockholder | 43077220001 | |||||
RAE, Douglas Keith | Amministratore | Millview Farm Mark Lane Fulwood S10 4PY Sheffield South Yorkshire | British | Steel Stockholder | 35386640001 | |||||
RAE, Ian Bell | Amministratore | 1 Elm Grove Park Broughty Ferry DD5 3QW Dundee Angus | United Kingdom | British | Steel Stockholder | 15800700002 | ||||
RINGROSE, Adrian Michael | Amministratore | Interserve House Ruscombe Park Twyford RG10 9JU Reading Berkshire | England | British | Director | 232006700001 | ||||
RUTTER, Richard Charles | Amministratore | 27 Clifton Road SO22 5BU Winchester Hampshire | British | Director | 72723760003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BANDT PROPERTIES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandt Holdings Limited | 06 apr 2016 | 91 Waterloo Road SE1 8RT London Capital Tower England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
BANDT PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 27 feb 2020 Consegnato il 15 mar 2020 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 14 ott 2019 Consegnato il 23 ott 2019 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 15 mar 2019 Consegnato il 19 mar 2019 | In corso | ||
Breve descrizione N/A. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 01 mag 2018 Consegnato il 03 mag 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Not applicable. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 mar 1998 Consegnato il 25 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental charge | Creato il 11 set 1996 Consegnato il 11 set 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (or any of them) under or pursuant to the finance documents and all other liabilities, actual or contingent, now existing or hereafter incurred by the company under or pursuant to any of the finance documents | |
Brevi particolari By way of first ranking legal mortgage all of the property being f/h- land lying to west of muklow hill halesowen dudley west midlands t/n-WM564678. F/h land being land and buildings on the northerly side of ambrose street openshaw manchester greater manchester t/n-GM704892 together with all buildings trade and other fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite debenture | Creato il 29 giu 1995 Consegnato il 06 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each "chargor" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust agreement | Creato il 29 giu 1995 Consegnato il 06 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each of the "obligors" as defined therein to the chargee under or pursuant to the finance documents as defined | |
Brevi particolari The trust property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Trust agreement | Creato il 09 ott 1992 Consegnato il 28 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the operative documents as defined | |
Brevi particolari The trust property being the rights and the proceeds as defined see form 395 ref M557C. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 09 ott 1992 Consegnato il 16 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the operative documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over all undertaking property and assets including book debts (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Letter of off set | Creato il 25 apr 1989 Consegnato il 15 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 ott 1981 Consegnato il 16 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital all buildings fixtures fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0