DISC DISTRIBUTION LIMITED

DISC DISTRIBUTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDISC DISTRIBUTION LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00125787
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    • (6312) /
    • (7415) /

    Dove si trova DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    242 Marylebone Road
    London
    NW1 6JL
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VCI UK LIMITED25 giu 199625 giu 1996
    STRAND VCI UK LIMITED29 ott 198429 ott 1984
    PRESTWICH PARKER HOLDINGS P.L.C.31 dic 198131 dic 1981
    PRESTWICH PARKER LIMITED07 dic 191207 dic 1912

    Quali sono gli ultimi bilanci di DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 gen 2012
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 ott 2012
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2011

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al28 dic 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma11 gen 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Bilancio redatto al 31 gen 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 mar 2011

    Stato del capitale al 21 mar 2011

    • Capitale: GBP 9,167,313.5
    SH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2010

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 gen 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 02 feb 2008

    14 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    annual-return18 giu 2008

    legacy

    363(353)

    legacy

    15 pagine395

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Facility agree 29/01/08
    RES13

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 03 feb 2007

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    7 pagine363s

    Chi sono gli amministratori di DISC DISTRIBUTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EAST, Stephen John
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    Amministratore
    White Ladies
    Birch Hill Shirley Hills
    CR0 5HT Surrey
    EnglandBritish108586450001
    BISH JONES, Trevor Charles
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    Segretario
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    British89529490001
    BLOOM, Jonathan Simon
    8 Wavel Mews
    South Hampstead
    NW6 3AB London
    Segretario
    8 Wavel Mews
    South Hampstead
    NW6 3AB London
    British78140960001
    CHASTON, David Carl Anthony
    67 Darlands Drive
    EN5 2DE Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    67 Darlands Drive
    EN5 2DE Barnet
    Hertfordshire
    British55677580003
    HARVEY, George Kenneth
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    Segretario
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    British17771640001
    PRAILL, Penelope
    5 Trout Hollow Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    5 Trout Hollow Bledlow Road
    Saunderton
    HP27 9UA Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British57322940001
    SCHOFIELD, Brian Beaumont
    Badgers Bigfrith Lane
    Cookham
    SL6 9UQ Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Badgers Bigfrith Lane
    Cookham
    SL6 9UQ Maidenhead
    Berkshire
    British47050440001
    SCOTT, Christopher David
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    Segretario
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    British118895720002
    SWENY, Susan
    36 Halifax Street
    Sydenham
    SE26 6JA London
    Segretario
    36 Halifax Street
    Sydenham
    SE26 6JA London
    British85387430001
    AYRES, Stephen Thomas
    Charringworth Grange
    GL55 6XY Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Charringworth Grange
    GL55 6XY Chipping Campden
    Gloucestershire
    United KingdomBritish66870470001
    BAYLISS, Colin Charles Macarthur
    2038 Channelford Road
    CA 91361 Westlake Village
    California
    Amministratore
    2038 Channelford Road
    CA 91361 Westlake Village
    California
    British68243990002
    BISH JONES, Trevor Charles
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    Amministratore
    Salford Manor
    Wavendon Road, Salford
    MK17 8BB Milton Keynes
    United KingdomBritish89529490001
    BROOMAN, Richard John
    27 Rivermead Court
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    27 Rivermead Court
    Marlow Bridge Lane
    SL7 1SJ Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish11328600001
    BURGESS, Mark Geoffrey William
    5 The Ridgway
    Mount Ararat Road
    TW10 6PR Richmond
    Surrey
    Amministratore
    5 The Ridgway
    Mount Ararat Road
    TW10 6PR Richmond
    Surrey
    British28476620002
    CLARKE, Roger Grenville Quinton
    Whitebeam
    Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    Amministratore
    Whitebeam
    Wainhill
    OX39 4AB Chinnor
    Oxfordshire
    British63850730001
    DUNLEAVY, Ivan Patrick
    Bois Heath Farm
    Watchet Lane Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Bois Heath Farm
    Watchet Lane Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    British17771660002
    GREEN, Richard John
    Aston House
    12a Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Aston House
    12a Stratton Road
    HP9 1HR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish41785690003
    HANKS, Terence James
    Holcombe
    Crown Lane
    SL2 3SF Farnham Royal
    Bucks
    Amministratore
    Holcombe
    Crown Lane
    SL2 3SF Farnham Royal
    Bucks
    British21917480001
    HARVEY, George Kenneth
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    22 Hillcroft Avenue
    HA5 5AW Pinner
    Middlesex
    British17771640001
    HEMBURY, Paul Brian
    St Margarets House
    St Margarets
    HP1 3BZ Great Gaddesden
    Hertfordshire
    Amministratore
    St Margarets House
    St Margarets
    HP1 3BZ Great Gaddesden
    Hertfordshire
    EnglandBritish34925020002
    HYNDMAN, Ruth Jennifer
    15 Cedars Road
    SW13 0HP London
    Amministratore
    15 Cedars Road
    SW13 0HP London
    British34562530002
    OGILVIE, Alasdair Mcdonald
    11 Gibsons Road
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Gibsons Road
    SK4 4JX Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish67412910001
    ROBERTS, David Benjamin
    Thatched Cottage
    Rake Lane Milford
    GU8 5AB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Thatched Cottage
    Rake Lane Milford
    GU8 5AB Godalming
    Surrey
    EnglandBritish49657510003
    ROGERS, Christopher Charles Bevan
    Mill House
    Turville
    RG9 6QL Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mill House
    Turville
    RG9 6QL Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish34678510004
    SANKEY, Brian William
    21 Parkland Avenue
    RM14 2HA Upminster
    Essex
    Amministratore
    21 Parkland Avenue
    RM14 2HA Upminster
    Essex
    British17771680001
    SCHOLFIELD, Brian Beaumont
    Badgers Bigfrith Lane
    SL6 9UQ Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Badgers Bigfrith Lane
    SL6 9UQ Cookham Dean
    Berkshire
    British55318250001
    SCOTT, Christopher David
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    Amministratore
    Copenhagen Street
    N1 0JD London
    2b
    British118895720002
    TOOMEY, Thomas Patrick
    23 Hillrise
    SL9 9BN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Amministratore
    23 Hillrise
    SL9 9BN Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British114191860001
    WILLITS, Giles Kirkley
    11 Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    Amministratore
    11 Buckingham Street
    WC2N 6DF London
    United KingdomBritish123734120001

    DISC DISTRIBUTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 30 gen 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge all sums due or to become due
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Finance PLC as Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 set 2000
    Consegnato il 07 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date and the rent deposit deed
    Brevi particolari
    The deposit sum is £24,510 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Developments Limited
    Transazioni
    • 07 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 09 feb 2000
    Consegnato il 14 feb 2000
    In corso
    Importo garantito
    The performance of the company's (the tenant) obligations to the chargee in a lease of even date and this deed
    Brevi particolari
    A separate interest bearing designated business premium account in the name of the chargee's managing agents,pilcher hershman re: disc distribution limited rent deposit account containing £139,188 or such funds as may from time to time stand to the credit of the account.
    Persone aventi diritto
    • Derwent Valley Property Developments Limited
    Transazioni
    • 14 feb 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of variation supplemental to debenture of even date
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 12 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the original debenture
    Brevi particolari
    Floating charge such of the company's property as shall from time to time be subject to legal charges in favour of the chargee but not otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 12 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 04 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 76 dean street city of westminster t/n NGL129044. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 lug 1998
    Consegnato il 04 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 04 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ott 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 11 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    L/Hold land/blds known as 1 watford business park,caxton way,watford,hertfordshire,barnet; t/no hd 264019 and unit 12,brunswick park estate,brunswick park rd,new southgate,barnet; ngl 385108; see form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Paribas,as Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 11 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 04 ott 1995
    Consegnato il 05 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of each finance document to which each obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Samuel Montagu & Co.Limited
    Transazioni
    • 05 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 giu 1994
    Consegnato il 20 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due friom the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facility agreement and this deed both dated 9TH june 1994
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 apr 1990
    Consegnato il 26 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and turstee for the beneficianies (s defined) under the terms of a guarantee of even date.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 21 giu 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee debenture
    Creato il 27 feb 1989
    Consegnato il 06 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 22 feb 1989
    Consegnato il 28 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 11 ott 1982
    Consegnato il 27 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charg on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capitl.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1982Registrazione di un'ipoteca

    DISC DISTRIBUTION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 dic 2011Data della petizione
    05 mar 2014Conclusione della liquidazione
    06 feb 2012Inizio della liquidazione
    11 giu 2014Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS
    Praticante
    21 Bloomsbury Street
    London
    WC1B 3SS

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0