COE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00128467
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COE GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova COE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COE GROUP PLC28 mag 200328 mag 2003
    TIMELOAD PLC01 ago 200201 ago 2002
    SCOOT.COM PLC22 feb 199922 feb 1999
    FREEPAGES GROUP PLC26 feb 199626 feb 1996
    BLAGG PLC.31 mar 199431 mar 1994
    C.C.S. GROUP PLC29 mar 198929 mar 1989
    BLUEMEL BROS PUBLIC LIMITED COMPANY23 mar 198923 mar 1989

    Quali sono gli ultimi bilanci di COE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per COE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Thruvision 121, Olympic Avenue Milton Abingdon OX14 4SA England a 1 More London Place London SE1 2AF in data 29 dic 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 15 dic 2021

    LRESSP

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 121 Olympic Avenue Milton Park Abingdon OX14 4SA

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Thruvision, 2 Saxton, Parklands Railton Road Guildford Surrey GU2 9JX United Kingdom a 121 Olympic Avenue Milton Park Abingdon OX14 4SA

    2 pagineAD02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Evans il 19 ago 2021

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Stato del capitale al 13 nov 2020

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 27/10/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Evans il 03 nov 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    6 pagineAA

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Digital Barriers 2-3 Parklands Railton Road Guildford Surrey GU2 9JX England a C/O Thruvision, 2 Saxton, Parklands Railton Road Guildford Surrey GU2 9JX

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Digital Barriers 121 Olympic Avenue Milton Park, Milton Abingdon Oxon OX14 4SA England a C/O Thruvision 121, Olympic Avenue Milton Abingdon OX14 4SA in data 19 lug 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Digital Barriers Plc come persona con controllo significativo il 01 nov 2017

    2 paginePSC06

    Nomina di Mr John Andrew Woollhead come amministratore in data 01 nov 2017

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di COE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WOOLLHEAD, John Andrew
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Segretario
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    154511690001
    EVANS, Colin
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishDirector154520370003
    WOOLLHEAD, John Andrew
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritishCompany Secretary13072060002
    BONNIER, Robert Johan Henri
    Flat 3 73 Holland Park
    W11 3SL London
    Segretario
    Flat 3 73 Holland Park
    W11 3SL London
    BritishChief Financial Officer44509120001
    CAFFREY, Ronald Joseph
    1 Newnham Manor
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EH Wallingford
    Oxfordshire
    Segretario
    1 Newnham Manor
    Crowmarsh Gifford
    OX10 8EH Wallingford
    Oxfordshire
    British58677890001
    DORJEE, Ronald
    Pijlstraat 1d
    1411 Re Naarden-Vesting
    The Netherlands
    Segretario
    Pijlstraat 1d
    1411 Re Naarden-Vesting
    The Netherlands
    DutchChief Financial Officer58589480002
    FRANCIS, Victoria Mary
    66 Deanhill Court
    Upper Richmond Road
    SW14 7DL London
    Segretario
    66 Deanhill Court
    Upper Richmond Road
    SW14 7DL London
    British51164670001
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Segretario
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    BritishAccountant17429220001
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Segretario
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    BritishAccountant17429220001
    GRIFFITHS, Derek Gordon
    250 Henwood Lane
    Catherine De Barnes
    B91 2SY Solihull
    West Midlands
    Segretario
    250 Henwood Lane
    Catherine De Barnes
    B91 2SY Solihull
    West Midlands
    British44646720001
    JEFFERSON, Ian David
    5 Backhouse Lane
    Woolley
    WF4 2LB Wakefield
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Backhouse Lane
    Woolley
    WF4 2LB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector80245080002
    SANDPEARL, Michael Barry
    9 The Moorings
    Harrogate Road
    LS17 8EN Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    9 The Moorings
    Harrogate Road
    LS17 8EN Leeds
    West Yorkshire
    BritishManager91253280001
    TEMPLE MORRIS, Suzanna Marjan
    12a Penzance Place
    W11 4PA London
    Segretario
    12a Penzance Place
    W11 4PA London
    British78597560002
    AKERS, Chris
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    Amministratore
    22a Launceston Place
    W8 5RL London
    BritishDirector77057180001
    ALLOTT, Stephen Antony
    21 Clapham Common West Side
    SW4 9AN London
    Amministratore
    21 Clapham Common West Side
    SW4 9AN London
    EnglandBritishDirector47377340002
    BERGH VAN DEN, Robert
    Willemslaan 12
    1406 LW Bussum
    Netherlands
    Amministratore
    Willemslaan 12
    1406 LW Bussum
    Netherlands
    DutchDirector51776010001
    BOARDMAN, Allan
    12 Goodwood Close
    Roby Grange
    L36 4QL Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    12 Goodwood Close
    Roby Grange
    L36 4QL Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritishMerchandising Director44468710001
    BONNIER, Robert Johan Henri
    39 Royal Crescent
    W11 4SN London
    Amministratore
    39 Royal Crescent
    W11 4SN London
    DutchChief Financial Officer44509120003
    CHARKIN, Richard Denis Paul
    3 Redcliffe Place
    SW10 9DB London
    Amministratore
    3 Redcliffe Place
    SW10 9DB London
    United KingdomBritishPublisher22140670002
    CHEDGZOY, Christopher Ronald
    The Malt House Evesham Road
    Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    The Malt House Evesham Road
    Cookhill
    B49 5LJ Alcester
    Warwickshire
    United KingdomBritishTechnology Officer73826560002
    COOK, John Bradford
    Stillingfleet Lodge
    Stillingfleet
    YO19 6HP York
    Yorks
    Amministratore
    Stillingfleet Lodge
    Stillingfleet
    YO19 6HP York
    Yorks
    BritishInvestment Manager1819370001
    DE SMEDT, Mark
    Voerhoek 29
    Tervuren
    3080
    Belgium
    Amministratore
    Voerhoek 29
    Tervuren
    3080
    Belgium
    BelgianChief Operating Officer Scoot72102550001
    DOFFMAN, Zak
    121 Olympic Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SA Abingdon
    C/O Digital Barriers
    Oxon
    England
    Amministratore
    121 Olympic Avenue
    Milton Park, Milton
    OX14 4SA Abingdon
    C/O Digital Barriers
    Oxon
    England
    United KingdomBritishDirector146648120001
    DORJEE, Ronald
    Pijlstraat 1d
    1411 Re Naarden-Vesting
    The Netherlands
    Amministratore
    Pijlstraat 1d
    1411 Re Naarden-Vesting
    The Netherlands
    DutchChief Financial Officer58589480002
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector93041580001
    EYKEL, Dick
    Brusselselann 8
    2587
    Ah Den Haag
    The Netherlands
    Amministratore
    Brusselselann 8
    2587
    Ah Den Haag
    The Netherlands
    DutchCompany Director51775900002
    FELLOWS, Keith Roger
    23 The Chase
    Wylde Green
    B76 1JS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    23 The Chase
    Wylde Green
    B76 1JS Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishGroup Finance Director40198270002
    FIELDING, Alison Margaret, Dr
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    Amministratore
    Cornhill
    EC3V 3ND London
    24
    EnglandBritishDirector73415280001
    FRANK, Boulben
    2 Rue De Villesexel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    Amministratore
    2 Rue De Villesexel
    FOREIGN Paris
    75007
    France
    FrenchChief Executive Officer Viven73697950002
    GLASS, Colin
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Fairway
    LS17 7PD Leeds
    66
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant17429220001
    GRIFFITHS, Derek Gordon
    250 Henwood Lane
    Catherine De Barnes
    B91 2SY Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    250 Henwood Lane
    Catherine De Barnes
    B91 2SY Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director44646720001
    HOLGATE, Nicholas James
    c/o Digital Barriers
    Hatfields
    SE1 9PG London
    1-2
    England
    Amministratore
    c/o Digital Barriers
    Hatfields
    SE1 9PG London
    1-2
    England
    United KingdomBritishFinance Director181596610001
    JEFFERSON, Ian David
    5 Backhouse Lane
    Woolley
    WF4 2LB Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Backhouse Lane
    Woolley
    WF4 2LB Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector80245080002
    LAWRENCE, Thomas James
    6 Cambridge Place
    W8 5PB London
    Amministratore
    6 Cambridge Place
    W8 5PB London
    BritishConsultant11840670001
    MARRIAGE, Mark Francis
    Park Avenue
    Thackley
    BD10 0RJ Bradford
    16
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Avenue
    Thackley
    BD10 0RJ Bradford
    16
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector132087840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di COE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Thruvision Group Plc
    Olympic Avenue
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    121
    England
    30 giu 2016
    Olympic Avenue
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    121
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleEnglish Law
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 lug 2008
    Consegnato il 18 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • IP2IPO Limited
    Transazioni
    • 18 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 mag 2003
    Consegnato il 31 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a timeload PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 31 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 09 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of the rent deposit deed together with any accrued interest.
    Persone aventi diritto
    • Tameside Metropolitan Borough Council
    Transazioni
    • 09 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 16 ago 2001
    Consegnato il 30 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the letter agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dmg Finance Limited
    Transazioni
    • 30 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 14 giu 2001
    Consegnato il 29 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date and the rent deposit deed
    Brevi particolari
    First fixed charge the initial rent deposit being £104,976.85 and all other sums paid and all interest in the single interest bearing account number 20344544.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Canada Trust Company (Jersey) Limited
    Transazioni
    • 29 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over loan nore guarantee security account
    Creato il 31 lug 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as a result of the guaranteeing bank issuing the guarantee
    Brevi particolari
    All right,title and interest in the loan note guarantee security account and the charged balance, as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 mar 2000
    Consegnato il 17 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease dated 15 march 2000
    Brevi particolari
    £341996.00 an interest bearing account in the name of the tenant and specifically designated "beaufort house, cricketfield road, uxbridge deposit account.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Life Assurance Company
    Transazioni
    • 17 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Single debenture
    Creato il 22 set 1993
    Consegnato il 06 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 ott 1990
    Consegnato il 11 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H unit 7D heming road, washford industrial estate redditch, worcestershire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 ott 1990
    Consegnato il 11 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 14 market street, hednesford staffs.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 04 ott 1990
    Consegnato il 11 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H bon marche yard rugeley road hednesford staffs.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 25 mag 1989
    Consegnato il 01 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off
    Creato il 26 gen 1985
    Consegnato il 01 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present & future account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set-off
    Creato il 19 mag 1982
    Consegnato il 26 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Single debenture
    Creato il 18 mag 1982
    Consegnato il 25 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at walston west midlands. Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 1982Registrazione di un'ipoteca

    COE GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 dic 2021Inizio della liquidazione
    16 mag 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Praticante
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0