MORRISFLEX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMORRISFLEX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00134022
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MORRISFLEX LIMITED?

    • produzione di prodotti abrasivi (23910) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MORRISFLEX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Spring Road
    Ibstock
    LE67 6LR Leicestershire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MORRISFLEX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOLBORN ENGINEERS LIMITED17 feb 191417 feb 1914

    Quali sono gli ultimi bilanci di MORRISFLEX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per MORRISFLEX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 apr 2017

    9 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 21 dic 2016

    8 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:resolution re. Powers of liquidator
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 dic 2015

    LRESSP

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 ago 2015

    Stato del capitale al 26 ago 2015

    • Capitale: GBP 84,908
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 99 Commercial Square Freemens Common Leicester Leicestershire LE2 7SR a Spring Road Ibstock Leicestershire LE67 6LR in data 04 feb 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2014

    Stato del capitale al 06 ago 2014

    • Capitale: GBP 84,908
    SH01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 ago 2013

    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    15 pagineAA

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    44 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Cessazione della carica di Richard Mayers come amministratore

    2 pagineTM01

    legacy

    16 pagineMG01

    Nomina di Richard Mayers come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Paul Moore come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Crowley come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MORRISFLEX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GARLAND, Anne
    Kileshandra
    Druminiskill
    Cavan
    Ireland
    Segretario
    Kileshandra
    Druminiskill
    Cavan
    Ireland
    Irish137648650001
    COSGROVE, Peter
    Fortfield Drive
    Terenure
    Dublin
    31
    Ireland
    Amministratore
    Fortfield Drive
    Terenure
    Dublin
    31
    Ireland
    IrelandIrishDirector129613430001
    MOORE, Paul Gerard
    Simmonstown Park
    Celbridge
    3
    Kildare
    Ireland
    Amministratore
    Simmonstown Park
    Celbridge
    3
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director53224850001
    HOBDAY, Alan Arthur
    69 Tilehouse Green Lane
    Knowle
    B93 9EU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    69 Tilehouse Green Lane
    Knowle
    B93 9EU Solihull
    West Midlands
    British33984620001
    LEMOND, Brian Hugh
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Segretario
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector490160004
    LYNCH, Carmel
    Virginia
    County Cavan
    Rahardrum
    Ireland
    Segretario
    Virginia
    County Cavan
    Rahardrum
    Ireland
    BritishNone130841320001
    MCGOWAN, Neil
    Killeen Road
    Rathmines
    37
    Dublin 6
    Ireland
    Segretario
    Killeen Road
    Rathmines
    37
    Dublin 6
    Ireland
    British128891990001
    THEAKER, Jeremy Robert
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    Segretario
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    British65284290001
    THEAKER, Jeremy Robert
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    Segretario
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    British65284290001
    AGNEW, Paul Raymond Barratt
    19 Druids Court
    Newtown Mount Kennedy
    Co. Wicklow
    Eire
    Amministratore
    19 Druids Court
    Newtown Mount Kennedy
    Co. Wicklow
    Eire
    GermanyBritishDirector94248530001
    CROWLEY, Peter Magner
    Sloperton Lodge
    Sloperton
    IRISH Monkstown
    Co. Dublin
    Amministratore
    Sloperton Lodge
    Sloperton
    IRISH Monkstown
    Co. Dublin
    IrelandIrishDirector122150210001
    EVANS, Richard Anthony
    11 Home Farm Close
    Witherley
    CV9 3SP Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    11 Home Farm Close
    Witherley
    CV9 3SP Atherstone
    Warwickshire
    BritishMarketing Director16187070001
    GATHERCOLE, John Robert
    30 Wolsey Road
    CV22 6LW Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    30 Wolsey Road
    CV22 6LW Rugby
    Warwickshire
    BritishEngineering Director16187050001
    GOULD, Ian David
    101 Frobisher Road
    CV3 6LZ Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    101 Frobisher Road
    CV3 6LZ Coventry
    West Midlands
    BritishOperations Director82574090001
    GRAINGER, Laurence Douglas
    Mid Balfunning Farm
    Balfron Station Balfron
    G33 0NF Glasgow
    Amministratore
    Mid Balfunning Farm
    Balfron Station Balfron
    G33 0NF Glasgow
    ScotlandBritishDirector52231560001
    LEMOND, Brian Hugh
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector490160004
    LIBBY, Terence Allan
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director16187060001
    LIBBY, Terence Allan
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director16187060001
    MAYERS, Richard Daniel
    Allfarthing Lane
    SW18 6PQ London
    14
    England
    Amministratore
    Allfarthing Lane
    SW18 6PQ London
    14
    England
    EnglandBritishChartered Accountant183644580001
    MCGARRY, Nicholas Scott
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomEnglishDirector130841260002
    MCGARRY, Nicholas Scott
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    Amministratore
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomEnglishSales Director130841260002
    WILSON, William Stuart
    M/S Oilfields Supply Centre
    Jebel Ali Building No 24 PO BOX 1518
    Dubai
    United Arab Emirates
    Amministratore
    M/S Oilfields Supply Centre
    Jebel Ali Building No 24 PO BOX 1518
    Dubai
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesBritishDirector78390007

    MORRISFLEX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 05 mar 2013
    Consegnato il 15 mar 2013
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors
    Brevi particolari
    Grand building 1-3 strand london fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mml Capital Europe V Sa
    Transazioni
    • 15 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 set 2012
    Consegnato il 02 ott 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC
    Transazioni
    • 02 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2008
    Consegnato il 04 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 04 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 23 dic 2005
    Consegnato il 07 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 apr 1997
    Consegnato il 22 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Used unison 2600 fgs mini tool grinder serial number 138.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 31 dic 1996
    Consegnato il 03 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    The following property :- unison model 8,000 cnc flute grinding machine serial no 059 and the proceeds and produects thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC Together with Royscot's Successors (As Defined)
    Transazioni
    • 03 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stage payment agreement
    Creato il 07 giu 1996
    Consegnato il 11 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this agreement being a maximum of £168,619.00 plus interest thereon
    Brevi particolari
    Floating charge all the company's right title and interest from time to time in the following goods and each part thereof: the goods being unison model 8,000 cnc flute grinding machine, serial no. 059.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 04 apr 1995
    Consegnato il 07 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Unison model 8000 cnc flute grinding machine serial N0 048. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 07 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stage payment agreement
    Creato il 13 ott 1994
    Consegnato il 27 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All the companys rights title and interest in the following goods and each part thereof:- unison model 8,000 cnc flute grinding machine serial no 048. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 27 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 dic 1989
    Consegnato il 20 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 dic 1989
    Consegnato il 13 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Brown & ward model af-874A1 (please see 395 M317 for details of further plant machinery & chattels) together with all additions alterations accessories replacements and renewals.
    Persone aventi diritto
    • 3I PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 17 ott 1988
    Consegnato il 18 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One new model 8000-5 axis burr grinder (nc tool & cutter) serial number 8000-010.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 18 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 17 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 19 lug 1988
    Consegnato il 29 lug 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1988Registrazione di un'ipoteca
    Chattel mortgage
    Creato il 15 lug 1987
    Consegnato il 22 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All property detailed on form 395 relevant to this charge.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee &
    Creato il 10 giu 1987
    Consegnato il 17 giu 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 giu 1987Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental legal charge
    Creato il 29 giu 1983
    Consegnato il 30 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over book debts and other debts due and owing to the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 30 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 11 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee &
    Creato il 27 mag 1983
    Consegnato il 03 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or flexwheel limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 21 ott 1981
    Consegnato il 28 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 21 ott 1981
    Consegnato il 24 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    Transazioni
    • 24 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MORRISFLEX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 dic 2015Inizio della liquidazione
    15 ago 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brigid Daly
    One Spenser Dock North Wall Quay
    Dublin
    Ireland
    Praticante
    One Spenser Dock North Wall Quay
    Dublin
    Ireland

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0