DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED

DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00136916
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED10 mar 198910 mar 1989
    COMMERCIAL ADVERTISING SERVICE LIMITED10 lug 191410 lug 1914

    Quali sono gli ultimi bilanci di DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mar 2010

    Stato del capitale al 01 mar 2010

    • Capitale: GBP 794,336
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Janet Roscoe il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Peter Royston Brown il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Perry il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Daniel Turnbull il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Boyde il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed silverwood communications group LIMITED\certificate issued on 15/01/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 gen 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 ott 2007

    19 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    20 pagineAA

    legacy

    10 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Risoluzioni

    Resolutions
    pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Chi sono gli amministratori di DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FORGAN, Janet
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Segretario
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    British119207370006
    BOYDE, Neil
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Amministratore
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    United KingdomBritish138054240002
    BROWN, Peter Royston
    c/o Gyrohsr Limited
    Exchange Quay
    M5 3EQ Manchester
    8
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Gyrohsr Limited
    Exchange Quay
    M5 3EQ Manchester
    8
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish65800190006
    GLASSON, Richard Paul
    176 Broom Road
    TW11 9PQ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    176 Broom Road
    TW11 9PQ Teddington
    Middlesex
    British84491310002
    PERRY, Richard John
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Amministratore
    3rd Floor The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    EnglandBritish103104420002
    TURNBULL, Daniel
    c/o Gyrohsr Limited
    Exchange Quay
    M5 3EQ Manchester
    8
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Gyrohsr Limited
    Exchange Quay
    M5 3EQ Manchester
    8
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish110743660002
    KEIRL, Charles Ian
    19b Willow Tree Road
    WA14 2EQ Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    19b Willow Tree Road
    WA14 2EQ Altrincham
    Cheshire
    British25682680003
    THOMSON, George Barnes
    5 Wellgreen Close
    Hale Barns
    WA15 8PT Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    5 Wellgreen Close
    Hale Barns
    WA15 8PT Altrincham
    Cheshire
    British33934480001
    BAILEY, David
    Boxtree Cottage 40 Watling Street
    Affetside
    BL8 3QW Bury
    Lancashire
    Amministratore
    Boxtree Cottage 40 Watling Street
    Affetside
    BL8 3QW Bury
    Lancashire
    UkBritish23957610002
    BRINE, Gary Edward
    2 Springwood Place
    Cobbetts Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    2 Springwood Place
    Cobbetts Hill
    KT13 0UB Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish34997210018
    BROWN, Peter Royston
    Chestnut Cottage 43 Moor Lane
    SK9 6AW Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Chestnut Cottage 43 Moor Lane
    SK9 6AW Wilmslow
    Cheshire
    British65800190001
    COLLINS, Timothy Giles
    The Catstones Tunstall Road
    CW12 3QB Congleton
    Cheshire
    Amministratore
    The Catstones Tunstall Road
    CW12 3QB Congleton
    Cheshire
    British12334710001
    FONT, Ian
    11 Hollins Lane
    Marple Bridge
    SK6 5BB Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Hollins Lane
    Marple Bridge
    SK6 5BB Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish33934470001
    FURNISS, Marjorie Teresa
    Beresford Lodge 267 Main Road
    PO10 8JE Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    Beresford Lodge 267 Main Road
    PO10 8JE Emsworth
    Hampshire
    British14918660002
    GATCLIFFE, John Anthony
    72 Ringley Road
    Whitefield
    M25 7LN Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    72 Ringley Road
    Whitefield
    M25 7LN Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish1808980001
    HACKNEY, Philip Stanley
    Bridge House
    76 Runcorn Road, Moore
    WA4 6TZ Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    Bridge House
    76 Runcorn Road, Moore
    WA4 6TZ Warrington
    Cheshire
    British67617980001
    JOHNSTONE, Roger Douglas
    19 Gibwood Road
    M22 4BR Northenden
    Manchester
    Amministratore
    19 Gibwood Road
    M22 4BR Northenden
    Manchester
    United KingdomBritish101574970002
    KEIRL, Charles Ian
    19b Willow Tree Road
    WA14 2EQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    19b Willow Tree Road
    WA14 2EQ Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish25682680003
    LEE, Terence
    Robins Ridge 12 Buckbean Way
    Goostrey
    CW4 8JJ Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Robins Ridge 12 Buckbean Way
    Goostrey
    CW4 8JJ Crewe
    Cheshire
    British9363520001
    LEWIS, John Martin
    Arraghslea
    Browns Lane Dean Row
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Arraghslea
    Browns Lane Dean Row
    SK9 2BR Wilmslow
    Cheshire
    British14918680001
    LOMAS, Anthony John
    18 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    18 Hough Lane
    SK9 2LQ Wilmslow
    Cheshire
    British45564050001
    MACAULEY, Iain Edward
    The Red House Woodhouse Lane
    Dunham Massey
    WA14 4SB Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    The Red House Woodhouse Lane
    Dunham Massey
    WA14 4SB Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish62969020002
    MILNER, Martin Francis
    Long Meadow 61 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    Long Meadow 61 Tarvin Road
    Littleton
    CH3 7DD Chester
    Cheshire
    British27911480002
    PARKER, Michael Peter
    No 10 The White House
    Suffolk Road
    WA14 4QX Altringham
    Cheshire
    Amministratore
    No 10 The White House
    Suffolk Road
    WA14 4QX Altringham
    Cheshire
    United KingdomBritish78590080002
    RICHMAN, James Leslie
    Woodcroft 15 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DE Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    Woodcroft 15 Broad Lane
    Hale
    WA15 0DE Altrincham
    Cheshire
    British27314100001
    RODGERS, Dominic
    Shernfold Lodge Shernfold Park
    Frant
    TN3 9DL Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Shernfold Lodge Shernfold Park
    Frant
    TN3 9DL Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish40735450001
    SELBY, Malcolm Geoffrey
    77 Gatley Road
    Gatley
    SK8 1LX Cheadle
    Cheshire
    Amministratore
    77 Gatley Road
    Gatley
    SK8 1LX Cheadle
    Cheshire
    British25895890001
    THOMSON, George Barnes
    5 Wellgreen Close
    Hale Barns
    WA15 8PT Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 Wellgreen Close
    Hale Barns
    WA15 8PT Altrincham
    Cheshire
    British33934480001

    DORMANT SILVERWOOD COMMUNICATIONS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 05 mar 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property mpc house francis street withington manchester t/no GM504977AND the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 04 mar 1997
    Consegnato il 10 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 06 ago 1993
    Consegnato il 20 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20925.24
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to all sums payablee under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 20 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Gurantee and debenture
    Creato il 27 ago 1991
    Consegnato il 10 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See form 395 - ref m 642C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 mar 1991
    Consegnato il 28 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 30 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 1989
    Consegnato il 12 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 3, francis road, withington, manchester, greater manchester. Title no: gm 10279 (part).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 26 apr 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 1988
    Consegnato il 01 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Silverwood house, 129 barlow moor road, west didsbury, manchester, great er manchester. Title no la 182594.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 lug 1983
    Consegnato il 26 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First & floating charge (please see doc M106).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Trustees of the Commercial Advertising Service Limited See Doc M106 and Attached Sheet).Directors Self Administered Pension Plan (Please
    Transazioni
    • 26 lug 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0