G O S INVESTMENTS LIMITED

G O S INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàG O S INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00137008
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di G O S INVESTMENTS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova G O S INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o RUBICON PARTNERS
    8-12 York Gate
    NW1 4QG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di G O S INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WOLSELEY DISTRIBUTION EUROPE LIMITED13 ott 199813 ott 1998
    WOLSELEY SECURITIES LIMITED14 apr 198614 apr 1986
    GROVEWOOD SECURITIES LIMITED15 lug 191415 lug 1914

    Quali sono gli ultimi bilanci di G O S INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per G O S INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    4 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 31 mag 2016

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2015

    Stato del capitale al 04 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 09/12/2014
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2014

    Stato del capitale al 21 nov 2014

    • Capitale: GBP 5,365,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2B Sidings Court Doncaster South Yorkshire DN4 5NU a C/O Rubicon Partners 8-12 York Gate London NW1 4QG in data 21 nov 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 nov 2013

    Stato del capitale al 04 nov 2013

    • Capitale: GBP 5,364,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    legacy

    2 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG04

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di G O S INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    Segretario
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    BritishDirector118293300001
    FISCHER, Andrew Olaf
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    Amministratore
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    United KingdomGermanCompany Director70312740036
    FISHER, Ian
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    Amministratore
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    United KingdomBritishCompany Director51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    Amministratore
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    United KingdomBritishCompany Director14669590002
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    Amministratore
    c/o Rubicon Partners
    York Gate
    NW1 4QG London
    8-12
    England
    EnglandBritishDirector118293300001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    BritishChartered Secretary37378570010
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Segretario
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    BritishDirector6780200001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BURTON, Ian Michael
    Five Oaks Green Meadows
    Homme Green
    HR9 7RE Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Five Oaks Green Meadows
    Homme Green
    HR9 7RE Ross On Wye
    Herefordshire
    BritishAccountant31859330002
    DESCOURS, Jacques Regis
    3 Rue Tete D'Or
    F69006 Lyon
    France
    Amministratore
    3 Rue Tete D'Or
    F69006 Lyon
    France
    FrenchCompany Director60498090001
    HUTTON, Andrew Joseph
    Anchor Dykes
    Station Road Topcliffe
    YO7 3SQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Anchor Dykes
    Station Road Topcliffe
    YO7 3SQ Thirsk
    North Yorkshire
    BritishCompany Director1663430002
    IRELAND, Richard
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    10 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCompany Director272320001
    LANCASTER, Jeremy
    The Gables
    Broadwell
    GL56 0UF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    The Gables
    Broadwell
    GL56 0UF Moreton In Marsh
    Gloucestershire
    United KingdomBritishChairman And Managing Director18757600002
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    BritishChartered Secretary37378570010
    POWELL, William Tudor
    Foye House
    Cliffords Mesne
    GL18 1JN Newent
    Gloucestershire
    Amministratore
    Foye House
    Cliffords Mesne
    GL18 1JN Newent
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director27960510001
    SHEPPARD, Peter Wickham
    17 Patterdale Close
    LU6 3DA Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    17 Patterdale Close
    LU6 3DA Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Director1663460005
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Amministratore
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritishDirector6780200002
    WEBSTER, Stephen Paul
    Rose Cottage
    Haye Lane
    WR9 0EJ Omberseley
    Worcestershire
    Amministratore
    Rose Cottage
    Haye Lane
    WR9 0EJ Omberseley
    Worcestershire
    BritishCompany Director40201730002
    WEBSTER, Stephen Paul
    Welsh House Farm
    Welsh House Lane
    GL18 1LR Newent
    Gloucestershire
    Amministratore
    Welsh House Farm
    Welsh House Lane
    GL18 1LR Newent
    Gloucestershire
    BritishCompany Director40201730001
    YOUNG, John William Garne
    The Gables
    Hindon Lane
    SP3 6QF Tisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Gables
    Hindon Lane
    SP3 6QF Tisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director3012320001

    G O S INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 nov 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 12 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 apr 2000
    Consegnato il 02 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Soctland PLC (As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    General charge
    Creato il 27 gen 1981
    Consegnato il 03 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the freehold and leasehold property in england and wales of the company both present and future and the fixtures in the nature of landlords fixtures and trade fixtures from time to time thereon but excluding any lease hold property where the reversioners consent to such charge is necessary unless and until any necessary unless and until any necessary consent to the charging of such property has been obtained from the reversioners.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance LTD.
    Transazioni
    • 03 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    G O S INVESTMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2016Inizio della liquidazione
    19 set 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    Praticante
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0