FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED

FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00137863
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street
    Queensway
    B3 3HN Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E.F. TAYLOR & COMPANY LIMITED14 apr 199814 apr 1998
    E.F. TAYLOR PLC28 set 199428 set 1994
    E.F. TAYLOR & COMPANY LIMITED05 ott 191405 ott 1914

    Quali sono gli ultimi bilanci di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 06 set 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 28 giu 2021

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 5, 2nd Floor Aspect House Bennerley Road Nottingham NG6 8WR United Kingdom a Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 25 mar 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 08 mar 2021

    LRESSP

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 feb 2021

    • Capitale: GBP 1.2825
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 03/02/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Indirizzo della sede legale modificato da Mps Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW United Kingdom a Suite 5, 2nd Floor Aspect House Bennerley Road Nottingham NG6 8WR in data 16 nov 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Mark John Wenham come amministratore in data 04 nov 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Hickey Sharkey Ii come amministratore in data 04 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Wilkinson come amministratore in data 04 nov 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Andrew Darrington come amministratore in data 04 nov 2020

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW a Mps Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW in data 30 lug 2020

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019

    9 pagineAA

    Nomina di Mr Neil Wilkinson come amministratore in data 28 nov 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Kevin Maxwell come amministratore in data 28 nov 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Richard Priestley come amministratore in data 28 nov 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAXWELL, Kevin Alden
    Abernathy Road Ne
    Suite 125
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    Amministratore
    Abernathy Road Ne
    Suite 125
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    United StatesAmericanAttorney256366640001
    SHARKEY II, David Hickey
    Abernathy Road Ne
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    Amministratore
    Abernathy Road Ne
    30328 Atlanta
    1000
    Ga
    United States
    United StatesAmericanSvp Tax276234820001
    FITZPATRICK, Deborah Jane
    36 Moss Lane
    HA5 3AX Pinner
    Middlesex
    Segretario
    36 Moss Lane
    HA5 3AX Pinner
    Middlesex
    BritishSolicitor44082000003
    KUDO, Machiko
    76 St Peters Street
    N1 8JS London
    Segretario
    76 St Peters Street
    N1 8JS London
    British84667740002
    PRIESTLEY, Mark Richard
    Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    2 Old Farm Court
    Buckinghamshire
    Segretario
    Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    2 Old Farm Court
    Buckinghamshire
    British275589400001
    ROSE, Charles George
    Baulk House 66 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AQ Bedford
    Bedfordshire
    Segretario
    Baulk House 66 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AQ Bedford
    Bedfordshire
    British12377810001
    SCULLY, Richard Andrew
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63194950001
    ADAMS, Mark Andrew
    23 The Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    Amministratore
    23 The Little Adelphi
    10 John Adam Street
    WC2N 6HA London
    BritishDirector22733610004
    BROOM, Alastair Kenneth Preston
    39 Elm Drive
    St Ives
    PE17 4UA Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    39 Elm Drive
    St Ives
    PE17 4UA Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishSales/Marketing Director12377800001
    DARRINGTON, Andrew
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssistant Financial Controller207397840001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    180 Hermitage Road
    GU21 8XQ Woking
    Surrey
    Amministratore
    180 Hermitage Road
    GU21 8XQ Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCorporate Controller108529830002
    FELLOWS, John William
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Blackberry House Berghers Hill
    Wooburn Green
    HP10 0JP High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director20018280001
    GILCHRIST, Keith
    Tudor House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Tudor House
    Devonshire Avenue
    HP6 5JF Amersham
    Buckinghamshire
    BritishDirector124301670001
    GORDON, Richard Edward
    Kempston House
    Green End Kempston
    MK43 8RL Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Kempston House
    Green End Kempston
    MK43 8RL Bedford
    Bedfordshire
    BritishChartered Accountant85763310001
    HAMES, John Peter
    1 Chestnut Close
    Market Bosworth
    CV13 0LR Nuneaton
    Warwickshire
    Amministratore
    1 Chestnut Close
    Market Bosworth
    CV13 0LR Nuneaton
    Warwickshire
    EnglandBritishFinance Director12377790001
    HEWITT, Colin David
    23 Ludlow Close
    Oadby
    LE2 4SU Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    23 Ludlow Close
    Oadby
    LE2 4SU Leicester
    Leicestershire
    Great BritainBritishProduction Director31027240002
    MURPHY, Patrick Francis
    4 Ashton Grove
    NN8 5ZA Wellingborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Ashton Grove
    NN8 5ZA Wellingborough
    Northamptonshire
    BritishManaging Director12377830001
    O'CONNOR, David Peter
    22 Manor Park
    Nether Heyford
    NN7 3NN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    22 Manor Park
    Nether Heyford
    NN7 3NN Northampton
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director21533620002
    PIERCE, Stephen Keith
    16 All Saints Avenue
    SL6 6EW Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    16 All Saints Avenue
    SL6 6EW Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director101528490001
    PRIESTLEY, Mark Richard
    2 Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    Buckinghamshire
    Amministratore
    2 Old Farm Court
    HP18 0SU Grendon Underwood
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAccountant275589400001
    RAY, Derick Parkinson
    14 Woodlands Road
    Great Shelford
    CB2 5LW Cambridge
    Cambridgeshire
    Amministratore
    14 Woodlands Road
    Great Shelford
    CB2 5LW Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishRetired Solicitor12377840001
    REGNIERS, Yves
    Woodhouse Gardens
    NG11 6BF Ruddington
    62
    United Kingdom
    Amministratore
    Woodhouse Gardens
    NG11 6BF Ruddington
    62
    United Kingdom
    United KingdomBelgianFinance Director159048480002
    ROSE, Charles George
    Baulk House 66 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AQ Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Baulk House 66 Bromham Road
    Biddenham
    MK40 4AQ Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector/Company Secretary12377810001
    ROSE, Keith George
    16 Vicars Close
    Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    16 Vicars Close
    Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    BritishSolicitor9370620001
    ROSE, Marjory Carol
    16 Vicars Close
    Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    16 Vicars Close
    Biddenham
    MK40 4BG Bedford
    Bedfordshire
    British9370640001
    RYLANCE, Neil
    5 Park Avenue
    Shelley Park, Shelley
    HD8 8JG Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Park Avenue
    Shelley Park, Shelley
    HD8 8JG Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director63514990001
    SANDERSON, Stephen Mark
    2 West Lodge Cottages
    Courteenhall
    NN7 2QB Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    2 West Lodge Cottages
    Courteenhall
    NN7 2QB Northampton
    Northamptonshire
    BritishCommercial Director53533050001
    SCULLY, Richard Andrew
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Sawmill Road
    Longwick
    HP27 9TD Princes Risborough
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director63194950001
    TIMS, James Gerald
    27a Broadway
    Duffield
    DE56 4BT Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    27a Broadway
    Duffield
    DE56 4BT Belper
    Derbyshire
    BritishDirector22203570002
    WENHAM, Mark John
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishExecutive Vice President224447950001
    WILKINSON, Neil
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director237765630001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Millennium Way West
    Phoenix Centre
    NG8 6AW Nottingham
    Mps
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione2586987
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 26TH march 1991 issued by the company
    Creato il 11 giu 1996
    Consegnato il 19 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    Brevi particolari
    All right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 03 giu 1996
    Consegnato il 06 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for the purchase of debts dated 8TH may 1996
    Brevi particolari
    Fixed equitable charge on all debts or other obligations of the company of agreed customers under contracts of sale which fail to vest absolutely in the security holder and remain vested in the company and all associated rights to the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 06 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 mar 1996
    Consegnato il 12 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    One iberica jr 105F cutting and creasing platen press - serial no 9561 together with all accessories and component parts and all improvements etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile Business Finance Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 29 mar 1993
    Consegnato il 02 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £53568.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 02 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 06 mar 1992
    Consegnato il 17 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £48735.30 due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All right title & interest in & to all sums payable under the insurance as from time to time varied or extended & the benefit of all powers & remedies.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 17 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 apr 1991
    Consegnato il 29 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the west of ampthill road, kempston, bedfordshire. Title no. Bd 71707.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mar 1991
    Consegnato il 05 apr 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 nov 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge.
    Creato il 20 giu 1989
    Consegnato il 23 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a master hire purchase agreement dated 14.5.89 and/or the charge.
    Brevi particolari
    One planeta p 24-3. serial no: 181805 with wallace knight ultra violet curing system, all replacements & additions thereto.
    Persone aventi diritto
    • Concord Leasing (UK) Limited.
    Transazioni
    • 23 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 24 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 14 ott 1987
    Consegnato il 21 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Planeta super variant size 4 five colour sheet, fed offset press and ancillary equipment.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 1983
    Consegnato il 08 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book & other debts now due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 ott 1978
    Consegnato il 20 ott 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold factory premises in ampthill road, bedford with all fixtures whatsoever.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 03 gen 1978
    Consegnato il 11 gen 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    One complete 3 lamp 40" ultra violet curing system. Serial no 271.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 03 gen 1978
    Consegnato il 11 gen 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the chattels. Plant, machinery as described planeta variant model P44 offset press serial no M1739.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 24 gen 1974
    Consegnato il 31 gen 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc.
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 12 ago 1966
    Consegnato il 26 ago 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc.
    Brevi particolari
    Factory premises situate in ampthill rd bedford with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ago 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 13 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 mar 2021Inizio della liquidazione
    15 mar 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Praticante
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Stephen Roland Browne
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London
    Praticante
    1 New Street Square
    EC4A 3HQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0