FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED
Panoramica
Nome della società | FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00137863 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway B3 3HN Birmingham West Midlands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
E.F. TAYLOR & COMPANY LIMITED | 14 apr 1998 | 14 apr 1998 |
E.F. TAYLOR PLC | 28 set 1994 | 28 set 1994 |
E.F. TAYLOR & COMPANY LIMITED | 05 ott 1914 | 05 ott 1914 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR | 2 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Suite 5, 2nd Floor, Aspect House Bennerley Road Nottingham United Kingdom NG6 8WR | 2 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN a C/O Teneo Restructuring Limited 156 Great Charles Street Queensway Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 06 set 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR a 156 Great Charles Street Queensway Birmingham West Midlands B3 3HN in data 28 giu 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Suite 5, 2nd Floor Aspect House Bennerley Road Nottingham NG6 8WR United Kingdom a Hill House, 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 25 mar 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 6 pagine | LIQ01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 19 feb 2021
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Mps Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW United Kingdom a Suite 5, 2nd Floor Aspect House Bennerley Road Nottingham NG6 8WR in data 16 nov 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark John Wenham come amministratore in data 04 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr David Hickey Sharkey Ii come amministratore in data 04 nov 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Neil Wilkinson come amministratore in data 04 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Darrington come amministratore in data 04 nov 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW a Mps Millennium Way West Phoenix Centre Nottingham Nottinghamshire NG8 6AW in data 30 lug 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mr Neil Wilkinson come amministratore in data 28 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Kevin Maxwell come amministratore in data 28 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Richard Priestley come amministratore in data 28 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXWELL, Kevin Alden | Amministratore | Abernathy Road Ne Suite 125 30328 Atlanta 1000 Ga United States | United States | American | Attorney | 256366640001 | ||||
SHARKEY II, David Hickey | Amministratore | Abernathy Road Ne 30328 Atlanta 1000 Ga United States | United States | American | Svp Tax | 276234820001 | ||||
FITZPATRICK, Deborah Jane | Segretario | 36 Moss Lane HA5 3AX Pinner Middlesex | British | Solicitor | 44082000003 | |||||
KUDO, Machiko | Segretario | 76 St Peters Street N1 8JS London | British | 84667740002 | ||||||
PRIESTLEY, Mark Richard | Segretario | Old Farm Court HP18 0SU Grendon Underwood 2 Old Farm Court Buckinghamshire | British | 275589400001 | ||||||
ROSE, Charles George | Segretario | Baulk House 66 Bromham Road Biddenham MK40 4AQ Bedford Bedfordshire | British | 12377810001 | ||||||
SCULLY, Richard Andrew | Segretario | 6 Sawmill Road Longwick HP27 9TD Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63194950001 | ||||||
ADAMS, Mark Andrew | Amministratore | 23 The Little Adelphi 10 John Adam Street WC2N 6HA London | British | Director | 22733610004 | |||||
BROOM, Alastair Kenneth Preston | Amministratore | 39 Elm Drive St Ives PE17 4UA Huntingdon Cambridgeshire | British | Sales/Marketing Director | 12377800001 | |||||
DARRINGTON, Andrew | Amministratore | Millennium Way West Phoenix Centre NG8 6AW Nottingham Mps Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Assistant Financial Controller | 207397840001 | ||||
FALLER, Guy Nicholas Anthony | Amministratore | 180 Hermitage Road GU21 8XQ Woking Surrey | United Kingdom | British | Corporate Controller | 108529830002 | ||||
FELLOWS, John William | Amministratore | Blackberry House Berghers Hill Wooburn Green HP10 0JP High Wycombe Buckinghamshire | England | British | Company Director | 20018280001 | ||||
GILCHRIST, Keith | Amministratore | Tudor House Devonshire Avenue HP6 5JF Amersham Buckinghamshire | British | Director | 124301670001 | |||||
GORDON, Richard Edward | Amministratore | Kempston House Green End Kempston MK43 8RL Bedford Bedfordshire | British | Chartered Accountant | 85763310001 | |||||
HAMES, John Peter | Amministratore | 1 Chestnut Close Market Bosworth CV13 0LR Nuneaton Warwickshire | England | British | Finance Director | 12377790001 | ||||
HEWITT, Colin David | Amministratore | 23 Ludlow Close Oadby LE2 4SU Leicester Leicestershire | Great Britain | British | Production Director | 31027240002 | ||||
MURPHY, Patrick Francis | Amministratore | 4 Ashton Grove NN8 5ZA Wellingborough Northamptonshire | British | Managing Director | 12377830001 | |||||
O'CONNOR, David Peter | Amministratore | 22 Manor Park Nether Heyford NN7 3NN Northampton Northamptonshire | British | Commercial Director | 21533620002 | |||||
PIERCE, Stephen Keith | Amministratore | 16 All Saints Avenue SL6 6EW Maidenhead Berkshire | England | British | Company Director | 101528490001 | ||||
PRIESTLEY, Mark Richard | Amministratore | 2 Old Farm Court HP18 0SU Grendon Underwood Buckinghamshire | United Kingdom | British | Accountant | 275589400001 | ||||
RAY, Derick Parkinson | Amministratore | 14 Woodlands Road Great Shelford CB2 5LW Cambridge Cambridgeshire | British | Retired Solicitor | 12377840001 | |||||
REGNIERS, Yves | Amministratore | Woodhouse Gardens NG11 6BF Ruddington 62 United Kingdom | United Kingdom | Belgian | Finance Director | 159048480002 | ||||
ROSE, Charles George | Amministratore | Baulk House 66 Bromham Road Biddenham MK40 4AQ Bedford Bedfordshire | England | British | Director/Company Secretary | 12377810001 | ||||
ROSE, Keith George | Amministratore | 16 Vicars Close Biddenham MK40 4BG Bedford Bedfordshire | British | Solicitor | 9370620001 | |||||
ROSE, Marjory Carol | Amministratore | 16 Vicars Close Biddenham MK40 4BG Bedford Bedfordshire | British | 9370640001 | ||||||
RYLANCE, Neil | Amministratore | 5 Park Avenue Shelley Park, Shelley HD8 8JG Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | Company Director | 63514990001 | ||||
SANDERSON, Stephen Mark | Amministratore | 2 West Lodge Cottages Courteenhall NN7 2QB Northampton Northamptonshire | British | Commercial Director | 53533050001 | |||||
SCULLY, Richard Andrew | Amministratore | 6 Sawmill Road Longwick HP27 9TD Princes Risborough Buckinghamshire | England | British | Finance Director | 63194950001 | ||||
TIMS, James Gerald | Amministratore | 27a Broadway Duffield DE56 4BT Belper Derbyshire | British | Director | 22203570002 | |||||
WENHAM, Mark John | Amministratore | Millennium Way West Phoenix Centre NG8 6AW Nottingham Mps Nottinghamshire United Kingdom | England | British | Executive Vice President | 224447950001 | ||||
WILKINSON, Neil | Amministratore | Millennium Way West Phoenix Centre NG8 6AW Nottingham Mps Nottinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 237765630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Packaging Solutions Uk Limited | 06 apr 2016 | Millennium Way West Phoenix Centre NG8 6AW Nottingham Mps Nottinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Fixed charge supplemental to a debenture dated 26TH march 1991 issued by the company | Creato il 11 giu 1996 Consegnato il 19 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture | |
Brevi particolari All right title and interest of the company in or arising out of a factoring invoice discounting or sales ledger financing agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Creato il 03 giu 1996 Consegnato il 06 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement for the purchase of debts dated 8TH may 1996 | |
Brevi particolari Fixed equitable charge on all debts or other obligations of the company of agreed customers under contracts of sale which fail to vest absolutely in the security holder and remain vested in the company and all associated rights to the debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 07 mar 1996 Consegnato il 12 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £250,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari One iberica jr 105F cutting and creasing platen press - serial no 9561 together with all accessories and component parts and all improvements etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A credit agreement | Creato il 29 mar 1993 Consegnato il 02 apr 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £53568.20 due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Credit agreement | Creato il 06 mar 1992 Consegnato il 17 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £48735.30 due from the company to the chargee | |
Brevi particolari All right title & interest in & to all sums payable under the insurance as from time to time varied or extended & the benefit of all powers & remedies. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 11 apr 1991 Consegnato il 29 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings lying to the west of ampthill road, kempston, bedfordshire. Title no. Bd 71707. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 mar 1991 Consegnato il 05 apr 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge. | Creato il 20 giu 1989 Consegnato il 23 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under a master hire purchase agreement dated 14.5.89 and/or the charge. | |
Brevi particolari One planeta p 24-3. serial no: 181805 with wallace knight ultra violet curing system, all replacements & additions thereto. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattels mortgage | Creato il 14 ott 1987 Consegnato il 21 ott 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Planeta super variant size 4 five colour sheet, fed offset press and ancillary equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 31 ago 1983 Consegnato il 08 set 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book & other debts now due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 13 ott 1978 Consegnato il 20 ott 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/Hold factory premises in ampthill road, bedford with all fixtures whatsoever. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattels mortgage | Creato il 03 gen 1978 Consegnato il 11 gen 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari One complete 3 lamp 40" ultra violet curing system. Serial no 271. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattels mortgage | Creato il 03 gen 1978 Consegnato il 11 gen 1978 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All and singular the chattels. Plant, machinery as described planeta variant model P44 offset press serial no M1739. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Floating charge | Creato il 24 gen 1974 Consegnato il 31 gen 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 12 ago 1966 Consegnato il 26 ago 1966 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc. | |
Brevi particolari Factory premises situate in ampthill rd bedford with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
FIELD BOXMORE BEDFORD LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0