CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED
Panoramica
Nome della società | CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00139651 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Wigmore House Wigmore Lane LU2 9TN Luton Bedfordshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CANADIAN PACIFIC STEAMSHIPS,LIMITED | 16 mar 1915 | 16 mar 1915 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 30 set 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 giu 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 11 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 25 mag 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 11 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2023 | 4 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Cp Ships (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2022 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2021 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2022 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Simon Jeffrey Cope come amministratore in data 01 ott 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Thomas Langhans come amministratore in data 30 set 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2020 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 4 pagine | AA | ||
Nomina di Sharon Louise Barter come amministratore in data 29 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Stephen John Brann come amministratore in data 29 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 3 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2017 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Cp Ships (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 02 ott 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Tui Travel House Crawley Business Quarter Fleming Way Crawley West Sussex RH10 9QL a Wigmore House Wigmore Lane Luton Bedfordshire LU2 9TN in data 02 ott 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Cessazione della carica di Mark Hattendorf come amministratore in data 01 ago 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Thomas Langhans come amministratore in data 01 ago 2017 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2016 | 4 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARTER, Sharon Louise | Amministratore | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | English | Company Director | 250202330001 | ||||
COPE, Simon Jeffrey | Amministratore | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 264880570001 | ||||
BAKER, John Michael | Segretario | Pedlars The Chase KT20 6HZ Kingswood Surrey | Canadian | 110901170001 | ||||||
HENDERSON, Diane | Segretario | The Old Dairy Manor House Mill Lane KT14 7RS Byfleet Surrey | British | 44615410001 | ||||||
HILL, Elliot Robert Greatrex | Segretario | 92 Montpelier Road BN1 3BE Brighton East Sussex | British | 99461490002 | ||||||
MANSFELD, Thomas | Segretario | Zikadenweg FOREIGN 22043 Hamburg 19e Germany | German | 117835010002 | ||||||
SHORT, Karen Margot | Segretario | Deanlands Vines Cross TN21 9HB Heathfield East Sussex | British | Fin & Ad Man | 78988930001 | |||||
SMITH, Caroline | Segretario | 61 Palace View BR1 3EJ Bromley Kent | British | Administrative Assistant | 45385810001 | |||||
WALTER, Joyce, Mrs. | Segretario | Crawley Business Quarter Fleming Way RH10 9QL Crawley Tui Travel House West Sussex United Kingdom | 149356710001 | |||||||
ADAMS, Anthony Frederick | Amministratore | 28 Granville Road TN13 1EY Sevenoaks Kent | British | Chartered Accountant | 14056830001 | |||||
BRANN, Stephen John | Amministratore | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 153081020001 | ||||
FATT, William Robert | Amministratore | 23 Aldershot Crescent Willowdale Ontario M2p 1l7 Canada | Canadian | Vice-President | 60844060001 | |||||
GAMEY, Ronald Kenneth | Amministratore | 86 Glen Road FOREIGN Toronto Ontario M4w 2v6 Canada | Canadian | Executive Vice President | 55303320001 | |||||
GRANDIN, Michael Anthony | Amministratore | 2226 Amherst Street Sw Calgary Alberta T2t 3b7 Canada | Canadian | Chief Financial Officer | 65300050001 | |||||
HATTENDORF, Mark | Amministratore | Crawley Business Quarter Fleming Way RH10 9QL Crawley Tui Travel House West Sussex | Germany | German | Accountant | 183404720001 | ||||
HENDERSON, Diane | Amministratore | The Old Dairy Manor House Mill Lane KT14 7RS Byfleet Surrey | British | Consultant Legal Sec Services | 44615410001 | |||||
JOHN, Andrew Lloyd | Amministratore | Crawley Business Quarter Fleming Way RH10 9QL Crawley Tui Travel House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Lawyer | 75467790004 | ||||
KEAST, Denis Raymond | Amministratore | 5 Dry Hill Park Crescent TN10 3BJ Tonbridge Kent | British | Managing Director | 14056860001 | |||||
LANGHANS, Thomas | Amministratore | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | Germany | German | Manager General Accounting | 236718330001 | ||||
NICKLIN, David Royston | Amministratore | 17 Saint Francis Gardens RH10 3JS Copthorne West Sussex | British | Director | 78465650001 | |||||
NICKLIN, David | Amministratore | 17 St Francis Gardens RH10 3JS Copthorne West Sussex | British | Group Financial Controller | 80794550001 | |||||
RAU, Wilfried | Amministratore | Hannover Bischofsholer Damm 34 30173 Germany | Germany | German | Director | 136733410001 | ||||
REEVE, Michael | Amministratore | 11 Tiberius Gardens CM8 1HJ Witham Essex | England | British | Director | 60778110001 | ||||
ROMOFF, Harvey Michael | Amministratore | 3445 Drummond Street Apt 803 FOREIGN Montreal Quebec H3g 1x9 Canada | Canadian | Vice-President | 14056870001 | |||||
TORRENS, Iain William | Amministratore | 34 Church Avenue East Sheen SW14 8NN London | British | Director | 83364810001 | |||||
VARTAN, Ronald Alastair Robertson | Amministratore | Flat 4 Rosewood Park Road GU27 2NJ Haslemere Surrey | England | British | International Transport | 29795340001 | ||||
WALDING, Keith John | Amministratore | Kintail Halldore Hill SL6 9EX Cookham Berkshire | British | Director | 46199600003 | |||||
WALTER, Joyce | Amministratore | Crawley Business Quarter Fleming Way RH10 9QL Crawley Tui Travel House West Sussex United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 76169540003 | ||||
WEBBER, Ian James | Amministratore | The Farmyard Pearsons Green TN12 7DE Brenchley Kent | British | Cfo | 54611490002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cp Ships (Uk) Limited | 06 apr 2016 | Wigmore Lane LU2 9TN Luton Wigmore House Bedfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CANADIAN PACIFIC (UK) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Supplemental agreement | Creato il 27 lug 1971 Consegnato il 04 ago 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £3,110,600 and all other monies due under terms of an agreement dated 24/6/70 and deeds supplemental | |
Brevi particolari The sum of £114,696 which has been deposited with bankers. (See doc 133 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of covenant | Creato il 27 lug 1971 Consegnato il 04 ago 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For further securing ukp 3,110,600 & all other monies due secured by another charge dated 27-7-71. | |
Brevi particolari The mortgages insurances earnings & requisition compensation (see doc 134 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Statutory mortgage | Creato il 27 lug 1971 Consegnato il 04 ago 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due on a/c current under terms financial agreement 24.6.70 as amended by the square agreements & deed of covenant dated 27.7.91 | |
Brevi particolari Mv "cp discoverer". | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of covenant | Creato il 01 lug 1971 Consegnato il 08 lug 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,723,200 and all other monies due or to become due from the company to national westminster bank LTD secured by another charge dated 1/7/71 | |
Brevi particolari The mortgaged premises (being the ship, the insurances, the earnings of the ship and requisition compensation as defined in the said deed of covenant). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Statutory mortgage | Creato il 01 lug 1971 Consegnato il 08 lug 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 24/6/70 of a deed of convenant dated 1/7/71 | |
Brevi particolari M.V. "cp trader" official no 341333. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of covenant | Creato il 27 nov 1970 Consegnato il 04 dic 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £3,142,616 & all other monies due under terms of 2 financial agreements dated 24.6.70 & 20.11.70. & secured by another charge 27.11.70 | |
Brevi particolari Insurances & earnings of the ship. Etc. (see doc 126 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Statutory mortgage | Creato il 27 nov 1970 Consegnato il 04 dic 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing all monies due or a/c current pursuant to the financial agreements 24-6-70, 20.11.70, & deed of covenant dated 27.11.70. | |
Brevi particolari M/V "cp voyageur" - 341152. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Agreement | Creato il 20 nov 1970 Consegnato il 24 nov 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For increasing the amounts secured by a financial agreement dated 24 june june 70 by £379,200 with a further commitment commissio of 1% | |
Brevi particolari 1) all the owners beneficial interest & all its benefits rights & titles in & under a building contract dated the 4TH march, 1969 2) the vessel as shars constructed & all her engines boilers and machiners etc. (see doc 124). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Agreement | Creato il 20 nov 1970 Consegnato il 24 nov 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For increasing the amount secured by a financial agreement dated 24 june 70 by £340.000 with a further commitment commission of 1% | |
Brevi particolari 1) all the owners beneficial interest & all its benefits rights & titles in & under a building contract dated the 4TH march, 1969 2) the vessel as she is constructed & all her engines boilers and machinery etc. (see doc. 123). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Financial agreement | Creato il 24 giu 1970 Consegnato il 02 lug 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,723,200 together with a commitment commission of 1% and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari 1) all the owners beneficial interest & all its benefits rights & titles in & under a building contract dated the 4TH march, 1969 2) the vessel as she is constructed & all her engines boilers and machinery etc. (see doc. 116 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Financial agreement | Creato il 24 giu 1970 Consegnato il 02 lug 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £2,801,816 together with a commitment commission of 1% and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement | |
Brevi particolari 1) all the owners beneficial interest & all its benefits rights & titles in & under a building contract dated the 4TH march, 1969 2) the vessel as she is constructed & all her engines boilers and machinery etc. (see doc. 115 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Financial agreement | Creato il 24 giu 1970 Consegnato il 02 lug 1970 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For securing £2,731.400 together with a commitment commission of 1% and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement. | |
Brevi particolari 1) all the owners beneficial interest & all its benefits rights & titles in & under a building contract dated the 4TH march, 1969 2) the vessel as she is constructed & all her engines boilers and machinery etc (see doc 114 for further details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0