SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED

SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00140534
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUSSEX COASTLINE BUSES LIMITED02 apr 199202 apr 1992
    SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED02 giu 191502 giu 1915

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al01 mag 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 09 mag 2022

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 01 mag 2021

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mag 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Bruce Dingwall come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Brown come amministratore in data 31 mag 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Karen Rosaleen Robbins come amministratore in data 31 mag 2019

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017

    4 pagineAA

    Modifica dei dettagli di West Sussex Buses Limited come persona con controllo significativo il 16 nov 2017

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Stagecoach Services Ltd Daw Bank Stockport Cheshire SK3 0DU a C/O Stagecoach Services Limited One Stockport Exchange 20 Railway Road Stockport SK1 3SW in data 16 nov 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2015

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VAUX, Michael John
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Segretario
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    British137383880001
    DINGWALL, Bruce Maxwell
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish185252790001
    ROBBINS, Karen Rosaleen
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Chendre Close
    Hayfield
    SK22 2PH High Peak
    8
    Derbyshire
    England
    EnglandBritish73518280001
    HEAD, Michael Edward
    19 Felbridge Avenue
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    Segretario
    19 Felbridge Avenue
    RH10 7BD Crawley
    West Sussex
    British59161160002
    REEVE, Michael John
    Yewcroft 28 Hammerwood Road
    Ashurst Wood
    RH19 3TG East Grinstead
    West Sussex
    Segretario
    Yewcroft 28 Hammerwood Road
    Ashurst Wood
    RH19 3TG East Grinstead
    West Sussex
    English2521430001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Segretario
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    British27504200001
    TYLER, Christopher Michael
    12 Delves Close
    Ringmer
    BN8 5JW Lewes
    East Sussex
    Segretario
    12 Delves Close
    Ringmer
    BN8 5JW Lewes
    East Sussex
    British54790510001
    WEBB, Forbes Waddington
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    Segretario
    7 Firle Grange
    BN25 2HD Seaford
    East Sussex
    British84060000001
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Segretario
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002
    BROWN, Colin
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish85970020003
    COCHRANE, Keith Robertson
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    Amministratore
    Glen Hall
    Belwood Park
    PH2 7AJ Perth
    British47574960002
    COX, Anthony Geoffrey
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    4 Keats Close
    Great Houghton
    NN4 7NX Northampton
    Northamptonshire
    British70180950001
    COX, Brian John
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    Amministratore
    Kirknewton House
    Kirknewton
    NE71 6XF Wooler
    Northumberland
    EnglandBritish1436830002
    COX, Brian John
    Little Crede Crede Lane
    Bosham
    PO18 8NX Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    Little Crede Crede Lane
    Bosham
    PO18 8NX Chichester
    West Sussex
    British1436830001
    DYER, Andrew William
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish62948690004
    GLOAG, Ann Heron
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Kinfauns Castle
    PH2 7JZ Perth
    Perthshire
    ScotlandBritish141120003
    GRIFFITHS, Martin Andrew
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Amministratore
    Upland
    2 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish61722690002
    HINKLEY, William Barry
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    Amministratore
    Mandalay
    Bassenthwaite
    CA12 4QG Keswick
    Cumbria
    EnglandBritish2268190002
    KINSKI, Michael John
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    Cherry Tree House 268 Dunchurch Road
    CV22 6HX Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritish58643710001
    SOUTER, Brian
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    Amministratore
    Murrayfield House
    St Magdalenes Road
    PH2 0BT Perth
    Perthshire
    British1436810001
    STOGGELL, Martin Herbert
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    Amministratore
    119 Blackborough Road
    RH2 7DA Reigate
    Surrey
    British27504200001
    TOPLIFF, Debra
    5 Warrenwood
    BN8 4JR North Chailey
    East Sussex
    Amministratore
    5 Warrenwood
    BN8 4JR North Chailey
    East Sussex
    British119755060001
    WARNEFORD, Leslie Brian
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Dunkeld Road
    PH1 5TW Perth
    Stagecoach Group Plc
    Perthshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish49771140004
    WHITNALL, Alan Leonard
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    Amministratore
    25 Millhill Drive
    Greenloaning
    FK15 0LS Dunblane
    Perthshire
    British54184420002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    06 apr 2016
    One Stockport Exchange
    20 Railway Road
    SK1 3SW Stockport
    C/O Stagecoach Services Limited
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione01961491
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SOUTHDOWN MOTOR SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 mag 1993
    Consegnato il 05 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 05 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 apr 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Letter of offset
    Creato il 19 ago 1991
    Consegnato il 09 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the northern scottish omnibuses limited to chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances at credit in any account held with the bank in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 gen 1990
    Consegnato il 02 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stage- coach (holdings) limited to the chargee under the terms of a term loan agreement dated 26/1/90 and all monies due or to become due from stage-coach (holdings) limited to the chargee under the terms of a revolving credit and overdraft facility agreement dated 26/01/90 and all monies due or to become due from stage-coach (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    (Including trade & tenants fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governer and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 10 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Office premises fronting walvers lane school hill lewes sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Office premises 10 east street littlehampton west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1/1A market parade havant hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 10 charterhouse lord montgomery way portsmouth hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bus station fronting elm lane havant hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 ott 1987
    Consegnato il 14 ott 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1987Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0