SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00143447
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    • Attività di organizzazioni di categoria di imprenditori e datori di lavoro (94110) / Altre attività di servizi

    Dove si trova SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Indirizzo della sede legale
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) LIMITED10 set 201010 set 2010

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 lug 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 lug 2015

    Stato del capitale al 27 lug 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2014

    Stato del capitale al 30 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 18 lug 2013

    SH01

    Nomina di Ms Beth Porter come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Robert Sayers come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ian Godden come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Brian Alfred Everitt come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Adam Godden il 16 lug 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Ian Adam Godden come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PORTER, Beth
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    Segretario
    E T P S Road
    GU14 6FD Farnborough
    Showcentre
    Hampshire
    England
    179916010001
    EVERITT, Paul Brian Alfred
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Amministratore
    Salamanca Square
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    United KingdomBritishChief Executive127067280001
    BATTEN, Kenneth Henry
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    Segretario
    1 Welbeck Avenue
    Highfield
    SO17 1SW Southampton
    Hampshire
    British14410550001
    BIRD, Katherine Evendra
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    42 Baldock Road
    Stotfold
    SG5 4PB Hitchin
    Hertfordshire
    BritishAssistant Company Secretary79431470001
    CHAPMAN, Ian
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    Segretario
    2 Palmerston House
    126 Westminster Bridge Rd
    SE1 7UW London
    British73385590002
    SAYERS, Robert
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    Segretario
    26 Dorian Drive
    Cheapside
    SL5 7QL Ascot
    Berkshire
    BritishAccountant30546490002
    SIDEBOTTOM, Trevor George
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    Segretario
    7 The Wheatridge
    GL4 4DQ Gloucester
    BritishCompany Secretary54601040001
    ANNETT, Richard John
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    Amministratore
    Nallers Farm Askerswell
    DT2 9EJ Dorchester
    Dorset
    BritishDirector63294730001
    ARENDT, Axel
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    Amministratore
    801 Westminster Green
    8 Dean Ryle Street Westminster
    SW1P 4DA London
    GermanPresident Defence Aerospace113562590001
    BANHAM, Stephen James
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    Amministratore
    42 West Street
    RG26 3SX Tadley
    Hampshire
    United KingdomBritishManaging Director54822030002
    BARBER, Norman Victor
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Greylands 17 Merrow Croft
    Merrow
    GU1 2XH Guildford
    Surrey
    EnglandBritishChairman Aerospace & Defence Group6210060001
    BEECH, Simon William
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    9 Greytree Crescent
    Dorridge
    B93 8SL Solihull
    West Midlands
    BritishM D73297190001
    BELISARIO, Anthony Alfredo
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    24 Coronation Road
    Prestbury
    GL52 3DA Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishManaging Director Dowty Aerosp19258750001
    BENNETT, Katherine Susan
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    Amministratore
    Grovewood Cottage
    Horton
    BS37 6QN Bristol
    Avon
    BritishHead Of Government Affairs Air107026600001
    BLOGH, Julian, Doctor
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Malvern 83 Green Lane
    SL1 8EG Burnham Beeches
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector36783690003
    BLUNDELL, Charles Edward
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    Amministratore
    Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    65
    BritishCompany Secretary44158000002
    BROADHURST, Martin Tilston
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    5 Chancellery Mews
    IP33 3EG Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishChief Executive26365720002
    BROWN, David Robert
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    Amministratore
    2 Wildwood Close
    GU22 8PL Woking
    Surrey
    BritishManaging Director70823740001
    BRUNDLE, Kenneth Sydney
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Amministratore
    Carigullian Cottage
    27a Killyleagh Road
    BT23 6TD Newtownards
    County Down
    Northern IrelandBritishVice President163918190001
    BRYSON, Marcus James Stirling
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    1 Jura Close
    Cosham
    PO6 3UG Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritishChief Executive Grn Aerospace82769940001
    BUNDRED, David George
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    31 Lindsey Crescent
    CV8 1FL Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishManaging Director70291370001
    BURNS, Christopher Robert, Dr
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    Amministratore
    66 Fairmile Lane
    Doonside
    KT11 2DE Cobham
    Surrey
    BritishChief Executive Dunlop Aerospace Group77008070001
    BURRIDGE, Harold James
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    15 Oakley Road
    BH21 1QJ Wimborne
    Dorset
    EnglandBritishSenior Manager72691890001
    BURROWS, Peter John
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    Amministratore
    Paddock Cottage
    East Coker
    BA22 9JP Yeovil
    Somerset
    BritishManaging Director5107210001
    BURTON, Philip Frederick Jocelyn
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Meadowcroft Miz Maze
    Leigh
    DT9 6JJ Sherborne
    Dorset
    EnglandBritishManaging Director65588520001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    Amministratore
    48 Fernside
    M26 1EQ Radcliffe
    Lancashire
    MalteseDirector Of Aerospace And Busi82769840001
    BUSUTTIL, Walter Gerard Paul
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    Amministratore
    Robecq Painswick Road
    Brockworth
    GL3 4RP Gloucester
    MalteseManaging Director58388590001
    CASE, Richard Ian
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    Amministratore
    Melchester House
    Horsington
    BA8 0EG Templecombe
    Somerset
    EnglandBritishChairman3618430001
    CASSIDY, Michael John
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    Amministratore
    De-Mar
    Aspen Holt Bassett Wood
    SO16 3QE Southampton
    BritishManaging Director Lucas Aerospace Ltd14410560001
    CHEFFINS, John Patrick
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    Amministratore
    65 Buckingham Gate
    SW1E 6AT London
    British CanadianChief Operating Officer43529390003
    CHISHOLM, John Alexander Raymond, Sir
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Batchworth Hill House London Road
    WD3 1JS Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCeo/Engineer52854760001
    CHISNALL, Graham
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    Amministratore
    10 Pear Tree Lane
    GU10 4DW Rowledge
    Little Orchard
    Surrey
    United KingdomBritishDirector135061600001
    CHOW, Chung Kong, Sir
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    Amministratore
    Flat 10
    20 Lowndes Square
    SW1X 9HD London
    BritishDirector37736600002
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    BritishManaging Director73934900001
    CLARK, Robin Hartley Ledgerd
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Glebe Cottage
    Rockbourne
    SP6 3NA Fordingbridge
    Hampshire
    BritishManaging Director Flight Refuelling Limited73934900001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    06 apr 2016
    9 Albert Embankment
    SE1 7SP London
    Salamanca Square
    England
    No
    Forma giuridicaRegistered Legal Entity
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07016635
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    SOCIETY OF BRITISH AEROSPACE COMPANIES (THE) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 04 lug 2007
    Consegnato il 25 lug 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a 9G albert embankment london (formerly k/a unit 7 9 albert embankment london) all buildings,fixtures,fittings and fixed plant and machienry. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • William Kenneth Maciver and Gordon Francis Page and Charles Nicholas Hall (Being Trustees Ofthe Society of British Aerospace Companies Limited Pension and Life Assurance Plan "the Scheme")
    Transazioni
    • 25 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 01 feb 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a suite 7 salamanca square albert embankment london. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage deed
    Creato il 12 feb 2003
    Consegnato il 21 feb 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as duxbury house 60 petty france victoria london SW1H 9EU title number NGL641010. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 21 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 24 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit (as defined) and all such rights to the repayment thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0