LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED
Panoramica
Nome della società | LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00146336 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 2 Holdsworth Street BD1 4AH Bradford West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HOLDSWORTH COLLECTIONS LIMITED | 05 feb 1990 | 05 feb 1990 |
T.& J.BRAGG LIMITED | 06 mar 1917 | 06 mar 1917 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Truluck il 14 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Notifica di Ginette Moulin come persona con controllo significativo il 10 apr 2018 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Cessazione di Eric Yvon Courteille come persona con controllo significativo il 10 apr 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione di Nathalie Catherine Balla come persona con controllo significativo il 10 apr 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Lruk (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 07 nov 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Notifica di Eric Yvon Courteille come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Notifica di Nathalie Catherine Balla come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed holdsworth collections LIMITED\certificate issued on 13/01/16 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Burke come amministratore in data 16 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nathalie Catherine Balla come amministratore in data 07 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nathalie Catherine Balla come amministratore in data 07 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Saida Gallouj come amministratore in data 01 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Madame Saida Gallouj come amministratore in data 22 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Paul Kenworthy come amministratore in data 22 set 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURKE, Richard | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | Managing Director | 197432680001 | ||||
KENWORTHY, Paul | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | Finance Director | 191937270001 | ||||
TRULUCK, Michael Paul | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | British | Finance Director | 153010590002 | ||||
MCLAUGHLIN, Ellen | Segretario | 6 Wharfe Grove LS22 6HA Wetherby West Yorkshire | British | Solicitor | 125588610001 | |||||
OAKES, Frederick William, Mr. | Segretario | Tithe House Way HD2 1RD Huddersfield 18 West Yorkshire | British | 2304400001 | ||||||
BALLA, Nathalie Catherine | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | Chief Executive | 179486450001 | ||||
BOTT, Richard | Amministratore | 49 Henley Avenue WF12 0LN Dewsbury West Yorkshire | British | Warehouse Director | 49293190001 | |||||
CAMPBELL, William James | Amministratore | 2 Heather Gardens Scarcroft LS14 3HU Leeds West Yorkshire | British | Personnel Director | 2303760001 | |||||
DEVE, Francoise Suzanne Marcelle | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | France | French | Managing Director | 147082500001 | ||||
GALLOUJ, Saida, Madame | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | England | French | Managing Director | 191940150001 | ||||
GREEN, Marianne Mckenzie | Amministratore | The Owl House 19 Eagle Row WA13 0PY Lymm Cheshire | British | Director | 118854820001 | |||||
HARRIS, Michael John Charles | Amministratore | The Deri Bramhope Manor Moor Road Bramhope LS16 9HJ Leeds West Yorkshire | British | Director | 2307700001 | |||||
IZARD, Olivier Jacques Georges | Amministratore | Creskeld House Creskeld Lane Arthington LS21 1NU Otley West Yorkshire | French | Director | 87658610002 | |||||
JONES, Robert Glyn | Amministratore | 17 Wellington Lodge North Street Winkfield SL4 4TA Windsor Berkshire | British | Finance Director | 116871110002 | |||||
MADELEY, Jane Elisabeth | Amministratore | 102 Leeds Road Bramhope LS16 9AN Leeds West Yorkshire | England | British | Chief Financial Officer | 105516350002 | ||||
OHLSSON, Hans | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | Swedish | Managing Director | 133656790001 | ||||
ROBERTS, Andrew William | Amministratore | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire United Kingdom | England | British | Finance Director | 68177770002 | ||||
ROCHE, Stephane Marie Marcel | Amministratore | Hilly Ridge Grosvenor Road Headingley Leeds West Yorkshire | French | Director | 116192560002 | |||||
SKELSEY, Alistair James | Amministratore | Bluebill Lodge 79 Lower Mill Bank Triangle HX6 3ED Sowerby Bridge Halifax West Yorkshire | British | Merchandise Director | 74013420001 | |||||
SMITH, Peter James | Amministratore | Melville Margaret Avenue Bardsey LS17 9AT Leeds West Yorkshire | England | British | Director | 17125140001 | ||||
STEELE, Susan Ann | Amministratore | 15 Harrop Green Lane Diggle OL3 5LW Saddleworth Lancashire | British | Director | 104134730001 | |||||
THOMSON, Alan | Amministratore | Flat 3 Hamilton House, 4 Park Avenue HG2 9BQ Harrogate | United Kingdom | British | Finance Director | 122421940001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Ginette Moulin | 10 apr 2018 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | No | ||||||||||
Nazionalità: French Paese di residenza: France | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Monsieur Eric Yvon Courteille | 06 apr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: French Paese di residenza: France | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Madame Nathalie Catherine Balla | 06 apr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 West Yorkshire | Sì | ||||||||||
Nazionalità: French Paese di residenza: Belgium | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Lruk (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Holdsworth Street BD1 4AH Bradford 2 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LRUK (DORMANT NO.4) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Northern ireland deed of charge and assignment | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 12 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all its right title and interest in and to the applicable charged monies and to the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of charge and assignment | Creato il 28 ott 2003 Consegnato il 12 nov 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargor to the participant under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in and to the applicable charged monies; the originator collection accounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 nov 1990 Consegnato il 10 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as security agent for itself and the beneficiaries (as therein defined) under the terms of the facility agreement and the facility letter both of even date. | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A fourth supplemental trust deed | Creato il 27 nov 1990 Consegnato il 06 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Securing 6 3/8 percent debenture stock 1985/90, 8 3/4 percent debenture stock 1991/96 and 9 1/4 percent debenture stock 1994/99 created under the various trust deeds and all other moneys due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to royal exchange trust company limited as secured by this deed | |
Brevi particolari See doc M95 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0