00151652 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | 00151652 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00151652 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di 00151652 LIMITED?
- (5242) /
Dove si trova 00151652 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Silverworks 67-71 Northwood Street B3 1TX Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di 00151652 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| AMALGAMATED COTTON MILLS TRUST LIMITED(THE) | 12 ott 1918 | 12 ott 1918 |
Quali sono gli ultimi bilanci di 00151652 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 mar 2008 |
Quali sono le ultime deposizioni per 00151652 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 28 pagine | LIQ14 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2023 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2022 | 5 pagine | 4.68 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 st. Pauls Square Birmingham West Midlands B3 1QZ a The Silverworks 67-71 Northwood Street Birmingham West Midlands B3 1TX in data 30 mar 2022 | 2 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2022 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2021 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2021 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2020 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2020 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2019 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2019 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2018 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2018 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2017 | 5 pagine | 4.68 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Poppleton & Appleby 34-35 Ludgate Hill Birmingham B3 1EH a 30 st. Pauls Square Birmingham West Midlands B3 1QZ in data 16 mar 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2017 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2016 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2016 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2015 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2015 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2014 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2014 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 lug 2013 | 5 pagine | 4.68 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 12 gen 2013 | 5 pagine | 4.68 | ||
Chi sono gli amministratori di 00151652 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSELL, Terence John | Segretario | Elm Cottage Asheridge Road HP5 2XD Chesham Buckinghamshire | British | 97778790001 | ||||||
| HARRIS, John Graham | Amministratore | 17 Westfield Road Edgbaston B15 3QF Birmingham West Midlands | England | British | 2142680001 | |||||
| WATSON, Susan Margaret | Amministratore | Cressington 23 Four Oaks Road B74 2XT Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 2142690001 | |||||
| ALDRIDGE, Gemma Jane Constance | Segretario | 54 Crown Street HA2 0HR Harrow On The Hill Middlesex | British | 144966000001 | ||||||
| BARKER, Julie Faith | Segretario | 7 Spencer Road KT8 0SP East Molesey Surrey | British | 53016860001 | ||||||
| BATTY, Frederick Robson | Segretario | 17 Cloverdale Shelf HX3 7RP Halifax West Yorkshire | British | 1295110002 | ||||||
| BOOTH, Brenda | Segretario | 10 Trevor Road Flixton M41 5QH Manchester | British | 16249170001 | ||||||
| BOWMAR, Raymond | Segretario | 1 Metro Avenue DE55 5UF Newton Derbyshire | British | 47946970001 | ||||||
| JENKINS, David Huw | Segretario | 25 Wingfield Close The Common CF37 4AB Pontypridd | British | 76742540002 | ||||||
| MCEWAN, Andrew Gilmour | Segretario | 376 Wootton Road PE30 3EA Kings Lynn Norfolk | British | 2681910001 | ||||||
| O'LEARY, Simon Christopher | Segretario | 64 Plimsoll Road N4 2EE London | British | 72296420001 | ||||||
| O'LEARY, Simon Christopher | Segretario | 64 Plimsoll Road N4 2EE London | British | 72296420001 | ||||||
| ROSE, Belinda | Segretario | 45 Reginald Road HA6 1EF Northwood Middlesex | British | 90092080001 | ||||||
| STEPHENS, Julia | Segretario | Chapel Lodge Old Stockbridge Road Sutton Scotney SO21 3JW Winchester Hampshire | British | 63984570001 | ||||||
| TABRIZI, Saeed Rismanforoosh | Segretario | 127 Whitton Avenue East UB6 0QE Greenford Middlesex | British | 36580380001 | ||||||
| TABRIZI, Saeed Rismanforoosh | Segretario | 127 Whitton Avenue East UB6 0QE Greenford Middlesex | British | 36580380001 | ||||||
| TAYLOR, Noel Howard | Segretario | 7 Old Hartshay Hill DE5 3HU Ripley Derbyshire | British | 13254380001 | ||||||
| TAYLOR, Noel Howard | Segretario | 7 Old Hartshay Hill DE5 3HU Ripley Derbyshire | British | 13254380001 | ||||||
| WATSON, Susan Margaret | Segretario | Cressington 23 Four Oaks Road B74 2XT Sutton Coldfield West Midlands | British | 2142690001 | ||||||
| AKERMAN, David Lenton | Amministratore | 6 Chantry Close DE73 1ET Melbourne Derby | British | 86534370001 | ||||||
| BALL, John Adrian | Amministratore | Watersmeet Mill Lane RG9 3LY Shiplake Oxfordshire | British | 11182730003 | ||||||
| BENNETT, Nigel William | Amministratore | 33 Solent Road West Hampstead NW6 1TP London | British | 72570780001 | ||||||
| BURNETT, Patricia Ann | Amministratore | The Conifers Seabrook Road WD4 8NU Kings Langley Hertfordshire | England | British | 70101270002 | |||||
| CRANSTON, John Charles | Amministratore | 8 Nottingham Road NG25 0LF Southwell Nottinghamshire | England | British | 145205440001 | |||||
| DUNCAN, Peter Courtney | Amministratore | 23 Brewers Wharf NG24 1ET Newark Nottinghamshire | United Kingdom | British | 9496230002 | |||||
| FINNIGAN, John Allan, Dr | Amministratore | High Ground Moor Lane Long Preston BD23 4QQ Skipton North Yorkshire | British | 41461960001 | ||||||
| HARRISON, Fiona Mary | Amministratore | Yew Tree Cottage North Heath RG20 8UD Chieveley Newbury | British | 40555070001 | ||||||
| HARRISON, Fiona Mary | Amministratore | Yew Tree Cottage North Heath RG20 8UD Chieveley Newbury | British | 40555070001 | ||||||
| HEALY, Christopher William | Amministratore | 50 Marville Road Fulham SW6 7BD London | United Kingdom | British | 58484770001 | |||||
| HOLT, David Leslie Frank | Amministratore | Stonelow Flat Farm S42 7DE Eastmoor Derbyshire | British | 73659860001 | ||||||
| LEA, Jonathan David | Amministratore | Little Manor Fulmer Road SL9 7EF Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 67105270002 | |||||
| MORRISON, Barry | Amministratore | The Stables Bulls Yard Queen Street NG25 0AA Southwell Nottinghamshire | British | 36461280002 | ||||||
| MORRISON, Barry | Amministratore | The Stables Bulls Yard Queen Street NG25 0AA Southwell Nottinghamshire | British | 36461280002 | ||||||
| MOULDS, Adrian Paul | Amministratore | Ferris House Newbarn Lane HP9 2QZ Seer Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | 161093650001 | |||||
| MOULDS, Adrian Paul | Amministratore | Ferris House Newbarn Lane HP9 2QZ Seer Green Buckinghamshire | United Kingdom | British | 161093650001 |
00151652 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 10 dic 2008 Consegnato il 13 dic 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 mar 2006 Consegnato il 22 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 13 gen 2004 Consegnato il 15 gen 2004 | In corso | Importo garantito £25,850.00 and retained interest thereon due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Ground floor and part basement 8/9 high street marlborough. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 set 2003 Consegnato il 02 ott 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 feb 2003 Consegnato il 25 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 28 mag 1971 Consegnato il 04 giu 1971 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,323,906 debenture stock of carrying to viyella LTD | |
Brevi particolari Floating charge undertaking and all property and present and future including umcalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
00151652 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
| 2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0