C D BRAMALL YORK LIMITED

C D BRAMALL YORK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC D BRAMALL YORK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00154612
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C D BRAMALL YORK LIMITED?

    • Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LEEDHAMS (YORK) LIMITED25 apr 191925 apr 1919

    Quali sono gli ultimi bilanci di C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    8 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 ott 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 apr 2016

    Stato del capitale al 13 apr 2016

    • Capitale: GBP 30,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MALONEY, Richard James
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British110894220002
    CASHA, Martin Shaun
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish41114490010
    WILLIS, Mark Simon
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish257534220001
    PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Oakwood Court
    Little Oak Drive
    NG15 0DR Annesley
    Loxley House
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2304195
    110674970001
    BELL, Andrew Phillip
    20 Horner Street
    YO30 6EA York
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Horner Street
    YO30 6EA York
    North Yorkshire
    British52811590002
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Segretario
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    LEEDHAM, Iain Patrick John
    40 Vyner Street
    Haxby Road
    YO3 7HS York
    North Yorkshire
    Segretario
    40 Vyner Street
    Haxby Road
    YO3 7HS York
    North Yorkshire
    British26336150002
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    British41559790001
    BALBACK, Simon Robert
    Fairfield House 10 Manor Court
    Fairburn
    WF11 9NY Knottingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Fairfield House 10 Manor Court
    Fairburn
    WF11 9NY Knottingley
    West Yorkshire
    British69893120002
    BARTLEY, Charles
    68 Hunters Way
    Dringhouses
    YO2 2JJ York
    North Yorkshire
    Amministratore
    68 Hunters Way
    Dringhouses
    YO2 2JJ York
    North Yorkshire
    British10020110001
    BRAMALL, Douglas Charles Antony
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    Amministratore
    Warren Farm Warren Lane
    Brearton
    HG3 3DB Harrogate
    United KingdomBritish29331220001
    FINN, Trevor Garry
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish2652610013
    FORSYTH, David Robertson
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    Amministratore
    Scotland Cottage
    Melbourne
    DE73 1BH Derby
    United KingdomBritish55127120002
    GREGSON, Robin Anthony
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Lakeside
    East Morton
    BD20 5UY Keighley
    West Yorkshire
    EnglandEnglish107835250001
    HERBERT, Mark Philip
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish123285980005
    HOLDEN, Timothy Paul
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish148034310003
    HOLROYD, John
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Arncliffe House Farm
    Starbotton
    BD23 5HY Skipton
    North Yorkshire
    British21483450001
    LEEDHAM, Iain Patrick John
    2 Village Farm Main Street
    Shipton By Beningbrough
    YO30 1AB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    2 Village Farm Main Street
    Shipton By Beningbrough
    YO30 1AB York
    North Yorkshire
    British26336150003
    LEEDHAM, John Edgar
    6 Millfield Rise
    YO6 3NE Easingwold
    N Yorks
    Amministratore
    6 Millfield Rise
    YO6 3NE Easingwold
    N Yorks
    British10062300001
    LEEDHAM, Rachel Louise
    Field House Providence Farm
    Low Crankley Easingwold
    YO61 3NY York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Field House Providence Farm
    Low Crankley Easingwold
    YO61 3NY York
    North Yorkshire
    EnglandBritish126468780001
    STEEL, Richard Alan
    4 Ruffhams Close
    Wheldrake
    YO19 6TD York
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Ruffhams Close
    Wheldrake
    YO19 6TD York
    North Yorkshire
    British69939790001
    SYKES, Hilary Claire
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Loxley House 2 0akwood Court
    Little Oak Drive Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41559790001
    WINFIELD, Garry Stephen
    Service Station
    52 St Annes Drive
    S80 3QD Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Service Station
    52 St Annes Drive
    S80 3QD Worksop
    Nottinghamshire
    British58488830001

    Chi sono le persone con controllo significativo di C D BRAMALL YORK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    C D Bramall Limited
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    06 apr 2016
    Little Oak Drive
    Annesley
    NG15 0DR Nottingham
    Loxley House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione444795
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    C D BRAMALL YORK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 13 mag 2009
    Consegnato il 21 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Secured Parties (The Override Agent)
    Transazioni
    • 21 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties
    Creato il 13 giu 2002
    Consegnato il 21 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 05 nov 1999
    Consegnato il 09 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge the undertaiking and all its property assets and rights including any uncalled capital. By way of specific charge all charged property being the debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 03 ago 1998
    Consegnato il 05 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed floating charge the whole of the company's title and interest from time to time in all the undertaking property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including any uncalled capital of the company and including used motor vehicles.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • General Motors Acceptance Corporation (UK) PLC
    Transazioni
    • 05 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1998
    Consegnato il 21 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Wayside garage malton road york north yorkshire t/no;-NYK126085. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 ott 1992
    Consegnato il 14 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over and goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 set 1992
    Consegnato il 09 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £115,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees
    Brevi particolari
    Wayside garage malton road york north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • John Edgar Leedham and Shirley Leedham
    Transazioni
    • 09 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement for loan
    Creato il 11 lug 1991
    Consegnato il 13 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,200
    Brevi particolari
    Ix sun electric vauxhall engine diagnostic unit serial no 2110307 complete with ix sgm 2004 T080 4 gas analyser module (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Alexander Duckham & Co., Limited
    Transazioni
    • 13 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 26 feb 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable charge without written instrument
    Creato il 21 dic 1989
    Consegnato il 09 gen 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 3 queen's staith mews skeldergate york title no nyk 309 21.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 mar 1988
    Consegnato il 21 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The unregistered and f/h property k/a premises at tanner street, tanners moat and rougier street, york.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 ago 1984
    Consegnato il 23 ago 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property situate at rougier street wellington row tanner street tanner moat and tanner row york. Title no nyk 16802. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • General Motors Acceptance Corporation (U.K.) Limited
    Transazioni
    • 23 ago 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 nov 1982
    Consegnato il 01 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property situate in rougier street and tanner street, york and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1982
    Consegnato il 03 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises being wa'side garage malton road york and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 nov 1982
    Consegnato il 03 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1982
    Consegnato il 03 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H lands & premises being wa'side garage, malton road york.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 1981
    Consegnato il 24 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bushell's warehouse, tanner row, york north yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 08 lug 1977
    Consegnato il 13 lug 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Various plots of land and premises all in york. Together with all fixtures ( see doc 107 for full details ).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 lug 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0