C D BRAMALL YORK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | C D BRAMALL YORK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00154612 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di C D BRAMALL YORK LIMITED?
- Vendita al dettaglio di autovetture nuove (45111) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Vendita al dettaglio di autovetture usate (45112) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LEEDHAMS (YORK) LIMITED | 25 apr 1919 | 25 apr 1919 |
Quali sono gli ultimi bilanci di C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Philip Herbert come amministratore in data 30 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Simon Willis come amministratore in data 08 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Philip Herbert come amministratore in data 01 apr 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Trevor Garry Finn come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Paul Holden come amministratore in data 31 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 31 ott 2018
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come segretario in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Hilary Claire Sykes come amministratore in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Trevor Garry Finn il 18 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Timothy Paul Holden il 26 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONEY, Richard James | Segretario | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | 110894220002 | ||||||||||
| CASHA, Martin Shaun | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 41114490010 | |||||||||
| WILLIS, Mark Simon | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 257534220001 | |||||||||
| PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Amministratore | 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Loxley House Nottinghamshire United Kingdom |
| 110674970001 | ||||||||||
| BELL, Andrew Phillip | Segretario | 20 Horner Street YO30 6EA York North Yorkshire | British | 52811590002 | ||||||||||
| HOLROYD, John | Segretario | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | 21483450001 | ||||||||||
| LEEDHAM, Iain Patrick John | Segretario | 40 Vyner Street Haxby Road YO3 7HS York North Yorkshire | British | 26336150002 | ||||||||||
| SYKES, Hilary Claire | Segretario | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | 41559790001 | ||||||||||
| BALBACK, Simon Robert | Amministratore | Fairfield House 10 Manor Court Fairburn WF11 9NY Knottingley West Yorkshire | British | 69893120002 | ||||||||||
| BARTLEY, Charles | Amministratore | 68 Hunters Way Dringhouses YO2 2JJ York North Yorkshire | British | 10020110001 | ||||||||||
| BRAMALL, Douglas Charles Antony | Amministratore | Warren Farm Warren Lane Brearton HG3 3DB Harrogate | United Kingdom | British | 29331220001 | |||||||||
| FINN, Trevor Garry | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 2652610013 | |||||||||
| FORSYTH, David Robertson | Amministratore | Scotland Cottage Melbourne DE73 1BH Derby | United Kingdom | British | 55127120002 | |||||||||
| GREGSON, Robin Anthony | Amministratore | 2 Lakeside East Morton BD20 5UY Keighley West Yorkshire | England | English | 107835250001 | |||||||||
| HERBERT, Mark Philip | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 123285980005 | |||||||||
| HOLDEN, Timothy Paul | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 148034310003 | |||||||||
| HOLROYD, John | Amministratore | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | 21483450001 | ||||||||||
| LEEDHAM, Iain Patrick John | Amministratore | 2 Village Farm Main Street Shipton By Beningbrough YO30 1AB York North Yorkshire | British | 26336150003 | ||||||||||
| LEEDHAM, John Edgar | Amministratore | 6 Millfield Rise YO6 3NE Easingwold N Yorks | British | 10062300001 | ||||||||||
| LEEDHAM, Rachel Louise | Amministratore | Field House Providence Farm Low Crankley Easingwold YO61 3NY York North Yorkshire | England | British | 126468780001 | |||||||||
| STEEL, Richard Alan | Amministratore | 4 Ruffhams Close Wheldrake YO19 6TD York North Yorkshire | British | 69939790001 | ||||||||||
| SYKES, Hilary Claire | Amministratore | Loxley House 2 0akwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 41559790001 | |||||||||
| WINFIELD, Garry Stephen | Amministratore | Service Station 52 St Annes Drive S80 3QD Worksop Nottinghamshire | British | 58488830001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di C D BRAMALL YORK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C D Bramall Limited | 06 apr 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
C D BRAMALL YORK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Creato il 13 mag 2009 Consegnato il 21 mag 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties | Creato il 13 giu 2002 Consegnato il 21 giu 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 05 nov 1999 Consegnato il 09 nov 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge the undertaiking and all its property assets and rights including any uncalled capital. By way of specific charge all charged property being the debts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 03 ago 1998 Consegnato il 05 ago 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed floating charge the whole of the company's title and interest from time to time in all the undertaking property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future including any uncalled capital of the company and including used motor vehicles.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 13 gen 1998 Consegnato il 21 gen 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Wayside garage malton road york north yorkshire t/no;-NYK126085. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 13 ott 1992 Consegnato il 14 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over and goodwill bookdebts and patents. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 07 set 1992 Consegnato il 09 set 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £115,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargees | |
Brevi particolari Wayside garage malton road york north yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Agreement for loan | Creato il 11 lug 1991 Consegnato il 13 lug 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,200 | |
Brevi particolari Ix sun electric vauxhall engine diagnostic unit serial no 2110307 complete with ix sgm 2004 T080 4 gas analyser module (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Equitable charge without written instrument | Creato il 21 dic 1989 Consegnato il 09 gen 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a 3 queen's staith mews skeldergate york title no nyk 309 21. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 mar 1988 Consegnato il 21 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The unregistered and f/h property k/a premises at tanner street, tanners moat and rougier street, york. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 15 ago 1984 Consegnato il 23 ago 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal mortgage over property situate at rougier street wellington row tanner street tanner moat and tanner row york. Title no nyk 16802. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 nov 1982 Consegnato il 01 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property situate in rougier street and tanner street, york and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1982 Consegnato il 03 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H lands & premises being wa'side garage malton road york and the proceeds of sale thereof. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 29 nov 1982 Consegnato il 03 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 nov 1982 Consegnato il 03 dic 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H lands & premises being wa'side garage, malton road york. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 20 lug 1981 Consegnato il 24 lug 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Bushell's warehouse, tanner row, york north yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 08 lug 1977 Consegnato il 13 lug 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Various plots of land and premises all in york. Together with all fixtures ( see doc 107 for full details ). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0