CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00156617 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | PWC 8th Floor Central Square 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds West Yorkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TARMAC CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED | 15 mar 1996 | 15 mar 1996 |
WIMPEY CONSTRUCTION LIMITED | 03 feb 1988 | 03 feb 1988 |
WIMPEY CONSTRUCTION UK LIMITED | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
GEORGE WIMPEY & CO LIMITED | 02 lug 1919 | 02 lug 1919 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2017 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2018 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 21 dic 2018 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 gen 2019 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 21 dic 2017 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 22 lug 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Construction Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Westley Maffei come amministratore in data 09 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 08 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 08 ago 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Westley Maffei come amministratore in data 01 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy Francis George come amministratore in data 30 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee James Mills il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Francis George il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 02 mar 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR, United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 02 mar 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , 24 Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 02 mar 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 dic 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 21 dic 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORT, Stefan Edward | Segretario | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | Company Secretary | 32824200005 | |||||
FITZHUGH, Dirk Olaf | Segretario | Beesdau House Mount Road Tettenhall Wood WV6 8HT Wolverhampton | British | 612090001 | ||||||
INGRAM, Peter William Irving | Segretario | 40 Landford Road SW15 1AG London | British | 1359100001 | ||||||
MCCORMACK, James Joseph | Segretario | Broome House Chapel Lane Knockin Heath SY10 8EB Oswestry Shropshire | British | Barrister | 678610003 | |||||
MCEWAN, Euan | Segretario | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | Financier | 110597480001 | |||||
TAPP, Richard Francis | Segretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | British | 173852420001 | ||||||
ANDERSON, David Joseph Alfred | Amministratore | 9 Tithe Meadows GU25 4EU Virgina Water Surrey | England | British | Director | 92518640001 | ||||
BATES, Kenneth Frank | Amministratore | 6 Bramwell Drive Highfields WS6 7PQ Cheslyn Hay West Midlands | British | Engineer | 25969700002 | |||||
BEAUPREZ, Richard Joseph | Amministratore | 16 Dale Close SG4 9AS Hitchin Hertfordshire | British | Accountant | 4079700001 | |||||
BENSON, Richard George | Amministratore | Halston House Lea Cross SY5 8JQ Ne Shrewsbury Salop | British | Commercial Director Transport | 103405290001 | |||||
BERNARD, Peter David | Amministratore | 16 Avenue Road TW11 0BT Teddington Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 34673830001 | ||||
BLACKER, Michael | Amministratore | 46 Ridgeway RG10 8AS Wargrave Berkshire | England | British | Legal Adviser | 120377750001 | ||||
BRANT, Dennis | Amministratore | 11 Ranelagh Drive North Grassenoale L19 9DS Liverpool | British | Director | 79472910001 | |||||
CASEBOURNE, Michael Victor | Amministratore | The Boundary Ballards Farm Road CR2 7JA South Croydon Surrey | British | Civil Engineer | 3792090001 | |||||
CLARKE, Michael Charles | Amministratore | Heron Lodge 3 Barrington Park Gardens HP8 4SS Chalfont St Giles Bucks | British | Chartered Civil Engineer | 71837170001 | |||||
FARMER, Arthur George | Amministratore | 17 Larkspur Close RG11 2NA Wokingham Berkshire | British | Chartered Engineer | 8015630001 | |||||
GEORGE, Timothy Francis | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | Chartered Secretary | 24075160004 | ||||
GREY, Peter John | Amministratore | Hameldown Higham RG7 5UJ Reading Berkshire | British | Marketing Director | 35824520001 | |||||
HAIGH, Allan Johnson | Amministratore | 404 Finchampstead Road Finchampstead RG40 3RA Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Building Contractor | 63056350001 | ||||
HORNER, David John | Amministratore | Mingary The Dell SP11 0LF Vernham Dean Hants | British | Director | 32837390001 | |||||
KENNEDY, Francis Milne | Amministratore | Aughton 36 St Albans Road RH2 9LN Reigate Surrey | British | Civil Engineer | 3792110001 | |||||
KING, John Ernest | Amministratore | 1 Blades Close KT22 7JY Leatherhead Surrey | British | Accountant | 427680001 | |||||
LOVELL, Anthony Brian | Amministratore | Windygates 40 Four Oaks Road B74 2TL Sutton Coldfield West Midlands | British | Business Executive | 47038900001 | |||||
MACIVER, Roderick David | Amministratore | 81 Esher Road KT8 0AQ East Molesey Surrey | England | British | Company Director | 8015650001 | ||||
MAFFEI, Westley Anthony | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | Assistant Company Secretary | 189962560002 | ||||
MARTIN, William Roy | Amministratore | 19 Lancaster Road TW1 1HR Twickenham Middlesex | British | Construction Engineer | 7681870001 | |||||
MCEWAN, Euan | Amministratore | 2 Bradshaw Close The Fairways PE28 4UZ Brampton Cambridgeshire | British | Chartered Accountant | 110597480001 | |||||
MILLS, Lee James | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 53951880001 | ||||
NICOLETTI, Bernard Rene Hughes | Amministratore | 357 Avenue De Fabron Nice F-06200 France | French | Chairman & Md | 56047920001 | |||||
PELLARD, Brian | Amministratore | 33 Wyvern Road B74 2PS Sutton Coldfield West Midlands | British | Civil Engineer | 33408310001 | |||||
ROSS, Ian Malcolm | Amministratore | 29 Mount Pleasant Close GU18 5TR Lightwater Surrey | British | Commercial Director | 1116930001 | |||||
SMOUT, Martin John | Amministratore | Greatfield Isington GU34 4PJ Near Alton Hampshire | United Kingdom | British | Md Carillion Building | 117017210001 | ||||
TOMAN, Lewis David | Amministratore | Old Orchard The Street Ubley BS18 8PJ Bristol Avon | British | Company Director | 32828350001 | |||||
TURNER, Gary Harold | Amministratore | 1 Mclean Drive Priorslee TF2 9RT Telford Shropshire | England | British | Commercial Director | 92534020001 | ||||
WOOD, Michael James | Amministratore | 2 Autumn Walk Wargrave RG10 8BS Reading | United Kingdom | British | Chemical Engineer | 62934890001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carillion Construction Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Creato il 21 feb 1990 Consegnato il 01 mar 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-contract dated 21ST february 1990. | |
Brevi particolari All rights, benefits and interests of the company under a building contract dated 21ST february 1990 between boundary post limited and the company. (See form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 set 1989 Consegnato il 05 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16TH may 1989 | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all its estate or interest in the f/h property k/a land at mansfield road & fulforth street nottingham. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 16 mag 1989 Consegnato il 31 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,000,000 and all other monies due or to become due from the company to banque indosuez under the terms of a facility agreement of even date and the charge | |
Brevi particolari Legal mortgage over property known as all that land and buildings thereon encompassed by mansfield road, woodborough road and huntingdon street, nottingham, together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery by way of assignment the benefit of all contracts agreements etc (see M89C for details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 20 nov 1985 Consegnato il 05 dic 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £150,000 | |
Brevi particolari F/H land situate on the west & east sides of lingham lane moreton merseyside title ms 89249. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 11 ago 1980 Consegnato il 26 ago 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Several plots of land situate at wallasey in the county of chester and formerly k/a moreton brick works. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Standard security presented for registration at the register of sasines on the 13TH jan 76. | Creato il 17 dic 1975 Consegnato il 29 gen 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £377,325 | |
Brevi particolari Area of ground at raith kirkcaldy, county of fife. Extending to 43 acres or thereby. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 16 dic 1974 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 86,442 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Lot 2, plan of subdivision 113348, parish of haree loorran, county of mornington. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 24 apr 1974 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 240,000 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Land pt of crown allotment a sect 22 parish of mooroolbark, county of evelyn. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 01 apr 1974 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 114,943 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Lot 1 & 2 on plan of subdivision 113573 parish of harree loorran, county of mornington. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 nov 1973 Consegnato il 28 nov 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari 146.5 acres at west hove sussex as described in an conveyance dated 31.8.59 and or transfer dated 16.4.73. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of mortgage | Creato il 10 ott 1973 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 254,000 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Land in the county of cumberland parish of minto city of cambelltown. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 09 ott 1973 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 70,436 australian dollars & all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Lot 2 of plan of subdivision 85290, parish of scoresby, county of mornington. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 01 ott 1973 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito Us $ 96,309 australian dollars and all other monies due or to become due | |
Brevi particolari Lot 2 on plan of subdivision 8661, pt of crown allotment 42, parish of scoresby, county of mornington. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage registered in australia | Creato il 14 mag 1973 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito UK $ 147,468.75 australian dollars and all monies due or to become due | |
Brevi particolari Pt of lot 6,7 & 8 on plan sub division 4287 pt of crown allotment 48 parish of mooroobark county of mornington. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memorandum of mortgage registered in australia | Creato il 02 ott 1970 Consegnato il 13 nov 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Land in parish of botany, county of cumberland vol 8274 folio 199. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0