CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED

CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00156617
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    PWC
    8th Floor Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TARMAC CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED15 mar 199615 mar 1996
    WIMPEY CONSTRUCTION LIMITED03 feb 198803 feb 1988
    WIMPEY CONSTRUCTION UK LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    GEORGE WIMPEY & CO LIMITED02 lug 191902 lug 1919

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2018
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 dic 2018
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma04 gen 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al21 dic 2017
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Indirizzo della sede legale modificato da , Crown House Birch Street, Wolverhampton, WV1 4JX, United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 22 lug 2019

    2 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Carillion Construction Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 01 ott 2018

    1 pagineAD01

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Westley Maffei come amministratore in data 09 ago 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lee James Mills come amministratore in data 08 ago 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come segretario in data 08 ago 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Westley Maffei come amministratore in data 01 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Francis George come amministratore in data 30 giu 2017

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 dic 2015

    Stato del capitale al 21 dic 2015

    • Capitale: GBP 64,000,000
    • Capitale: USD 2,560,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee James Mills il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Francis George il 02 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 02 mar 2015

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da , Carillion House 84 Salop Street, Wolverhampton, WV3 0SR, United Kingdom a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 02 mar 2015

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 24 Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY a 8th Floor Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 02 mar 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2014

    Stato del capitale al 22 dic 2014

    • Capitale: GBP 64,000,000
    • Capitale: USD 2,560,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2013

    Stato del capitale al 23 dic 2013

    • Capitale: GBP 64,000,000
    • Capitale: USD 2,560,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BORT, Stefan Edward
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    Segretario
    126 Grove Park
    SE5 8LD London
    BritishCompany Secretary32824200005
    FITZHUGH, Dirk Olaf
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    Segretario
    Beesdau House Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HT Wolverhampton
    British612090001
    INGRAM, Peter William Irving
    40 Landford Road
    SW15 1AG London
    Segretario
    40 Landford Road
    SW15 1AG London
    British1359100001
    MCCORMACK, James Joseph
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    Segretario
    Broome House
    Chapel Lane Knockin Heath
    SY10 8EB Oswestry
    Shropshire
    BritishBarrister678610003
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Segretario
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    BritishFinancier110597480001
    TAPP, Richard Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Segretario
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    British173852420001
    ANDERSON, David Joseph Alfred
    9 Tithe Meadows
    GU25 4EU Virgina Water
    Surrey
    Amministratore
    9 Tithe Meadows
    GU25 4EU Virgina Water
    Surrey
    EnglandBritishDirector92518640001
    BATES, Kenneth Frank
    6 Bramwell Drive
    Highfields
    WS6 7PQ Cheslyn Hay
    West Midlands
    Amministratore
    6 Bramwell Drive
    Highfields
    WS6 7PQ Cheslyn Hay
    West Midlands
    BritishEngineer25969700002
    BEAUPREZ, Richard Joseph
    16 Dale Close
    SG4 9AS Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    16 Dale Close
    SG4 9AS Hitchin
    Hertfordshire
    BritishAccountant4079700001
    BENSON, Richard George
    Halston House
    Lea Cross
    SY5 8JQ Ne Shrewsbury
    Salop
    Amministratore
    Halston House
    Lea Cross
    SY5 8JQ Ne Shrewsbury
    Salop
    BritishCommercial Director Transport103405290001
    BERNARD, Peter David
    16 Avenue Road
    TW11 0BT Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    16 Avenue Road
    TW11 0BT Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor34673830001
    BLACKER, Michael
    46 Ridgeway
    RG10 8AS Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    46 Ridgeway
    RG10 8AS Wargrave
    Berkshire
    EnglandBritishLegal Adviser120377750001
    BRANT, Dennis
    11 Ranelagh Drive North
    Grassenoale
    L19 9DS Liverpool
    Amministratore
    11 Ranelagh Drive North
    Grassenoale
    L19 9DS Liverpool
    BritishDirector79472910001
    CASEBOURNE, Michael Victor
    The Boundary Ballards Farm Road
    CR2 7JA South Croydon
    Surrey
    Amministratore
    The Boundary Ballards Farm Road
    CR2 7JA South Croydon
    Surrey
    BritishCivil Engineer3792090001
    CLARKE, Michael Charles
    Heron Lodge
    3 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St Giles
    Bucks
    Amministratore
    Heron Lodge
    3 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St Giles
    Bucks
    BritishChartered Civil Engineer71837170001
    FARMER, Arthur George
    17 Larkspur Close
    RG11 2NA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    17 Larkspur Close
    RG11 2NA Wokingham
    Berkshire
    BritishChartered Engineer8015630001
    GEORGE, Timothy Francis
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary24075160004
    GREY, Peter John
    Hameldown
    Higham
    RG7 5UJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Hameldown
    Higham
    RG7 5UJ Reading
    Berkshire
    BritishMarketing Director35824520001
    HAIGH, Allan Johnson
    404 Finchampstead Road
    Finchampstead
    RG40 3RA Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    404 Finchampstead Road
    Finchampstead
    RG40 3RA Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishBuilding Contractor63056350001
    HORNER, David John
    Mingary
    The Dell
    SP11 0LF Vernham Dean
    Hants
    Amministratore
    Mingary
    The Dell
    SP11 0LF Vernham Dean
    Hants
    BritishDirector32837390001
    KENNEDY, Francis Milne
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Aughton
    36 St Albans Road
    RH2 9LN Reigate
    Surrey
    BritishCivil Engineer3792110001
    KING, John Ernest
    1 Blades Close
    KT22 7JY Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    1 Blades Close
    KT22 7JY Leatherhead
    Surrey
    BritishAccountant427680001
    LOVELL, Anthony Brian
    Windygates
    40 Four Oaks Road
    B74 2TL Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Windygates
    40 Four Oaks Road
    B74 2TL Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishBusiness Executive47038900001
    MACIVER, Roderick David
    81 Esher Road
    KT8 0AQ East Molesey
    Surrey
    Amministratore
    81 Esher Road
    KT8 0AQ East Molesey
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director8015650001
    MAFFEI, Westley Anthony
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAssistant Company Secretary189962560002
    MARTIN, William Roy
    19 Lancaster Road
    TW1 1HR Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    19 Lancaster Road
    TW1 1HR Twickenham
    Middlesex
    BritishConstruction Engineer7681870001
    MCEWAN, Euan
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    Amministratore
    2 Bradshaw Close
    The Fairways
    PE28 4UZ Brampton
    Cambridgeshire
    BritishChartered Accountant110597480001
    MILLS, Lee James
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    Amministratore
    84 Salop Street
    WV3 0SR Wolverhampton
    Carillion House
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant53951880001
    NICOLETTI, Bernard Rene Hughes
    357 Avenue De Fabron
    Nice F-06200
    France
    Amministratore
    357 Avenue De Fabron
    Nice F-06200
    France
    FrenchChairman & Md56047920001
    PELLARD, Brian
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    33 Wyvern Road
    B74 2PS Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishCivil Engineer33408310001
    ROSS, Ian Malcolm
    29 Mount Pleasant Close
    GU18 5TR Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    29 Mount Pleasant Close
    GU18 5TR Lightwater
    Surrey
    BritishCommercial Director1116930001
    SMOUT, Martin John
    Greatfield
    Isington
    GU34 4PJ Near Alton
    Hampshire
    Amministratore
    Greatfield
    Isington
    GU34 4PJ Near Alton
    Hampshire
    United KingdomBritishMd Carillion Building117017210001
    TOMAN, Lewis David
    Old Orchard
    The Street Ubley
    BS18 8PJ Bristol
    Avon
    Amministratore
    Old Orchard
    The Street Ubley
    BS18 8PJ Bristol
    Avon
    BritishCompany Director32828350001
    TURNER, Gary Harold
    1 Mclean Drive
    Priorslee
    TF2 9RT Telford
    Shropshire
    Amministratore
    1 Mclean Drive
    Priorslee
    TF2 9RT Telford
    Shropshire
    EnglandBritishCommercial Director92534020001
    WOOD, Michael James
    2 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    Amministratore
    2 Autumn Walk
    Wargrave
    RG10 8BS Reading
    United KingdomBritishChemical Engineer62934890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Birch Street
    WV1 4JX Wolverhampton
    Crown House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione594581
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 feb 1990
    Consegnato il 01 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-contract dated 21ST february 1990.
    Brevi particolari
    All rights, benefits and interests of the company under a building contract dated 21ST february 1990 between boundary post limited and the company. (See form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Bfu (Contractors) Limited
    Transazioni
    • 01 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 set 1989
    Consegnato il 05 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 16TH may 1989
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all its estate or interest in the f/h property k/a land at mansfield road & fulforth street nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 05 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 mag 1989
    Consegnato il 31 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5,000,000 and all other monies due or to become due from the company to banque indosuez under the terms of a facility agreement of even date and the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property known as all that land and buildings thereon encompassed by mansfield road, woodborough road and huntingdon street, nottingham, together with all buildings fixtures and fittings and fixed plant and machinery by way of assignment the benefit of all contracts agreements etc (see M89C for details).
    Persone aventi diritto
    • Banque Indosuez
    Transazioni
    • 31 mag 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 10 lug 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 1985
    Consegnato il 05 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    F/H land situate on the west & east sides of lingham lane moreton merseyside title ms 89249.
    Persone aventi diritto
    • Ashton and Mccaul Limited
    Transazioni
    • 05 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 11 ago 1980
    Consegnato il 26 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Several plots of land situate at wallasey in the county of chester and formerly k/a moreton brick works.
    Persone aventi diritto
    • Barker & Jones LTD
    Transazioni
    • 26 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration at the register of sasines on the 13TH jan 76.
    Creato il 17 dic 1975
    Consegnato il 29 gen 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £377,325
    Brevi particolari
    Area of ground at raith kirkcaldy, county of fife. Extending to 43 acres or thereby.
    Persone aventi diritto
    • Abbotshall Builders Limited
    Transazioni
    • 29 gen 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage registered in australia
    Creato il 16 dic 1974
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 86,442 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Lot 2, plan of subdivision 113348, parish of haree loorran, county of mornington.
    Persone aventi diritto
    • F G Fordham
    • C V Fordham
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage registered in australia
    Creato il 24 apr 1974
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 240,000 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Land pt of crown allotment a sect 22 parish of mooroolbark, county of evelyn.
    Persone aventi diritto
    • Taunton Developments Pty LTD
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage registered in australia
    Creato il 01 apr 1974
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 114,943 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Lot 1 & 2 on plan of subdivision 113573 parish of harree loorran, county of mornington.
    Persone aventi diritto
    • E J Faulds.
    • W Faulds
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 nov 1973
    Consegnato il 28 nov 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    146.5 acres at west hove sussex as described in an conveyance dated 31.8.59 and or transfer dated 16.4.73.
    Persone aventi diritto
    • Javstry Investments LTD
    Transazioni
    • 28 nov 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 05 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of mortgage
    Creato il 10 ott 1973
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 254,000 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Land in the county of cumberland parish of minto city of cambelltown.
    Persone aventi diritto
    • N W Harris
    • E P Blain
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage registered in australia
    Creato il 09 ott 1973
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 70,436 australian dollars & all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Lot 2 of plan of subdivision 85290, parish of scoresby, county of mornington.
    Persone aventi diritto
    • H E Moffatt
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage registered in australia
    Creato il 01 ott 1973
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Us $ 96,309 australian dollars and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    Lot 2 on plan of subdivision 8661, pt of crown allotment 42, parish of scoresby, county of mornington.
    Persone aventi diritto
    • E a Voigt
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage registered in australia
    Creato il 14 mag 1973
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    UK $ 147,468.75 australian dollars and all monies due or to become due
    Brevi particolari
    Pt of lot 6,7 & 8 on plan sub division 4287 pt of crown allotment 48 parish of mooroobark county of mornington.
    Persone aventi diritto
    • G M Chandler
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of mortgage registered in australia
    Creato il 02 ott 1970
    Consegnato il 13 nov 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land in parish of botany, county of cumberland vol 8274 folio 199.
    Persone aventi diritto
    • Rural Bank of New South Wales
    Transazioni
    • 13 nov 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 08 mar 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CARILLION CONSTRUCTION (CONTRACTS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 giu 2018Data della petizione
    08 ago 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0