L.R.RUSSELL LIMITED

L.R.RUSSELL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàL.R.RUSSELL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00156981
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di L.R.RUSSELL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova L.R.RUSSELL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di L.R.RUSSELL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al27 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per L.R.RUSSELL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015

    8 pagineAA

    Seconda presentazione per la cessazione di Nils Olin Steinmeyer come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore

    4 pagineRP04TM01

    Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2016

    Stato del capitale al 18 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    22 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 10 mar 2016

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    22 set 2016Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016.

    Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 23 feb 2016

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 mag 2015

    Stato del capitale al 22 mag 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 22 mag 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mag 2014

    Stato del capitale al 19 mag 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2012

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Nomina di Mr Kevin Michael Bradshaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di L.R.RUSSELL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Segretario
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    British50457500001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    Segretario
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    Segretario
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    British28975060001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Segretario
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Segretario
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    British1470160001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    CAUNCE, John Geoffrey
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    Amministratore
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director1470170001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    Amministratore
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    Amministratore
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    BritishCompany Director50457500001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    Amministratore
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    Amministratore
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    Amministratore
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    Amministratore
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    BritishCompany Director1470160001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    VAUGHAN, David John
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    Amministratore
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishSolicitor44521810001

    L.R.RUSSELL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 24 feb 2009
    Consegnato il 04 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    Transazioni
    • 04 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 26 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 13 gen 1995
    Consegnato il 25 gen 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 gen 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 08 dic 1992
    Consegnato il 23 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mar 1988
    Consegnato il 05 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited.
    Transazioni
    • 05 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1991Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 23 mar 1988
    Consegnato il 05 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business.
    Persone aventi diritto
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transazioni
    • 05 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 29 set 1982
    Consegnato il 11 ott 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ott 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 mar 1980
    Consegnato il 26 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 nov 1972
    Consegnato il 14 dic 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Inst of charge
    Creato il 16 feb 1959
    Consegnato il 04 mar 1959
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc.
    Brevi particolari
    Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate.
    Persone aventi diritto
    • Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 04 mar 1959Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 16 apr 1936
    Consegnato il 16 apr 1936
    Soddisfatta integralmente
    Transazioni
    • 16 apr 1936Registrazione di un'ipoteca
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0