L.R.RUSSELL LIMITED
Panoramica
Nome della società | L.R.RUSSELL LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00156981 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di L.R.RUSSELL LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova L.R.RUSSELL LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Wyevale Garden Centres Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Middlesex England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di L.R.RUSSELL LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 27 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per L.R.RUSSELL LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Justin Matthew King come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Nils Olin Steinmeyer come amministratore | 4 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Kevin Michael Bradshaw come amministratore | 4 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Justin Matthew King come amministratore in data 18 ago 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 18 ago 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Gerald Jones il 22 lug 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Stephen Thomas Murphy come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Roger Mclaughlan come amministratore in data 10 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nils Olin Steinmeyer come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Anthony Gerald Jones come amministratore in data 06 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Michael Bradshaw come amministratore in data 10 mar 2016 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 23 feb 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 28 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF a Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF in data 22 mag 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 dic 2012 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 28 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kevin Michael Bradshaw come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di L.R.RUSSELL LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONES, Anthony Gerald | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Cfo | 212265950001 | ||||
MCLAUGHLAN, Roger | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Ceo | 206428840001 | ||||
FORREST, David Mervyn | Segretario | Clouds Farm Drayton TA10 0JT Langport Somerset | British | 50457500001 | ||||||
JONES, Anthony David | Segretario | 14 Brownhill Crescent LE7 7LA Rothley Leicestershire | British | Chartered Accountant | 73622510001 | |||||
MURFIN, Stephen | Segretario | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Company Director | 8690590001 | |||||
PEARCE, Patrick John | Segretario | Blue Cedars Bunces Lane Burghfield Common RG7 3DL Reading Berkshire | British | 28975060001 | ||||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Segretario | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | British | Finance Director | 76162020001 | |||||
SPENCER SMITH, Thomas Peter | Segretario | The Old Rectory Llanvetherine NP7 8RG Abergavenny Gwent | British | 1470160001 | ||||||
BRADSHAW, Kevin Michael | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | England | British | Company Director | 124019940001 | ||||
BRIGDEN, Peter | Amministratore | 16 Woodstock Gardens Appleton WA4 5HN Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director Of Retail Operation | 195802400001 | ||||
CAUNCE, John Geoffrey | Amministratore | 16 Beaconsfield Road Claygate KT10 0PW Esher Surrey | British | Company Director | 1470170001 | |||||
FAVELL, Gary Alan | Amministratore | Yates House Foldshaw Lane Braithwaite HG3 4AN Harrogate Yorks | United Kingdom | British | Chief Executive | 107699240001 | ||||
FORREST, David Mervyn | Amministratore | Clouds Farm Drayton TA10 0JT Langport Somerset | British | Company Director | 50457500001 | |||||
HEWITT, Robert John | Amministratore | The Old Cider Mill 2 Cotts Farm Cotts Lane HR1 3ND Lugwardine Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 15486070002 | ||||
HODKINSON, James Clifford | Amministratore | 29b Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | England | British | Company Director | 606430001 | ||||
JENKINSON, Antonia Scarlett | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | United Kingdom | British | Investment Banker | 72128340003 | ||||
KING, Justin Matthew | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Director | 213157990001 | ||||
KOZLOWSKI, Richard Leon | Amministratore | 34 Stubbs Wood HP6 6EX Amersham Buckinghamshire | England | British | Director | 124967710001 | ||||
LIVINGSTON, William Andrew | Amministratore | 3 Barnes Close St Cross SO23 9QX Winchester Hampshire | England | British | Commercial Director | 111439220001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Amministratore | Syon Park TW8 8JF Brentford The Garden Centre Group Middlesex England | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour | Amministratore | Glan Honddu House Llandefaelog Fach LD3 9PP Brecon Powys | Wales | British | Company Director | 1470180001 | ||||
MURFIN, Stephen | Amministratore | The Kymin Westhide HR1 3RG Hereford Herefordshire | British | Company Director | 8690590001 | |||||
MURPHY, Stephen Thomas | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | British | Chairman | 207509410001 | ||||
PRICE, Glyn John | Amministratore | Mill End Ash Ingen Mews Bridstow HR9 6QA Ross On Wye Herefordshire | United Kingdom | British | Company Director | 73470720001 | ||||
RATCLIFFE, Sarah Elizabeth | Amministratore | 59b Grange Road SM2 6SP Sutton Surrey | England | British | Finance Director | 76162020001 | ||||
SPENCER SMITH, Thomas Peter | Amministratore | The Old Rectory Llanvetherine NP7 8RG Abergavenny Gwent | British | Company Director | 1470160001 | |||||
STEINMEYER, Nils Olin | Amministratore | Syon Park London Road TW8 8JF Brentford Wyevale Garden Centres Middlesex England | United Kingdom | German | Financial Director | 126422100002 | ||||
STEVENSON, Barry John | Amministratore | Cherry Trees Cane End RG4 9HG Reading Berkshire | England | British | Company Director | 102595670001 | ||||
VAUGHAN, David John | Amministratore | Bryn Cain Penpergwm NP7 9AE Abergavenny Gwent | United Kingdom | British | Solicitor | 44521810001 |
L.R.RUSSELL LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 24 feb 2009 Consegnato il 04 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 1995 Consegnato il 26 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 1995 Consegnato il 25 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 13 gen 1995 Consegnato il 25 gen 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 08 dic 1992 Consegnato il 23 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and mortgage debenture | Creato il 08 dic 1992 Consegnato il 23 dic 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge | |
Brevi particolari Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 23 mar 1988 Consegnato il 05 apr 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 23 mar 1988 Consegnato il 05 apr 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 29 set 1982 Consegnato il 11 ott 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 12 mar 1980 Consegnato il 26 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 nov 1972 Consegnato il 14 dic 1972 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Inst of charge | Creato il 16 feb 1959 Consegnato il 04 mar 1959 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc. | |
Brevi particolari Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Series of debentures | Creato il 16 apr 1936 Consegnato il 16 apr 1936 | Soddisfatta integralmente | ||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0