SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSELECTA REFRESHMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00157122
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Finway Road Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SELECTA UK LIMITED20 gen 200320 gen 2003
    VENDEPAC LIMITED01 mag 199801 mag 1998
    TM GROUP LIMITED12 mag 198612 mag 1986
    MAYFAIR GROUP LIMITED31 dic 198131 dic 1981
    STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED16 lug 191916 lug 1919

    Quali sono gli ultimi bilanci di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England a 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT in data 15 nov 2022

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    12 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Anthony Michael Leon come amministratore in data 01 apr 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Nathaniel Ian Hearne come amministratore in data 01 apr 2021

    2 pagineAP01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    legacy

    68 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Nomina di Mr Anthony Michael Leon come amministratore in data 20 ott 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Marta Schwartz come amministratore in data 20 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2020 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 dic 2019

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    25 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Marta Schwartz come amministratore in data 01 set 2019

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr.
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish124527170003
    VRIJLANDT, Jan Marck
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch201873380001
    BAKER, Roger Owen
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    Segretario
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    British18801330003
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Segretario
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Segretario
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Segretario
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MERCER, Roderick
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    Segretario
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    British129465490001
    MILLER, Simon Jonathan
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    Segretario
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    British88269280001
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    Segretario
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    British147336500001
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Segretario
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritish183822370001
    BATE, David Martin
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    British130717000002
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    Amministratore
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    British32104690001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    Amministratore
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritish451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    British36622820001
    BURROWS, Helen
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    EnglandBritish171865220001
    COWING, Helen
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    Amministratore
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    NetherlandsBritish156849560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Amministratore
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    CULLENS, Alan
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    British6875310001
    HUGHES, Geraint
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    SwitzerlandBritish169470320001
    JONES, Dylan Glynn
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish153523810001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    British56997350002
    LANCASTER, James
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    Amministratore
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    EnglandBritish147052660001
    LEON, Anthony Michael
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Amministratore
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    EnglandBritish242255050001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish12314170002
    MAUGUY, Philippe Francis Robert
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    Amministratore
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish, French179402830001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Amministratore
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    MEE, Andy Edward
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    Amministratore
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    EnglandBritish177086470001
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    Amministratore
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    British6907290001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    British47770480002
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritish124498400001
    PORTER, Andrew Graham
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    Amministratore
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritish64331540001
    SCHWAB, Martin
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    Amministratore
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    SwitzerlandSwiss123132130001
    SCHWARTZ, Marta
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    Amministratore
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    United KingdomPolish262359470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    19 dic 2017
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00209116
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Kkr & Co.L.P
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    06 apr 2016
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    Forma giuridicaLimited Partnership
    Paese di registrazioneDelaware
    Autorità legaleDelaware
    Luogo di registrazioneRegistered In Delaware
    Numero di registrazioneState File No. 4378294
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2017
    Consegnato il 01 mar 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Factofrance
    Transazioni
    • 01 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2014
    Consegnato il 26 giu 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 26 giu 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Rent deposit deed
    Creato il 13 gen 2012
    Consegnato il 27 gen 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wgtc Nominees Limited
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    Transazioni
    • 27 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Fixed and floating secuirty document
    Creato il 28 set 2007
    Consegnato il 10 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank Pls as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transazioni
    • 10 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over deposit
    Creato il 08 dic 2000
    Consegnato il 19 dic 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents
    Brevi particolari
    1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 28 nov 1998
    Consegnato il 08 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over deposit account
    Creato il 10 lug 1998
    Consegnato il 27 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined)
    Brevi particolari
    The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC; As Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 27 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 10 lug 1998
    Consegnato il 27 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland P.L.C.; As Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 27 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 17 apr 1998
    Consegnato il 23 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995
    Brevi particolari
    Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental legal charge
    Creato il 06 dic 1996
    Consegnato il 09 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 02 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 02 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 lug 1995
    Consegnato il 31 lug 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0