SELECTA REFRESHMENTS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SELECTA REFRESHMENTS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00157122 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead Hertfordshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SELECTA UK LIMITED | 20 gen 2003 | 20 gen 2003 |
| VENDEPAC LIMITED | 01 mag 1998 | 01 mag 1998 |
| TM GROUP LIMITED | 12 mag 1986 | 12 mag 1986 |
| MAYFAIR GROUP LIMITED | 31 dic 1981 | 31 dic 1981 |
| STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED | 16 lug 1919 | 16 lug 1919 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England a 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PT in data 15 nov 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 12 pagine | AA | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 12 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Anthony Michael Leon come amministratore in data 01 apr 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Paul Nathaniel Ian Hearne come amministratore in data 01 apr 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019 | 16 pagine | AA | ||
legacy | 68 pagine | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||
Nomina di Mr Anthony Michael Leon come amministratore in data 20 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Marta Schwartz come amministratore in data 20 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 mar 2020 con aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2019 al 31 dic 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 25 pagine | AA | ||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Nomina di Marta Schwartz come amministratore in data 01 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEARNE, Paul Nathaniel Ian, Mr. | Amministratore | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | England | British | 124527170003 | |||||
| VRIJLANDT, Jan Marck | Amministratore | Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 7PT Hemel Hempstead 1 Finway Road Hertfordshire England | Netherlands | Dutch | 201873380001 | |||||
| BAKER, Roger Owen | Segretario | Ampfield House Blackheath GU4 8RD Guildford Surrey | British | 18801330003 | ||||||
| BARNES, Christopher Howard | Segretario | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||
| BUCKNALL, Christopher David | Segretario | 51 Brackendale Road GU15 2JS Camberley Surrey | British | 32104690001 | ||||||
| MASON, Timothy Charles | Segretario | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | British | 12314170002 | ||||||
| MERCER, Roderick | Segretario | Charvil Lane Sonning RG4 6TH Reading Slipe Berkshire | British | 129465490001 | ||||||
| MILLER, Simon Jonathan | Segretario | Crabtrees CB11 3BH Saffron Walden 12 Essex | British | 88269280001 | ||||||
| PAYNE, Michael John | Segretario | Unit 2 Cartel Business Centre Wade Road RG24 8FW Basingstoke Selecta Uk Ltd Hampshire | British | 147336500001 | ||||||
| SNEYD, Ian Nicholas | Segretario | Oakleigh Swan Lane Marlpit Hill TN8 6BA Edenbridge Kent | British | 31342250001 | ||||||
| ABRAHAMS, Daniel Henry | Amministratore | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | England | British | 183822370001 | |||||
| BATE, David Martin | Amministratore | 9 Harptree Close BS48 4YT Nailsea Morgan's View North Somerset United Kingdom | British | 130717000002 | ||||||
| BUCKNALL, Christopher David | Amministratore | 51 Brackendale Road GU15 2JS Camberley Surrey | British | 32104690001 | ||||||
| BULPITT, Nigel Peter | Amministratore | The Old School Upper Froyle GU34 4LB Alton Hampshire | England | British | 451080002 | |||||
| BURCHELL, Philip Raymond | Amministratore | 123 Tolmers Road EN6 4JW Cuffley Potters Bar Hertfordshire | British | 36622820001 | ||||||
| BURROWS, Helen | Amministratore | Cartel Business Centre Wade Road RG24 8FW Basingstoke Unit 2 Hampshire England | England | British | 171865220001 | |||||
| COWING, Helen | Amministratore | c/o Selecta Management Ag Hinterbergstrasse 6330 Cham 20 Switzerland | Netherlands | British | 156849560001 | |||||
| COX, Allister Russell | Amministratore | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | 31500810002 | |||||
| CULLENS, Alan | Amministratore | Candleford Colville Gardens GU18 5QQ Lightwater Surrey | British | 6875310001 | ||||||
| HUGHES, Geraint | Amministratore | Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8GG Basingstoke 1st Floor Spinnaker House Hampshire England | Switzerland | British | 169470320001 | |||||
| JONES, Dylan Glynn | Amministratore | Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8GG Basingstoke 1st Floor Spinnaker House Hampshire England | England | British | 153523810001 | |||||
| KEEN, David John | Amministratore | 33 Richmond Drive Mapperley NG3 5EL Nottingham Nottinghamshire | British | 56997350002 | ||||||
| LANCASTER, James | Amministratore | Upper Childown Accomodation Road KT16 0EJ Longcross Surrey | England | British | 147052660001 | |||||
| LEON, Anthony Michael | Amministratore | West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House, Odyssey Business Park England | England | British | 242255050001 | |||||
| MASON, Timothy Charles | Amministratore | 231 Station Road Knowle B93 0PU Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 12314170002 | |||||
| MAUGUY, Philippe Francis Robert | Amministratore | Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park Chineham RG24 8GG Basingstoke 1st Floor Spinnaker House Hampshire England | England | British, French | 179402830001 | |||||
| MCFARLANE, Ian Douglas | Amministratore | Shirenewton NP16 6RL Chepstow The Cayo Gwent | British | 130747750001 | ||||||
| MEE, Andy Edward | Amministratore | Loughglynn Bunstrux HP23 4HT Tring Herts | England | British | 177086470001 | |||||
| MITCHELL, Philip | Amministratore | 3 White House Drive Merrow GU1 2SU Guildford Surrey | British | 6907290001 | ||||||
| MORTIMER, David Grant | Amministratore | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||
| MORTIMER, David Grant | Amministratore | 86 Frenchay Road OX2 6TF Oxford Oxfordshire | British | 47770480002 | ||||||
| PAYNE, Michael John | Amministratore | Unit 2 Cartel Business Centre Wade Road RG24 8FW Basingstoke Hampshire | England | British | 124498400001 | |||||
| PORTER, Andrew Graham | Amministratore | 16 Alderwood Avenue Chandlers Ford SO53 4TH Eastleigh Hampshire | England | British | 64331540001 | |||||
| SCHWAB, Martin | Amministratore | Eebrunnestrasse 26 Hausen Bei Brugg 5212 Switzerland | Switzerland | Swiss | 123132130001 | |||||
| SCHWARTZ, Marta | Amministratore | West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House, Odyssey Business Park England | United Kingdom | Polish | 262359470001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SELECTA REFRESHMENTS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecta Uk Holding Limited | 19 dic 2017 | Odyssey Business Park West End Road HA4 6QD Ruislip Apollo House Middlesex England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Kkr & Co.L.P | 06 apr 2016 | West 57th Street Suite 4200 NY10019 New York 9 New York United States | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SELECTA REFRESHMENTS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 27 feb 2017 Consegnato il 01 mar 2017 | In corso | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 20 giu 2014 Consegnato il 26 giu 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 13 gen 2012 Consegnato il 27 gen 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating secuirty document | Creato il 28 set 2007 Consegnato il 10 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over deposit | Creato il 08 dic 2000 Consegnato il 19 dic 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents | |
Brevi particolari 1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 28 nov 1998 Consegnato il 08 dic 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over deposit account | Creato il 10 lug 1998 Consegnato il 27 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined) | |
Brevi particolari The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 10 lug 1998 Consegnato il 27 lug 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed | Creato il 17 apr 1998 Consegnato il 23 apr 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995 | |
Brevi particolari Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental legal charge | Creato il 06 dic 1996 Consegnato il 09 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995 | |
Brevi particolari L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 02 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share pledge | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 02 ago 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) | |
Brevi particolari Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 24 lug 1995 Consegnato il 31 lug 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
Brevi particolari L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0