LINER SHIPPING SERVICES LIMITED

LINER SHIPPING SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINER SHIPPING SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00162280
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUE STAR AGENCIES (UK) LIMITED 04 dic 199204 dic 1992
    BENAIR SHIPPING LIMITED27 mar 199027 mar 1990
    BRODIES (LONDON) LIMITED01 gen 192001 gen 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 ott 2010

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Maersk House Braham Street London E1 8EP in data 21 ott 2010

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ago 2010

    Stato del capitale al 12 ago 2010

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Cessazione della carica di James Burridge come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Martyn Clive Allen come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per John Kilby il 22 dic 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per John Kilby il 22 dic 2009

    1 pagineCH03

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    5 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LINER SHIPPING SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Segretario
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    British76247880001
    ALLEN, Martyn Clive
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    United KingdomBritish117739980001
    KILBY, John, Mr.
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    Amministratore
    Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    1
    EnglandBritish76247880001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Segretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Segretario
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    WALKERLEY, Dennis John
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    Segretario
    18 Paddock Close
    Nobles Green Eastwood
    SS9 5QR Leigh On Sea
    Essex
    British73793480001
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Segretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Amministratore
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Amministratore
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    CARR, Robert Andrew
    Swan House
    Preston
    CT3 1HA Canterbury
    Kent
    Amministratore
    Swan House
    Preston
    CT3 1HA Canterbury
    Kent
    British15101040001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Amministratore
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    HAZLITT, Basil Rodney
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    Amministratore
    Cousins Farm
    The Haven
    RH14 9BE Nr.Billingshurst
    West Sussex
    British1594150002
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Amministratore
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Amministratore
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Amministratore
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    VESTEY, Edmund Hoyle
    Little Thurlow Hall
    CB9 7LQ Haverhill
    Suffolk
    Amministratore
    Little Thurlow Hall
    CB9 7LQ Haverhill
    Suffolk
    British34614630001
    VESTEY, Samuel George Armstrong, Lord
    Stowell Park
    Northleach
    GL54 3LE Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Stowell Park
    Northleach
    GL54 3LE Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish67343880001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Amministratore
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001

    LINER SHIPPING SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Subordination agreement
    Creato il 20 feb 1997
    Consegnato il 07 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or owing by the company and/or any of the other companies named therein to the senior creditors (as defined therein) under or in connection with the senior finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    All payments in cash or in kind in respect of the subordinated debt (as defined therein), and any payment in respect of any security interest or under any guarantee thereunder and payments on account of the purchase or other acquisition thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for Itself and the Seniorcreditors)
    Transazioni
    • 07 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 25 mar 1986
    Consegnato il 07 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from blue star line LTD to the chargee under the terms of a facility letter d/d 10/3/1986 or by the company under a deed of covenant d/d 25/3/1986
    Brevi particolari
    M.V. australia star official no. 379682.
    Persone aventi diritto
    • Govermor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 25 mar 1986
    Consegnato il 07 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from blue star line LTD to the chargee under the terms of a facility letter d/d 10/3/1986 or by the company under the terms of the charge
    Brevi particolari
    64/64TH shares in the M.V. "australia star" registered as a british ship in london with official no. 379682 and all insurances compensation on the said vessel as set out in the said deed of covenants.
    Persone aventi diritto
    • Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 apr 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 feb 1989Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant
    Creato il 11 set 1978
    Consegnato il 28 set 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £4,666,975 under the terms of a loan agreement dated 27-2-78 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a statutory mortgage dated 11-9-78
    Brevi particolari
    1) 64 x 64TH shares in the british ship M.V. "australia star" NO379682 2) all insurance and entries in protection and indemnity and was risks associationaffected in respect of the ship 3) all charter hire and earnings of thr ship 4) all requisition compensation received in respect of the ship 5) all moneys from time to time outstanding to the credit of a blocked account pursuant to clause 10 of the said deed of covenants.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 1978Registrazione di un'ipoteca
    Tripartite deed of covenant
    Creato il 11 set 1978
    Consegnato il 28 set 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing £10,889,607 and all other monies due or to become due from the company under the terms of a loan agreement dated 16/2/78 as amended and the deed of covenant secured by a charge dated 11/9/78
    Brevi particolari
    The mortgaged premises being the slip, the containes her earnings and insurances and any requisition compensation as defined in the triparitite deed of covenant.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Financial agreement
    Creato il 16 feb 1978
    Consegnato il 28 feb 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,889,607 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement
    Brevi particolari
    All the company's beneficial interest all benefits, rights under a building contract dated 3-2-78 and all monies due in respect of insurances under the contract & all policies & contracts of insurance from time to time taken out in respect of containers (see doc M123 for details).
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 feb 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 01 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    LINER SHIPPING SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 ott 2010Inizio della liquidazione
    18 ago 2011Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    Praticante
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0