ARG REALISATIONS 2016 LIMITED

ARG REALISATIONS 2016 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARG REALISATIONS 2016 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00164291
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ship Canal House 8th Floor
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AUSTIN REED GROUP LIMITED07 feb 200707 feb 2007
    AUSTIN REED GROUP PLC20 feb 192020 feb 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    31 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    6 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Indirizzo della sede legale modificato da Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WU in data 11 nov 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    32 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Alixpartners the Zenith Building Spring Gardens Manchester M2 1AB England a Ship Canal House 8th Floor 98 King Street Manchester M2 4WB in data 16 mar 2020

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Dimissioni di un amministratore

    2 pagineAM15

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    34 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    4 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    37 pagineAM10

    Soddisfazione dell'onere 001642910013 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 001642910015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 001642910012 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di ARG REALISATIONS 2016 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ANDERS, Jill
    1 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    Segretario
    1 Back Lane
    Whixley
    YO26 8BG York
    British9506490005
    ANDERSON, David Mathieson
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    British551340001
    GIBSON, Geoffrey
    Laburnum Lodge Wetherby Road
    Rufforth
    YO23 3QB York
    North Yorkshire
    Segretario
    Laburnum Lodge Wetherby Road
    Rufforth
    YO23 3QB York
    North Yorkshire
    British48777390002
    GRIFFITHS, Susan Frances
    116 Corkland Road
    Chorlton
    M21 8XW Manchester
    Segretario
    116 Corkland Road
    Chorlton
    M21 8XW Manchester
    British89502620001
    LEE, Tony
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    8 Rossdale
    TN2 3PG Tunbridge Wells
    Kent
    British49293090003
    MITCHELL, Francesca
    Aysgarth
    DL8 3AD Leyburn
    Midville
    North Yorkshire
    Segretario
    Aysgarth
    DL8 3AD Leyburn
    Midville
    North Yorkshire
    British136433470001
    WAITE, Simon Nicholas
    10 Osprey Close
    Collingham
    LS22 5LZ Wetherby
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Osprey Close
    Collingham
    LS22 5LZ Wetherby
    West Yorkshire
    British44542620003
    WALLACE, Iain
    Station Road
    Thirsk
    YO7 1QH North Yorkshire
    Segretario
    Station Road
    Thirsk
    YO7 1QH North Yorkshire
    181597790001
    WATTS, Paula Mary
    57 Beck Road
    Everthorpe
    HU15 2JJ Brough
    North Humberside
    Segretario
    57 Beck Road
    Everthorpe
    HU15 2JJ Brough
    North Humberside
    British120535120001
    GUERANDE CONSULTING LIMITED
    Kirkby Avenue
    HG4 2DR Ripon
    3
    North Yorkshire
    England
    Segretario
    Kirkby Avenue
    HG4 2DR Ripon
    3
    North Yorkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione9562706
    198620710001
    ANDERSON, David Mathieson
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Old Vicarage
    Skipton-On-Swale
    YO7 4SB Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish551340001
    BALI, Alka
    42 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Amministratore
    42 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    EnglandBritish60919110003
    BARRY, Anthony Kevin
    39 Arlington Road
    NW1 7ES London
    Amministratore
    39 Arlington Road
    NW1 7ES London
    British47288370001
    CHARLTON, Alan Christopher
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    Croft Grange
    North Yorkshire
    Amministratore
    Marton Cum Grafton
    YO51 9QJ York
    Croft Grange
    North Yorkshire
    EnglandBritish113562910004
    CONSTANT, Richard Ashley Meyricke
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    Amministratore
    Park Lodge
    Aislaby
    YO1 1SW Whitby
    Yorkshire
    British19600420001
    EVANS, Colin Marten Llewellyn
    Wasing Wood Edge
    RG7 4RY Brimpton Common
    Berkshire
    Amministratore
    Wasing Wood Edge
    RG7 4RY Brimpton Common
    Berkshire
    British83975580001
    FITTON, Neil Hamilton Livesey
    27 Guion Road
    SW6 4UD London
    Amministratore
    27 Guion Road
    SW6 4UD London
    British551350001
    GALE, David John
    80 Church Street
    Market Deeping
    PE6 8AL Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    80 Church Street
    Market Deeping
    PE6 8AL Peterborough
    Cambridgeshire
    British12036820001
    GIBSON, Geoffrey
    Laburnum Lodge Wetherby Road
    Rufforth
    YO23 3QB York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Laburnum Lodge Wetherby Road
    Rufforth
    YO23 3QB York
    North Yorkshire
    EnglandBritish48777390002
    HAND, Elbert Osborne Iii
    1947 North Fremont
    Chigago Illinois 60614
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    1947 North Fremont
    Chigago Illinois 60614
    FOREIGN Usa
    American42217570001
    HEYLIN, Angela Christine
    46 St Augustines Road
    NW1 9RN London
    Amministratore
    46 St Augustines Road
    NW1 9RN London
    British21723640001
    HOLLINGWORTH, Nicholas William
    71 Earls Court Road
    W8 6EF London
    Amministratore
    71 Earls Court Road
    W8 6EF London
    United KingdomBritish248502860001
    HOULIHAN, Colin Anthony
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Ednaston Grange
    Hollington Lane Ednaston
    DE6 3AE Brailsford Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritish149560460001
    HOW, Timothy Francis
    47 Battlefield Road
    AL1 4DB St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    47 Battlefield Road
    AL1 4DB St Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish4242070001
    JACOBS, Alan Steven
    10 West Heath Avenue
    NW11 7QL London
    Amministratore
    10 West Heath Avenue
    NW11 7QL London
    EnglandBritish52186140001
    JENNINGS, Roger William
    31b Devonshire Place
    W1G 6JJ London
    Amministratore
    31b Devonshire Place
    W1G 6JJ London
    EnglandBritish13935230003
    LOWBRIDGE, William Albert
    Willowdean 2 Runrigg Hill
    Chesham Bois
    HP6 6DL Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Willowdean 2 Runrigg Hill
    Chesham Bois
    HP6 6DL Amersham
    Buckinghamshire
    UkBritish53295680001
    NAGGAR, Jonathan
    3 Acacia Road
    NW8 6AB London
    Amministratore
    3 Acacia Road
    NW8 6AB London
    United KingdomBritish44844270003
    PEARSON, David Compton Froome
    The Manor
    Berwick St John
    SP7 0EX Shaftesbury
    Dorset
    Amministratore
    The Manor
    Berwick St John
    SP7 0EX Shaftesbury
    Dorset
    British9929710001
    REED, Barry St George Austin
    Crakehall House
    Crakehall
    DL8 1HS Bedale
    North Yorkshire
    Amministratore
    Crakehall House
    Crakehall
    DL8 1HS Bedale
    North Yorkshire
    British578830001
    ROBINS, John Vernon Harry
    56 Duncan Terrace
    N1 8AG London
    Amministratore
    56 Duncan Terrace
    N1 8AG London
    United KingdomBritish25437690003
    SANDERS, John Roland
    Redwood House
    12 Temple Gardens
    WD3 1QJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Redwood House
    12 Temple Gardens
    WD3 1QJ Rickmansworth
    Hertfordshire
    British5381180001
    THOMSON, Christopher Norman
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    Amministratore
    High Sharow
    Sharow
    HG4 5BQ Ripon
    North Yorkshire
    EnglandBritish11591540001
    TIFFIN, Michael Adrian
    4 Lysander Mead
    SL6 8NS Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    4 Lysander Mead
    SL6 8NS Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish13444210002
    WILSON, Colin
    39 Woodhurst Road
    W3 6SS London
    Amministratore
    39 Woodhurst Road
    W3 6SS London
    British41000630001

    ARG REALISATIONS 2016 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P.
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 04 giu 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    In corso
    Breve descrizione
    92-100 regent street, london, W1B 5SR. Title number NGL767267.
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P. as Security Agent
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2015
    Consegnato il 19 mag 2015
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P. as Security Agent
    Transazioni
    • 19 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2015
    Consegnato il 19 mag 2015
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alteri Europe, L.P. as Security Agent
    Transazioni
    • 19 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 dic 2014
    Consegnato il 12 gen 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alan Charlton as Security Trustee
    Transazioni
    • 12 gen 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 ago 2014
    Consegnato il 23 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 ago 2014
    Consegnato il 13 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H 218 high street guildford surrey.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 13 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 giu 2014
    Consegnato il 17 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 17 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 mag 2014
    Consegnato il 30 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    92-100 regent street london t/no.NGL767267.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 30 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 mag 2014
    Consegnato il 30 mag 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Trademark A.R. and lion in diamond devic country united states of america applicant(s) austin reed group PLC application number 74/50445; ar signature crest country european community applicant(s) austin reed group limited application number 12400511; austin reed country germany applicant(s) austin reed group limited; cut country european community applicant(s) austin reed group limited application number 12400495.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alan Charlton
    Transazioni
    • 30 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 apr 2014
    Consegnato il 10 apr 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mar 2014
    Consegnato il 04 apr 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Third party charge of deposit
    Creato il 14 nov 2008
    Consegnato il 27 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from country casuals limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now or in the future credited to account designated 39425762 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 14 nov 2008
    Consegnato il 27 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now or in the future credited to account designated 39425762 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 04 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed equitable charge all other real property, by way of first fixed charge book debts, bank accounts, investments, uncalled capital and goodwill, intellectual property and plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Landsbanki Islands H.F (Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 29 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 06 feb 1998
    Consegnato il 25 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabiliites due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee on any account whatsoever under each finance document (as therein defined)
    Brevi particolari
    All group shares (as defined on the form 395) held by the company and all related rights accruing thereunder and the benfit of all authorisations in connection therewith and the right to recover and receive all compensation payable in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 ott 2000Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 02 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 gen 1966
    Consegnato il 05 gen 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £100,000 due from the company and/or austin reed properties LTD to the chargee
    Brevi particolari
    Land & building on south side of beresford avenue, wembley.
    Persone aventi diritto
    • Babcock Staff Pension Trust LTD.
    Transazioni
    • 05 gen 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 24 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further charge
    Creato il 20 feb 1924
    Consegnato il 26 feb 1924
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £8,250
    Brevi particolari
    Specific charge on the 130 & 131, fishergate preston, lancs.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Company LTD.
    Transazioni
    • 26 feb 1924Registrazione di un'ipoteca
    • 24 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 30 nov 1923
    Consegnato il 14 dic 1923
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing the sum of £3,000 and further advances not exceeding £11,250 in all.
    Brevi particolari
    Specific charge on the 130 & 131, fishergate preston, lancs.
    Persone aventi diritto
    • Phoenix Assurance Company LTD.
    Transazioni
    • 14 dic 1923Registrazione di un'ipoteca
    • 24 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARG REALISATIONS 2016 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 apr 2016Inizio dell'amministrazione
    04 mag 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Clare Kennedy
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Kevin James Coates
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Praticante
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0