WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED

WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00165376
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Innovation House Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2014
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2015

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mar 2014

    Stato del capitale al 27 mar 2014

    • Capitale: GBP 32,016
    SH01

    Nomina di Mr John King come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Seaton come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2012

    3 pagineAA

    Nomina di Mr Raymond Christopher Foran come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Richard Daniel come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nigel Barker come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Vaughan come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2011

    1 pagineAA

    Cessazione della carica di Raymond Foran come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew David Vaughan come amministratore

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 20 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Nigel Barker il 30 mar 2011

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2010

    1 pagineAA

    Nomina di Nigel Barker come segretario

    3 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DANIEL, Mark Richard
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Segretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    178839650001
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    IrelandIrishCompany Director149366250001
    KING, John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    IrelandIrishCompany Director184461620001
    BARKER, Nigel
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Segretario
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    British153012360001
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Segretario
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    BritishFinance Director125430560001
    LAWRENCE, David
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    Segretario
    45 Griffith Avenue
    Drumcondra
    Dublin 9
    Republic Of Ireland
    British136692630001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Segretario
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    BritishDirector204243460001
    MEREDITH, Mark
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    Segretario
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    British6502780001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    Segretario
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    BritishCompany Secretary123410850001
    CARILLION SECRETARIAT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    33743910002
    BEAN, Paul Francis
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    Amministratore
    10 Ormiston Farm Steadings
    Kirknewton
    EH27 0DQ Edinburgh
    West Lothian
    United KingdomBritishCompany Director125759470001
    BRANNIGAN, Terence Hugh
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    Amministratore
    West Cliffe Grove
    HG2 0PS Harrogate
    17
    North Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director125430930001
    DAY, Stephen John
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    Amministratore
    Becca House Becca Lane
    Aberford
    LS25 3BD Leeds
    EnglandBritishDirector59028300002
    ELLIOTT, Paul Graham
    14 Clay Hill Road
    NG34 7TF Sleaford
    Lincolnshire
    Amministratore
    14 Clay Hill Road
    NG34 7TF Sleaford
    Lincolnshire
    BritishCompany Director4321530003
    FORAN, Raymond Christopher
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    IrelandIrishDirector149366250001
    HARKIN, Niall
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Amministratore
    5 Campbell Chase
    BT4 3PE Belfast
    County Antrim
    N Ireland
    Northern IrelandBritishFinance Director125430560001
    MACNAMARA, James Justin
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    Amministratore
    Heyford Manor
    18 Church Lane, Lower Heyford
    OX25 5NZ Oxon
    EnglandBritishDirector204243460001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector96596920001
    MEREDITH, Barbara Anne
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector6561120001
    MEREDITH, Jayne Monica Ann
    10 Bankfield Drive
    BD18 4AD Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Bankfield Drive
    BD18 4AD Shipley
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector6561130001
    MEREDITH, Mark
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hadfield House Netherghyll Lane
    Cononley
    BD20 8PB Keighley
    West Yorkshire
    BritishDirector6502780001
    MEREDITH, Mary Elizabeth
    Uplands Odda Lane
    Guiseley
    LS20 8NZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Uplands Odda Lane
    Guiseley
    LS20 8NZ Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector6561140001
    MEREDITH, Richard Paul
    10 Bankfield Drive
    BD18 4AD Shipley
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Bankfield Drive
    BD18 4AD Shipley
    West Yorkshire
    BritishDirector6502790001
    SEATON, David John
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    EnglandBritishDirector66233040004
    VAUGHAN, Andrew David
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    Amministratore
    Bullerthorpe Lane
    Colton
    LS15 9JL Leeds
    Innovation House
    EnglandBritishDirector110679680001
    VOCKINS, Anthony Frederick
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    3 Shires Orchard
    Croxton Kerral
    NG32 1RD Grantham
    Lincolnshire
    BritishCompany Secretary123410850001
    WOODS, David
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    12 Rainsborough Rise
    Thorpe St Andrew
    NR7 0TR Norwich
    Norfolk
    BritishDirector11156100002
    CARILLION MANAGEMENT LIMITED
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    24 Birch Street
    WV1 4HY Wolverhampton
    West Midlands
    36778210004

    WEST RIDING CLEANING COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 14 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever under the financing documents or otherwise
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 3 vaughan street bradford & the land & buildings adjoining 3 vaughan street & fronting rebecca street.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 21 ago 1998
    Consegnato il 04 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 02 dic 1982
    Consegnato il 09 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Specific equitable charge over all f/h and l/h property and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charge over goodwill, book debts. Legal mortgage over f/h properties 3, vaughan street, westgate, bradford and 12 & 28, worthington street, bradford, and/or proceeds of sale thereof.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0