INCANITE FOUNDRIES LIMITED

INCANITE FOUNDRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINCANITE FOUNDRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00167997
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    • fusione di ghisa (24510) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10th Floor 103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WELLMAN INCANITE FOUNDRIES LIMITED04 giu 192004 giu 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2023

    15 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Baker Tilly Restructuring and Recovery Llp St Philips Point Temple Row Birmingham B2 5AF a 10th Floor 103 Colmore Row Birmingham B3 3AG in data 11 ott 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    8 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2022

    14 pagineLIQ03

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    6 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2021

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2020

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2019

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2018

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2017

    12 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 gen 2016

    14 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 gen 2015

    18 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 22 lug 2014

    18 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    3 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    41 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    13 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Suite 11J Peartree Business Centre Cobham Road Ferndown Dorset BH21 7PP* in data 31 gen 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4 Challeymead Business Park Melksham Wiltshire SN12 8BU* in data 13 nov 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 30 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 set 2013

    Stato del capitale al 12 set 2013

    • Capitale: GBP 17,600
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2012

    3 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di INCANITE FOUNDRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BERESFORD, Mark Christopher
    103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    10th Floor
    Amministratore
    103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    10th Floor
    EnglandBritish76800950001
    BERESFORD, Sharon Maria
    103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    10th Floor
    Amministratore
    103 Colmore Row
    B3 3AG Birmingham
    10th Floor
    United KingdomBritish162067170001
    EATON, Elliot
    Bradford Road
    SN12 8BU Melksham
    4 Challeymead Business Park
    Wiltshire
    England
    Amministratore
    Bradford Road
    SN12 8BU Melksham
    4 Challeymead Business Park
    Wiltshire
    England
    EnglandEnglish121713010001
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Segretario
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Segretario
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    British56115110001
    HOWELL, James Robert
    14 Santa Maria Way
    DY13 9RX Stourport On Severn
    Worcestershire
    Segretario
    14 Santa Maria Way
    DY13 9RX Stourport On Severn
    Worcestershire
    British19849000002
    HOWELL, James Robert
    Fernbank Quarry Bank Hartlebury
    DY11 7TE Kidderminster
    Worcs
    Segretario
    Fernbank Quarry Bank Hartlebury
    DY11 7TE Kidderminster
    Worcs
    British19849000001
    NEAL, Peter Richard
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    Segretario
    Coppers
    Cox Hill Boxford
    CO10 5HR Sudbury
    Suffolk
    British11209680002
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Segretario
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    BAXTER, Alan John
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Endon Hays Farm Dingle Lane
    Rushton Spencer
    SK11 0RX Macclesfield
    Cheshire
    British35520050002
    BURDETT, Roger Leonard
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    2 Pennyfields Boulevard
    NG10 3QJ Long Eaton
    Nottinghamshire
    British53792200005
    GILBERT, John
    Ham Farm
    Sandhill Lane
    TN3 9LP Eridge Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Ham Farm
    Sandhill Lane
    TN3 9LP Eridge Tunbridge Wells
    Kent
    British41281460001
    GUMIENNY, Marek Stefan
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    Amministratore
    13 Lambolle Road
    Belsize Park
    NW3 4HS London
    British66370740001
    HALE, Vivien Joan
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Keeley 12 Gables Meadow
    Holmer Green
    HP15 6RT High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish56115110001
    HANCOX, Roger Frederic
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Lower Leys 46 Mount Road
    Tettenhall Wood
    WV6 8HW Wolverhampton
    West Midlands
    British1597600001
    HOWELL, James Robert
    14 Santa Maria Way
    DY13 9RX Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    14 Santa Maria Way
    DY13 9RX Stourport On Severn
    Worcestershire
    EnglandBritish19849000002
    MCCORKELL, Henry Nigel Pakenham
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    The Hatch
    Gaunts Common
    BH21 4JB Wimborne
    Dorset
    EnglandEnglish13447260001
    MORGAN, Alan
    Prestbury Charles Street
    Wrockwardine Wood
    TF2 7LA Telford
    Salop
    Amministratore
    Prestbury Charles Street
    Wrockwardine Wood
    TF2 7LA Telford
    Salop
    British31148380001
    RICHARDS, Eric Thomas
    44 Sheepcote Lane
    B77 3JP Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    44 Sheepcote Lane
    B77 3JP Tamworth
    Staffordshire
    EnglandBritish72781120001
    SMITH, Jonathan Francis
    Mid Thatch Boon Street
    Eckington
    WR10 3BL Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Mid Thatch Boon Street
    Eckington
    WR10 3BL Pershore
    Worcestershire
    British1755460001

    INCANITE FOUNDRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 gen 2012
    Consegnato il 24 gen 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 09 nov 2000
    Consegnato il 16 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 10 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any of the other companies named therein (the group companies) to the chargee as agent and trustee for the beneficiaries (as defined) and/or any of the beneficiaries under or in connection with the facilities agreement and/or any other senior finance document
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 giu 1996
    Consegnato il 12 giu 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever .
    Brevi particolari
    Land at cornwall road smethwick warley west midlands. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 02 gen 1996
    Consegnato il 05 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 ago 1994
    Consegnato il 25 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite deed of debenture
    Creato il 18 apr 1991
    Consegnato il 03 mag 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Please see doc M395 ref M646 (for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite cross-guarantee and set-off.
    Creato il 26 apr 1990
    Consegnato il 11 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 04 apr 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 feb 1985
    Consegnato il 08 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Please doc M137. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1985Registrazione di un'ipoteca

    INCANITE FOUNDRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 gen 2014Inizio dell'amministrazione
    26 gen 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Guy Edward Brooke Mander
    Baker Tilly
    St Philips Point
    B2 5AF Temple Row
    Birmingham
    Praticante
    Baker Tilly
    St Philips Point
    B2 5AF Temple Row
    Birmingham
    Dilip K Dattani
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park, Enderby
    LE19 3RY Leicester
    Praticante
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park, Enderby
    LE19 3RY Leicester
    2
    DataTipo
    01 set 2023Data prevista di scioglimento
    26 gen 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Diana Frangou
    St Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praticante
    St Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Liquidatore proposto
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Dilip K Dattani
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Liquidatore proposto
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Dilip K Dattani
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire
    Praticante
    Rivermead House 7 Lewis Court
    Grove Park Enderby
    LE19 1SD Leicester
    Leicestershire
    Guy Edward Brooke Mander
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham
    Praticante
    St. Philips Point Temple Row
    B2 5AF Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0