HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED

HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00168182
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HGD STEEL STOCKHOLDERS LIMITED11 giu 192011 giu 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 giu 2011

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 mag 2011

    Stato del capitale al 26 mag 2011

    • Capitale: GBP 14,890
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Karen Devonport il 10 dic 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mrs Karen Devonport il 10 dic 2010

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr George Clinton Jones il 10 dic 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    5 pagineAA

    Nomina di Mrs Karen Devonport come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Martin Joyce come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    2 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 16 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Segretario
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    British108483890002
    DEVONPORT, Karen
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish108483890002
    JONES, George Clinton
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    Amministratore
    Valley Farm Road
    Stourton
    LS10 1SD Leeds
    United KingdomBritish70121220002
    HEYS, Peter
    30 Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DF Grimsby
    South Humberside
    Segretario
    30 Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DF Grimsby
    South Humberside
    British50210280001
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    British7474650008
    BARUGH, Michael John
    North Farm
    North Street
    HU11 4QN Aldbrough
    East Yorkshire
    Amministratore
    North Farm
    North Street
    HU11 4QN Aldbrough
    East Yorkshire
    United KingdomBritish157016780001
    HEYS, Peter
    30 Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DF Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    30 Edinburgh Drive
    Holton Le Clay
    DN36 5DF Grimsby
    South Humberside
    British50210280001
    HURST, Philip John
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    The Court House
    12 Draycott Road Upper Tean
    ST10 4JF Stoke On Trent
    Staffordshire
    British9447640003
    JOYCE, Martin Joseph
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Meynell Lane
    Meynell Road Colton
    LS15 9BZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish7474650008
    MACDONALD, Alexander Scott
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 St Helens Grove
    Sandal
    WF2 6RR Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish3480700001
    MIDDIS, Kevin John
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    Amministratore
    Silverdale
    Old Forge Gardens
    DY11 7TA Hartlebury
    Worcestershire
    EnglandBritish81620510001
    STREETS, Janice Christine
    The Pines Rotherham Road
    Tickhill
    DN11 9NJ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    The Pines Rotherham Road
    Tickhill
    DN11 9NJ Doncaster
    South Yorkshire
    British35035980001
    SYKES, Kenneth Olaf
    92 Caistor Road
    Laceby
    DN37 7JG Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    92 Caistor Road
    Laceby
    DN37 7JG Grimsby
    South Humberside
    British35035970001
    TAINTON, John Samuel
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    Amministratore
    Bramblings
    Frenchlands Lane
    WR2 6QU Lower Broadheath
    Worcestershire
    British9305720001
    TAYLOR, Paul
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Sutherland Drive
    Westlands
    ST5 3EN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British50931220001
    TIPLADY, John Eason
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    7 Osborne Drive
    Todwick
    S26 1HW Sheffield
    South Yorkshire
    British3480680001

    HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 20 dic 1988
    Consegnato il 04 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at south humber industrial estate grimsby title no hs 107011 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 dic 1985
    Consegnato il 24 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a factory number bt 557/1 on the south humberside industrial estate grimsby in the county of humberside and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 dic 1985
    Consegnato il 24 dic 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a 1752 square yards of land at the junction of king edward street with market street grimsby and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 dic 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 14 gen 1985
    Consegnato il 18 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of market street, grimsby, south humberside and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 giu 1984
    Consegnato il 12 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property plot 7, queen street estate grimsby humberside and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1984
    Consegnato il 12 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property land & buildings lying to the east of king edward st grimsby humberside. Title no. Hs 12780 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1984
    Consegnato il 12 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property - unit no. V riverside industrial estate marsh lane, boston, lincoln. And/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 giu 1984
    Consegnato il 12 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property - 351 & 353 hotham st, kingston upon hull. Humberside title no hs 47097 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 25 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 set 1983
    Consegnato il 05 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the companies f/h or l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 09 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    HUMBER STEEL STOCKHOLDERS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 giu 2011Inizio della liquidazione
    06 mar 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0