MACARTHY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMACARTHY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00168702
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MACARTHY LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MACARTHY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MACARTHY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MACARTHYS PHARMACEUTICALS P.L.C.30 giu 192030 giu 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di MACARTHY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MACARTHY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 ott 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Stato del capitale al 15 giu 2012

    • Capitale: GBP 1,000
    4 pagineSH19

    Consolidamento delle azioni al 12 giu 2012

    5 pagineSH02

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 15 giu 2012

    • Capitale: GBP 5,780,899.20
    4 pagineSH06

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share prem reduced/ b pref shares cancelled/ consolidated 12/06/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Martin Sillitto come amministratore in data 26 gen 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Engelen come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2011

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Jason Grover come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 08 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Sillitto il 04 apr 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2010

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Richard De Souza come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Oades come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Thomas Engelen come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Philip Edward Parry come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Oades come amministratore

    2 pagineTM01
    Note
    DataNota
    07 ott 2010Part Rectified THE DATE OF TERMINATION ON THE TM01 WAS REMOVED FROM THE PUBLIC REGISTER ON 07/10/10 AS IT WAS FACTUALLY INACCURATE OR DERIVED FROM SOMETHING FACTUALLY INACCURATE

    Chi sono gli amministratori di MACARTHY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DE SOUZA, Richard Anthony
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    EnglandBritish154817550001
    GROVER, Jason
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    EnglandBritish71645160002
    PARRY, Philip Edward
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomBritish153299600001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Segretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    KNIGHT, Anthony
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    Segretario
    122 Ongar Road
    Writtle
    CM1 3NX Chelmsford
    Essex
    British126965310001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    OAKLEY, Stephen Edward
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    British438640001
    PINCHIN, Nicholas John
    19 Sutton Place
    E9 6EH London
    Segretario
    19 Sutton Place
    E9 6EH London
    British54411540001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Segretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    WEST, David William
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    Segretario
    10 Brindles
    RM11 2RU Hornchurch
    Essex
    English18533210002
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    60471940015
    AXTEN, Godfrey Clive
    21 Oakhill Road
    TN13 1NS Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    21 Oakhill Road
    TN13 1NS Sevenoaks
    Kent
    UkBritish112949110001
    BRYANT, Derek
    14 Lordswood View
    Leaden Roding
    CM6 1SE Dunmow
    Essex
    Amministratore
    14 Lordswood View
    Leaden Roding
    CM6 1SE Dunmow
    Essex
    British54411450001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Amministratore
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    EARNSHAW, Jeremy Waring
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Thorntons Dale
    Newlaithes Road Horsforth
    LS18 4UW Leeds
    West Yorkshire
    British47388900001
    ENGELEN, Thomas
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomNetherlands136783900002
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    KAY, Andrew George
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    Amministratore
    9 Back Lane
    Whixley Gate
    YO26 8BG Whixley
    Yorkshire
    British41347920003
    KERSHAW, Graham Anthony
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    Amministratore
    24 Oakfield Road
    HD2 2XF Huddersfield
    Yorkshire
    British8991780009
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    LOFTHOUSE, Stephen David
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Windsor House
    Cornwall Road
    HG1 2PW Harrogate
    North Yorkshire
    British111617880001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    OADES, Andrew Giovanni
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Cardinal Health
    Essex
    United KingdomBritish108839700002
    OAKLEY, Stephen Edward
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    31 Barlings Road
    AL5 2AW Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish438640001
    PARKER, John Francis
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Beck House 10 Fulwith Mill Lane
    HG2 8HJ Harrogate
    North Yorkshire
    British47002780001
    PARSONS, Ian Dominic
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    Amministratore
    72 Spindlewood
    Elloughton
    HU15 1LL Brough
    North Humberside
    EnglandBritish63325310001
    READ, John Leslie
    2 Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    Amministratore
    2 Milbrook
    KT10 9EJ Esher
    Surrey
    EnglandBritish58899370001
    SAUNDERS, Martin John
    17 Bromley Road
    BN25 3ES Seaford
    East Sussex
    Amministratore
    17 Bromley Road
    BN25 3ES Seaford
    East Sussex
    EnglandBritish34627480001
    SILLITTO, Martin
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    Amministratore
    Bampton Road
    Harold Hill
    RM3 8UG Romford
    Essex
    United KingdomBritish126965260002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Amministratore
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TAYLOR, Malcolm Archibald, Doctor
    The Acorns
    Drury Lane, Pannal
    HG3 1ET Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Acorns
    Drury Lane, Pannal
    HG3 1ET Harrogate
    North Yorkshire
    British7445580002

    MACARTHY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 12 mag 2010
    Consegnato il 21 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 ott 2002
    Consegnato il 24 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties)
    Transazioni
    • 24 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 ott 2000
    Consegnato il 11 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All and any of all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the other secured parties (as defined) on any account whatsoever under or in connection with any of the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 26 ott 2000
    Consegnato il 11 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee including those under the guarantee and indemnity (as defined) and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lombard Natwest Discounting Limited
    Transazioni
    • 11 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 08 ago 1997
    Consegnato il 20 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "finance documents" (as defined in the debenture)
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee )
    Transazioni
    • 20 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of off-set
    Creato il 08 ago 1997
    Consegnato il 15 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the principal debtors (as defined) or any of them to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents (as defined in the facilities agreement of even date)
    Brevi particolari
    All monies at the date of the charge or at any tine thereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books are charged by way of fixed and specific charge.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of set off 10.1.83
    Creato il 10 gen 1983
    Consegnato il 24 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any present or future account of the company.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Letter of set-off
    Creato il 13 mag 1980
    Consegnato il 28 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brevi particolari
    Any sums standing to the credit of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mag 1980Registrazione di un'ipoteca
    Memo of deposit
    Creato il 06 mar 1944
    Consegnato il 10 mar 1944
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £5000
    Brevi particolari
    No. 18 duke st, chelmesford essex.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 1944Registrazione di un'ipoteca
    • 17 set 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MACARTHY LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 lug 2013Data di scioglimento
    02 ott 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0