CAMP,HOPSON & CO.LIMITED

CAMP,HOPSON & CO.LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAMP,HOPSON & CO.LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00169112
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAMP,HOPSON & CO.LIMITED?

    • Altro commercio al dettaglio in negozi non specializzati (47190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova CAMP,HOPSON & CO.LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAMP,HOPSON & CO.LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CAMP,HOPSON & CO.LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2018

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 22 lug 2017

    24 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O 12-20 Oxford Street Newbury Berkshire RG14 1JB England a C/O Begbies Traynor (Central) Llp 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 03 ago 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 23 lug 2016

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O 12-20 Oxford Street Oxford Street Newbury Berkshire RG14 1JB England a C/O 12-20 Oxford Street Newbury Berkshire RG14 1JB in data 27 apr 2016

    1 pagineAD01

    Iscrizione dell'ipoteca 001691120011, creata il 20 apr 2016

    5 pagineMR01

    Indirizzo della sede legale modificato da Units 1 and 2 Hambridge Lane Newbury Berkshire RG14 5TU a C/O 12-20 Oxford Street Oxford Street Newbury Berkshire RG14 1JB in data 26 apr 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 gen 2016

    Stato del capitale al 20 gen 2016

    • Capitale: GBP 781,192
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 gen 2015

    40 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew John Michael Curry come amministratore in data 01 giu 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Andrew John Michael Curry come amministratore in data 01 giu 2015

    2 pagineAP01

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Richard Mark Tavener come amministratore in data 31 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 feb 2015

    Stato del capitale al 10 feb 2015

    • Capitale: GBP 771,192
    SH01

    Cessazione della carica di Andrew Paul Riddle come amministratore in data 30 ott 2014

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 7-11 Northbrook Street Newbury Berkshire RG14 1DN a Units 1 and 2 Hambridge Lane Newbury Berkshire RG14 5TU in data 14 nov 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio consolidato redatto al 31 gen 2014

    41 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CAMP,HOPSON & CO.LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOPSON, Jonathan Joseph
    Hollington
    Woolton Hill
    RG20 9XT Newbury
    Hawk House
    Berkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Hollington
    Woolton Hill
    RG20 9XT Newbury
    Hawk House
    Berkshire
    United Kingdom
    British22727720003
    CURRY, Andrew John Michael
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    Amministratore
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    EnglandBritishManagement Consultant12144390001
    HOPSON, Christopher Ian
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    Amministratore
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    United KingdomBritishCompany Director77443720001
    HOPSON, Jonathan Joseph
    Hollington
    Woolton Hill
    RG20 9XT Newbury
    Hawk House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hollington
    Woolton Hill
    RG20 9XT Newbury
    Hawk House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector22727720003
    PHILIP, Sally Anne
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    Amministratore
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    ScotlandBritishLegal Editor80254100002
    ROBINSON, Raymond Barry
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    Amministratore
    c/o Begbies Traynor (Central) Llp
    Bank Street
    E14 5NR London
    31st Floor 40
    EnglandBritishArchitect159051250001
    ALLEN, Brian William
    1 Severn Close
    RG18 3DW Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    1 Severn Close
    RG18 3DW Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishRemovals Director69257370001
    CLARKE, Joy
    Thyme Cottage Compton Street
    Compton
    SO21 2AT Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Thyme Cottage Compton Street
    Compton
    SO21 2AT Winchester
    Hampshire
    BritishRetired23091970001
    CURRY, Andrew John Michael
    Hambridge Lane
    RG14 5TU Newbury
    Units 1 And 2
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Hambridge Lane
    RG14 5TU Newbury
    Units 1 And 2
    Berkshire
    England
    EnglandBritishManagement Consultant12144390001
    CURRY, Andrew John Michael
    7 Richford Street
    W6 7HJ London
    Amministratore
    7 Richford Street
    W6 7HJ London
    EnglandBritishTelevision Producer12144390001
    DAWES, Alfred Joseph, Dr
    Durtshot Yafford
    PO30 4PW Brighstone
    Isle Of Wight
    Amministratore
    Durtshot Yafford
    PO30 4PW Brighstone
    Isle Of Wight
    BritishDirector4887330001
    EDGINGTON, Margaret Ellen
    11 Elm Farm Close
    OX12 9FD Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    11 Elm Farm Close
    OX12 9FD Wantage
    Oxfordshire
    BritishMerchandise Director69257440002
    EMPSON, David John
    Evingar
    North End
    RG20 0AX Newbury
    Amministratore
    Evingar
    North End
    RG20 0AX Newbury
    EnglandBritishDirector Adams77897830004
    GREEN, Robert Edward
    7 Stocks Lane
    Steventon
    OX13 6SG Abingdon
    Oxfordshire
    Amministratore
    7 Stocks Lane
    Steventon
    OX13 6SG Abingdon
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director89150190001
    GUTHRIE, Desmond Erskine
    Slade Hill Cottage
    Woolton Hill
    RG20 9TN Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Slade Hill Cottage
    Woolton Hill
    RG20 9TN Newbury
    Berkshire
    British3168300001
    HAMILTON, James Dundas
    45 Melbury Court
    Kensington High Street
    W8 6NH London
    Amministratore
    45 Melbury Court
    Kensington High Street
    W8 6NH London
    BritishConsultant79721990001
    HAMILTON, James Dundas
    45 Melbury Court
    Kensington High Street
    W8 6NH London
    Amministratore
    45 Melbury Court
    Kensington High Street
    W8 6NH London
    BritishMember Of International Stock Exchange79721990001
    HENDERSON, Robert David Charles
    North Ecchinswell Farm
    RG20 4UJ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    North Ecchinswell Farm
    RG20 4UJ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishBanker43565270004
    HOPSON, David Joseph
    Field Acre
    Hoe Benham
    RG20 8PD Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Field Acre
    Hoe Benham
    RG20 8PD Newbury
    Berkshire
    BritishDirector47704820001
    MAYS-SMITH, Eliza Maria, Lady
    Chaddleworth House
    Chaddleworth
    RG20 7EB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Chaddleworth House
    Chaddleworth
    RG20 7EB Newbury
    Berkshire
    BritishFarmer23217610003
    MILNE, Linda Christeen
    Silver Birches Chapel Lane
    Curridge
    RG16 9DX Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Silver Birches Chapel Lane
    Curridge
    RG16 9DX Newbury
    Berkshire
    British23091940001
    PHILIP, Sally Anne
    5a Albany Street
    EH1 3PY Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    5a Albany Street
    EH1 3PY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishEditorial Manager80254100002
    RIDDLE, Andrew Paul
    137 Winchester Road
    RG28 7RB Whitchurch
    Hampshire
    Amministratore
    137 Winchester Road
    RG28 7RB Whitchurch
    Hampshire
    United KingdomBritishRetailer106576770001
    ROBINSON, Denis Norman, Captain
    Merryways
    Owslebury
    SO21 1LP Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Merryways
    Owslebury
    SO21 1LP Winchester
    Hampshire
    BritishRetired23091930001
    SIMPSON, Richard Gordon
    Choice Hill Farm
    Overnorton
    OX7 5PZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Choice Hill Farm
    Overnorton
    OX7 5PZ Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishCandlemaker13379600003
    TAVENER, Richard Mark
    The Willows
    17 Donnington Park
    RG14 2DZ Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Willows
    17 Donnington Park
    RG14 2DZ Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishAccountant126619000001
    TAVENER, Richard Mark
    Magnolia House Pangbourne Hill
    Pangbourne
    RG8 7AS Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Magnolia House Pangbourne Hill
    Pangbourne
    RG8 7AS Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant54647100001

    CAMP,HOPSON & CO.LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 apr 2016
    Consegnato il 27 apr 2016
    In corso
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Legal charge
    Creato il 24 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 6-12 northbrook street newbury berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 12 ott 2004
    Consegnato il 13 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a land on the south west side of park way newbury berkshire (the tricorn building) t/n BK343193.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 set 2004
    Consegnato il 25 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 92 west street newbury berkshire t/n BK105890.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 set 2004
    Consegnato il 25 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a units 1 and 2 hambridge lane newbury berkshire t/no 173652.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 24 set 2004
    Consegnato il 25 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 90 west street newbury berkshire t/no BK5749.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 09 ago 2004
    Consegnato il 24 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a units 1 & 2 hambridge lane newbury berkshire t/no.bk 173652 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.all present and future book and other debts by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land off park way newbury berks forming the site of a proposed building k/a the tricorn building being part of t/no.bk 203202 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.all present and future book and other debtsby way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 30 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 6/7 northbrook street newbury berkshire being part of the t/no.bk 203202 together with all buildings & fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.all present and future book and other debts by way of assignment the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 09 feb 1990
    Consegnato il 13 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £120,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the mortgage conditions
    Brevi particolari
    12/12A bath road thatchann, berkshire, RG13 4SX.
    Persone aventi diritto
    • Newbury Building Society.
    Transazioni
    • 13 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 set 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CAMP,HOPSON & CO.LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 lug 2016Inizio della liquidazione
    09 ott 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kirstie Jane Provan
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31 St Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0