CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED

CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHAPMAN INDUSTRIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00170366
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3 The Courtyard Harris Business Park
    Hanbury Road Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHAPMAN INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY09 feb 198209 feb 1982
    CHAPMAN & CO (BALHAM) LIMITED22 set 192022 set 1920

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    3 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2017

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 set 2016

    7 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 set 2015

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Trelleborg, International Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8UQ a 3 the Courtyard Harris Business Park Hanbury Road Stoke Prior Bromsgrove B60 4DJ in data 16 ott 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 lug 2015

    • Capitale: GBP 15,548,988
    3 pagineSH01

    Cessazione della carica di Ivar Lars Leijonberg come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Niklas Anders Johansson come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Soren Bengt Evert Andersson come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mar 2015

    Stato del capitale al 18 mar 2015

    • Capitale: GBP 15,205,042
    SH01

    Nomina di Mr Niklas Anders Johansson come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Ivar Lars Leijonberg come amministratore in data 26 set 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Charlotta Ingrid Grahs come amministratore in data 01 ott 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sven Ulf Runesson Graden come amministratore in data 30 set 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2014

    Stato del capitale al 15 apr 2014

    • Capitale: GBP 15,205,042
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    8 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELCOCK, Ian
    Harris Business Park
    Hanbury Road Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    3 The Courtyard
    Segretario
    Harris Business Park
    Hanbury Road Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    3 The Courtyard
    British72862100001
    GRAHS, Charlotta Ingrid
    Harris Business Park
    Hanbury Road Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    3 The Courtyard
    Amministratore
    Harris Business Park
    Hanbury Road Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    3 The Courtyard
    SwedenSwedish191425470001
    JOERWALL, Claes
    Mollemadsvagen 28c
    Se 239 42 Falsterbo
    Sweden
    Amministratore
    Mollemadsvagen 28c
    Se 239 42 Falsterbo
    Sweden
    SwedenSwedish76893510001
    BAILEY, Alan Wilce
    1 Brian Avenue
    Sanderstead
    CR2 9NG South Croydon
    Surrey
    Segretario
    1 Brian Avenue
    Sanderstead
    CR2 9NG South Croydon
    Surrey
    British27233850001
    LAUREN, Anders Joakim
    Woodlands Cottage
    Roman Road
    B74 3AR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Woodlands Cottage
    Roman Road
    B74 3AR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Swedish66094560001
    TINGLE, Martin David
    87 Golden Cross Lane
    Catshill
    B61 0LE Bromsgrove
    Worcestershire
    Segretario
    87 Golden Cross Lane
    Catshill
    B61 0LE Bromsgrove
    Worcestershire
    British79624340001
    VARLEY, Tony
    1 Kensington Drive
    Horwich
    BL6 6AE Bolton
    Lancashire
    Segretario
    1 Kensington Drive
    Horwich
    BL6 6AE Bolton
    Lancashire
    British38777800001
    WAYLAND, William Sidney Peter
    57 Button Lane
    Bearsted
    ME15 8DW Maidstone
    Kent
    Segretario
    57 Button Lane
    Bearsted
    ME15 8DW Maidstone
    Kent
    British70325470002
    ANDERSSON, Soren Bengt Evert
    Birger Jarlsgatan 26
    216 12 Limhann
    Sweden
    Amministratore
    Birger Jarlsgatan 26
    216 12 Limhann
    Sweden
    SwedenSwedish77181430002
    ARP, Frederick
    Nordan V 16
    21618 Malmoe
    Sweden
    Sweden
    Amministratore
    Nordan V 16
    21618 Malmoe
    Sweden
    Sweden
    Swedish50787110001
    BJAREHOLT, Sture
    Villagaton 8
    FOREIGN 56172 Huskvarna
    Sweden
    Amministratore
    Villagaton 8
    FOREIGN 56172 Huskvarna
    Sweden
    Swedish29342130001
    CARTER, Sylvia May
    71 Valleyfield Road
    Streatham
    SW16 2HX London
    Amministratore
    71 Valleyfield Road
    Streatham
    SW16 2HX London
    British869090001
    FORSEN, Bjorn Bo
    Sommarvindsvagen 7
    Trelleborg
    Sweden
    Amministratore
    Sommarvindsvagen 7
    Trelleborg
    Sweden
    Swedish72345220001
    GRADEN, Sven Ulf Runesson
    Loddesnasvagen 25
    SE-23741 Bjarred
    -
    Sweden
    Sweden
    Amministratore
    Loddesnasvagen 25
    SE-23741 Bjarred
    -
    Sweden
    Sweden
    SwedenSwedish121744450001
    JOHANSSON, Niklas Anders
    Trelleborg, International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Amministratore
    Trelleborg, International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    SwedenSwedish260412010001
    KARLEN, Stig Olof Oscar
    Snabbvingevagen 5
    FOREIGN 561 47 Huskvarna
    Sweden
    Amministratore
    Snabbvingevagen 5
    FOREIGN 561 47 Huskvarna
    Sweden
    Swedish12703580001
    LEIJONBERG, Ivar Lars
    Trelleborg, International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    Amministratore
    Trelleborg, International Drive
    Tewkesbury Business Park
    GL20 8UQ Tewkesbury
    SwedenSwedish191939320001
    LINDBACK, Rolf Eje
    Trollegaten 4
    S-38238 Nybro
    FOREIGN Sweden
    Amministratore
    Trollegaten 4
    S-38238 Nybro
    FOREIGN Sweden
    Swedish35364390001
    LINDSTEDT, Sten Carl Axel
    Vasagatan 42
    Gothenburg
    FOREIGN 41137
    Sweden
    Amministratore
    Vasagatan 42
    Gothenburg
    FOREIGN 41137
    Sweden
    Swedish66869130001
    LINDSTEDT, Sten Carl Axel
    Vasagatan 42
    Gothenburg
    FOREIGN 41137
    Sweden
    Amministratore
    Vasagatan 42
    Gothenburg
    FOREIGN 41137
    Sweden
    Swedish66869130001
    LJUNG, Sven
    Oskarsgatan 4
    38200 Nybro
    FOREIGN Sweden
    Amministratore
    Oskarsgatan 4
    38200 Nybro
    FOREIGN Sweden
    Swedish37730220001
    RODERT, Per Iwar
    Krubbarp
    FOREIGN S-561 91 Huskvarna
    Sweden
    Amministratore
    Krubbarp
    FOREIGN S-561 91 Huskvarna
    Sweden
    Swedish56983310001
    THAWLEY, Clive
    Dunmore Ballplay Road
    DG10 9JU Moffat
    Dumfriesshire
    Amministratore
    Dunmore Ballplay Road
    DG10 9JU Moffat
    Dumfriesshire
    British61761690001
    TOWNEND, John Andrew
    Broadmead 19 Meins Road
    BB2 6QQ Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    Broadmead 19 Meins Road
    BB2 6QQ Blackburn
    Lancashire
    British2084050001

    CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security
    Creato il 06 dic 1991
    Consegnato il 18 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of personal bond dated 25/11/91
    Brevi particolari
    Ground on the north or north east side of mcdonald road edinburgh for full details see form 395.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 18 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 6, clayton park industrial estate, clayton be moors, lancashire title no la 612375.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land known as 3 & 4 longfield together with a right of way over the roading known as longfield leading into london road, london borough of bromley t/n k 217657.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that freehold property situated near danwen in the county of lancashire being part of the property comprised in a conveyance dated 2.5.90.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold properties situated near danwen in the county of lancashire being part of the property comprised in a conveyance dated 2.5.1990.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north side of longfield, london borough of bromley t/n sgl 184501.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A registered charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 19 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All freehold properties situated near darwen in the county of lancashire being part of the property comprised to a conveyance dated 2.5.90.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All freehold property situated near darwen in the county of lancashire being part of property comprised in a conveyance dated 2.5.90.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that freehold property situated at darwen in the county of lancashire being part of the property comprised in a conveyance dated 2.5.90.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 31 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that freehold property situated at darwen in the county of lancashire being part of the property comprised in a conveyance dated 2.5.90.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 apr 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 19 lug 1991
    Consegnato il 26 lug 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See doc M682C for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1987
    Consegnato il 07 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Central warehouse caswell rd blackmills industrial estates northampton.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    Second deed of substitution
    Creato il 23 nov 1987
    Consegnato il 04 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Securing sterling pounds 800, 000 82% first mortgage debenture stock 1993/98 of the company issued fixtures to a first deed dated 14 jan 69 as amanded, and anyadditional stock created and issued pursuant to the first deed together with any other moneys intended to be secured by the trust deed and deeds supplemental those to royal exchange assurance
    Brevi particolari
    F/Hold land k/as chapman house, farwig lane and 52, landa rd bromley kent with the car park relating thereto all of which are registered t/n sgl 100810, K217657, sgl 177497, sgl 184501 and sgl 90983.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 04 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Series of debentures
    Creato il 14 gen 1969
    Consegnato il 20 gen 1969
    Soddisfatta integralmente
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 20 gen 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 04 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CHAPMAN INDUSTRIES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 feb 2019Data di scioglimento
    28 set 2015Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Adam Jordan
    3 The Courtyard Harris Business Park Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Praticante
    3 The Courtyard Harris Business Park Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Worcestershire
    Nickolas Garth Rimes
    3 The Courtyard Harris Business Park Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove
    Praticante
    3 The Courtyard Harris Business Park Hanbury Road
    Stoke Prior
    B60 4DJ Bromsgrove

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0