RHM FOODSERVICE LIMITED
Panoramica
Nome della società | RHM FOODSERVICE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00177510 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RHM FOODSERVICE LIMITED?
- Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere
Dove si trova RHM FOODSERVICE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St Albans Hertfordshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RHM FOODSERVICE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MCDOUGALLS CATERING FOODS LIMITED | 27 ott 1921 | 27 ott 1921 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RHM FOODSERVICE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RHM FOODSERVICE LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per RHM FOODSERVICE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 25 set 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2014 al 31 mar 2015 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Emmett Mcevoy il 10 lug 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Mcdonald il 10 lug 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore in data 20 apr 2012 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Antony David Smith come amministratore in data 20 apr 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Andrew Mcdonald come amministratore in data 15 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Suzanne Elizabeth Wise come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||
Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale | 2 pagine | CC02 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 34 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 01 ago 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RHM FOODSERVICE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
MCDONALD, Andrew John | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St Albans Hertfordshire | England | British | General Counsel & Company Secretary | 164670820001 | ||||
MCEVOY, Emmett | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St Albans Hertfordshire | United Kingdom | Irish | Director | 168590540001 | ||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | Company Secretary | 125719290002 | ||||
BURTON, Denise Patricia | Segretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
CRADDOCK, Martin Keith Robert | Segretario | The Dairy House St Nicholas Farm RG10 0TA Hurst Berkshire | British | Director | 2383560001 | |||||
HARTREY, Patrick Mark | Segretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
HINES, Christine Anne | Segretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
MILLER, Roger Keith | Segretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | Company Secretary | 120645920001 | |||||
PHILLIPS, Timothy Richard | Segretario | Pendower 28 Stone Lane Lydiard Millicent SN5 9LD Swindon Wiltshire | British | 19988490001 | ||||||
WATERS, Paul Christopher | Segretario | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
WOODMORE, Michael Brian | Segretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
ALLNER, Andrew James | Amministratore | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | Finance Director Chartered Acc | 73003300001 | |||||
AUSTIN, Michael Allan | Amministratore | 6 Olive Grove Pinehurst SN2 3DB Swindon Wiltshire | British | Director | 41967870001 | |||||
BLACKMORE, Andrew David | Amministratore | The Lowe Fen Rd, Pakenham IP31 2JS Bury St Edmunds Suffolk | United Kingdom | British | Director | 127246350001 | ||||
CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Amministratore | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98818450001 | ||||
CRADDOCK, Martin Keith Robert | Amministratore | The Dairy House St Nicholas Farm RG10 0TA Hurst Berkshire | British | Director | 2383560001 | |||||
CROSSLEY, Nigel | Amministratore | Tempsford 34 Grove Road HP9 1PE Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | Financial Director | 145901880001 | ||||
DUNCAN, Ian Alexander | Amministratore | Durham House Durham Place SW3 4ET London | United Kingdom | British | Company Director | 27300002 | ||||
FIELD, Stephen Colin | Amministratore | Wildwood Cottage 20 The Green Cosgrove MK19 7JW Milton Keynes Buckinghamshire | British | Company Director | 19988530001 | |||||
HODGSON, John Robert | Amministratore | 13 Bencombe Road Marlow Bottom SL7 3NZ Marlow Buckinghamshire | British | Company Director | 19988510001 | |||||
IRVING, Patrick Haydn | Amministratore | Hyeswood Guildford Road Rudgwick RH12 3BX Horsham West Sussex | British | Company Director | 19988500001 | |||||
JAMES, Martin David | Amministratore | Bloomfield Hatch Farm House Bloomfield Hatch, Mortimer RG7 3AD Reading Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 19988520002 | ||||
KELLY, Timothy Geoffrey | Amministratore | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | Director | 92817300001 | ||||
LAWSON, Robert | Amministratore | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | Director | 99991140001 | ||||
LEWIS, David | Amministratore | Pennyfield 9 Pitch Pond Close Knotty Green HP9 1XY Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | Director | 69920630001 | ||||
LLOYD, Ian Barry | Amministratore | 1 Laurel Close Oakley RG23 7LN Basingstoke | British | Accountant | 91293240002 | |||||
MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Secretary/Director | 26880001 | |||||
MARTIN, Nicholas Scott | Amministratore | Ivon House High Road Broad Chalke SP5 5EH Salisbury Wiltshire | British | Director | 43737920001 | |||||
MCMAHON, Ian Reid | Amministratore | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | Chief Executive | 84644240002 | |||||
MURPHY, Thomas Jerome Peter | Amministratore | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | General Counsel | 76945730001 | |||||
PANTER, Alan James, Mr. | Amministratore | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | Chartered Accountant | 114414690002 | |||||
PEELER, Andrew Michael | Amministratore | 108 Ellesborough Road Wendover HP22 6EW Aylesbury Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Controller | 87359710001 | ||||
PHILLIPS, Timothy Richard | Amministratore | Pendower 28 Stone Lane Lydiard Millicent SN5 9LD Swindon Wiltshire | British | Company Director | 19988490001 |
RHM FOODSERVICE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 26 lug 2004 Consegnato il 06 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 41 ashton vale road ashton gate bristol f/H. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creato il 11 set 2000 Consegnato il 23 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0