NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED

NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00180567
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROCAR (HUDDERSFIELD) LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    W.H.ATKINSON AND CO. (HUDDERSFIELD) LIMITED23 mar 192223 mar 1922

    Quali sono gli ultimi bilanci di NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 29 mar 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2019 al 30 dic 2019

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di David Richard Pugh come amministratore in data 17 lug 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di David Richard Pugh come persona con controllo significativo il 01 gen 2019

    1 paginePSC07

    Cessazione di Michael Alfred Wilmshurst come persona con controllo significativo il 01 gen 2019

    1 paginePSC07

    Notifica di Nationwide Accident Repair Services Ltd come persona con controllo significativo il 01 gen 2019

    2 paginePSC02

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 apr 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 18,180
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 001805670011 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 apr 2015

    Stato del capitale al 10 apr 2015

    • Capitale: GBP 18,180
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    3 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Alfred Wilmshurst il 12 set 2014

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILMSHURST, Michael Alfred
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Amministratore
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director82302420002
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Segretario
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    British1841480001
    ALLAN, Richard Ronald
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    Amministratore
    Mornington House 1 High Trees
    CM4 9DQ Stock
    Essex
    United KingdomBritishChairman Perry Group Plc1841490001
    FRENCH, Neil Peter Donaldson, Dr
    Oakleaves
    5 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oakleaves
    5 Barrington Park Gardens
    HP8 4SS Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director166551820001
    HICKMAN-ASHBY, Martin James
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    7 High Elms Close
    HA6 2DG Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Secretary1841480001
    HOGG, David John
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    Amministratore
    Parklands Hall
    Church Hill, Middleton On The Wolds
    YO25 9UG Driffield
    East Yorkshire
    BritishAccountant113013220001
    LANE, Martin William
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Churchfields 6 New Road
    Great Chishill
    SG8 8ST Royston
    Hertfordshire
    BritishFinance Dirctor1841500001
    PUGH, David Richard
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Amministratore
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director108788360001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Nationwide Accident Repair Services Ltd
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    01 gen 2019
    Thorney Leys Park
    OX28 4GE Witney
    17
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione966807
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    Mr Michael Alfred Wilmshurst
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    06 apr 2016
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr David Richard Pugh
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    06 apr 2016
    17a Thorney Leys Park
    Witney
    OX28 4GE Oxfordshire
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    NATIONWIDE CRASH REPAIR SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 dic 2013
    Consegnato il 20 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage the property and all other land now vested in the chargor.. By way of first fixed charge all other land now vested in the chargor (to the extent not effectively charged by clause 3.1.1) and all land acquired by the chargor after the date of this debenture.. By way of first fixed charge any of the following in which the chargor has an interest: (a) any registered intellectual property right in any territory or jurisdiction, including, without limitation, patents, trade marks, service marks, registered designs, and any similar right in any territory or jurisdiction and any applications or right to apply for any of the above; (b) any invention, copyright, design right or performance right; (c) any trade secrets, know how and confidential information; and (d) the benefit of any agreement or licence for the use of any such right.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1987
    Consegnato il 12 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate near to southgate, huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 feb 1987
    Consegnato il 12 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate near to southgate, huddersfield.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 feb 1987
    Consegnato il 17 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & buildings at southgate huddersfield west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 17 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 21 gen 1986
    Consegnato il 24 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A fixed charge on all book and other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital (excluding those mentioned above).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 giu 1984
    Consegnato il 22 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on the north east side of southgate & land lying to the northeast of southgate, huddersfield or in the proceeds of sale thereof. T/nos yk 18206 yk 12465, wyk 10157.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 mag 1984
    Consegnato il 21 mag 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Parkside house, somerset road, huddersfield and/or the proceeds of sale thereof. Title no ywk 4481.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 14 lug 1983
    Consegnato il 18 lug 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    2 & 4 st johns rd huddersfield title no wyk 165084 and the proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 ott 1980
    Consegnato il 31 ott 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rocar group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land on the north east side of southgate, huddersfield, west yorkshire title nos yk 12465 yk 18206 and wyk 10157.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 31 ott 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 15 feb 1980
    Consegnato il 25 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts, goodwill & uncalled capital. Book debts, goodwill uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 25 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 24 gen 1974
    Consegnato il 31 gen 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 09 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0