CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED

CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASPIAN UK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00182180
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GOWRINGS LIMITED23 mar 200523 mar 2005
    GOWRINGS PLC09 giu 198909 giu 1989
    GOWRING'S LIMITED31 mag 192231 mag 1922

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021

    8 pagineAA

    Stato del capitale al 14 apr 2022

    • Capitale: GBP 0.10
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel capuital redemption reserve and share prem ac/ 13/04/2022
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2021 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Jan Mohammad Nader Zadeh come amministratore in data 29 ago 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mrs Yvonne Davey come segretario in data 31 mag 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael James Gray come segretario in data 31 mag 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael James Gray come amministratore in data 31 mag 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 01 gen 2017

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 03 gen 2016

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVEY, Yvonne
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars, 2 High Street
    Surrey
    England
    Segretario
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars, 2 High Street
    Surrey
    England
    259041230001
    NADER-ZADEH, Taji
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish35056010004
    CHADWICK, Clive Frederick
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    Segretario
    75 Gorselands
    Wash Common
    RG14 6PU Newbury
    Berkshire
    British107091790001
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Segretario
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    British37403500001
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Segretario
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    British6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Segretario
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    British55978100001
    SMITH, Graham Charles
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Segretario
    Lawndale
    8 Hillfield Road
    SL9 0DX Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British37978250001
    COULSON, Derek William
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Fox Lea Hermitage Road
    Cold Ash
    RG18 9JH Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish30237250002
    FOALE, Stephen John
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    Amministratore
    42 Holmbury Avenue
    RG45 6TQ Crowthorne
    Berkshire
    EnglandBritish37403500001
    FOWLES, John
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Burghclere Manor
    Old Burghclere
    RG20 9NS Newbury
    Berkshire
    British12870040001
    GOOD, Anthony Bruton Meyrick
    Clench House
    Wootton Rivers
    SN8 4NT Marlborough
    Wilts
    Amministratore
    Clench House
    Wootton Rivers
    SN8 4NT Marlborough
    Wilts
    United KingdomBritish39536400006
    GRAY, David Henry
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    Amministratore
    Whisper Wood House Whisper Wood
    Loudwater
    WD3 4JU Hertfordshire
    British6369250003
    GRAY, Michael James
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish55978100001
    KENDALL, David William
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    Amministratore
    41 Albion Street
    W2 2AU London
    United KingdomBritish9207490001
    NADER ZADEH, Jan Mohammad
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    Amministratore
    The Cedars
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    Surrey
    EnglandBritish102645370001
    OLDLAND, Michael John
    Dolmans Barn
    Hankerton
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Dolmans Barn
    Hankerton
    SN16 9LH Malmesbury
    Wiltshire
    British12870050002
    THOMAS, Vivian
    Camelot
    Bennett Way
    GU4 7TN West Clandon
    Surrey
    Amministratore
    Camelot
    Bennett Way
    GU4 7TN West Clandon
    Surrey
    EnglandBritish102093310001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Caspian Uk Group Limited
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    2 High Street
    GU19 5AE Bagshot
    The Cedars
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione2810190
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CASPIAN UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 17 feb 2005
    Consegnato il 19 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land and building at 1 wellington avenue aldershot hampshire title no HP652649.
    Persone aventi diritto
    • The Secretary of State for Defence
    Transazioni
    • 19 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 mar 2004
    Consegnato il 20 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1988
    Consegnato il 07 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 30,750 and all monies due or to become due from the company to the chargee and all moneys due for goods and services supplied
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a gowrings leisure centre at hte willows caravan park maidenhead berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Whitebread & Company PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 dic 1988
    Consegnato il 07 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a or being the willows caravan park, maidenhead road, bray, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mag 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 dic 1988
    Consegnato il 19 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a kings copse caravan park garsington oxford tn ON45651 (please refer to form M395). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 apr 1987
    Consegnato il 21 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or cowrings food services limited to the chargee on any account whatsover
    Brevi particolari
    L/H porperty l/a trafalgar house wellington avenue ardershot hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 nov 1985
    Consegnato il 27 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Church gate & cco church gate a thatcham grange, thatcham berkshire t/no BK52156 a/m us proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 09 dic 1983
    Consegnato il 15 dic 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land, truttle green, finchampstead rd, workingham, berkshire, title no bk 30719.
    Persone aventi diritto
    • United Dominatins Trust Limited
    Transazioni
    • 15 dic 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 mar 1982
    Consegnato il 08 mar 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Other lands buildings throttle green, finchampstead road, barks, title no BK30719 f/hold lands buildgs 85,87 basingstoke road reading berks title no BK183148 l/hold land & buildings unit 1 smallmead road reading, berks title no BK131326.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 08 mar 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 27 ago 1980
    Consegnato il 03 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the bank side of commercial road, reading, berkshire title no BK49008.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 lug 1980
    Consegnato il 25 lug 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold throttle green, wokingham berks title no bk 30719.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 lug 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 14 set 1971
    Consegnato il 21 set 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stock in trade as defined in the mortgage debenture (see doc. 99).
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 21 set 1971Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 19 gen 1971
    Consegnato il 28 gen 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Swanbridge garage, london road, newbury, berks. L/h swanbridge & brookside filling stations london road, newbury, berks.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 1971Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1970
    Consegnato il 21 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at 60 beaumpstoke rd, reading, berks title no br 49007.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 02 dic 1970
    Consegnato il 21 dic 1970
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Part of 169, basingstoke rd, reading, berkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1970Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 18 gen 1961
    Consegnato il 18 gen 1961
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1800 and all other monies due..etc
    Brevi particolari
    17 westernville road reading, berks.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Permanent Bldg Society
    Transazioni
    • 18 gen 1961Registrazione di un'ipoteca
    • 20 dic 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1959
    Consegnato il 26 feb 1959
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 25,000
    Brevi particolari
    75 and 77 silver street reading, berks.
    Persone aventi diritto
    • B W Trade Facilities LTD
    Transazioni
    • 26 feb 1959Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 ott 1949
    Consegnato il 28 set 1949
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due etc
    Brevi particolari
    Freehold:- 6,8,10 london road reading.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 1949Registrazione di un'ipoteca
    • 28 mar 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0