ENNSTONE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàENNSTONE PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00185664
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ENNSTONE PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova ENNSTONE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    4 Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ENNSTONE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALBRIGHTON PLC30 mag 199030 mag 1990
    G F LOVELL PUBLIC LIMITED COMPANY11 nov 192211 nov 1922

    Quali sono gli ultimi bilanci di ENNSTONE PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per ENNSTONE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 mar 2012

    4 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 set 2011

    5 pagine4.68

    Nomina di un liquidatore volontario

    15 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    14 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 mar 2011

    7 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Deloitte Llp 4 Brindley Place Birmingham B1 2HZ in data 23 apr 2010

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 mar 2010

    26 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 mar 2010

    15 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagine2.34B

    Indirizzo della sede legale modificato da Breedon Hall Breedon on the Hill Derby DE73 8AN in data 15 feb 2010

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 set 2009

    29 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Colin Mcleod come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    80 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    58 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    5 pagine395

    Chi sono gli amministratori di ENNSTONE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCDONALD, Ross Edward
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    21b Four Oaks Road
    Four Oaks
    B74 2XT Sutton Coldfield
    West Midlands
    British44092870005
    COOPER, Julian Edward Peregrine
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    Amministratore
    17b Sheridan Road
    Merton Park
    SW19 3HW London
    United KingdomBritish91049680001
    JOHNSTON, John Michael Stuart
    The Garth Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    Amministratore
    The Garth Ballards Lane
    Limpsfield
    RH8 0SN Oxted
    Surrey
    British12314380002
    KENNEDY, Ciaran Anthony
    Robertson Road
    KY15 5YR Cupar
    29
    Fife
    Amministratore
    Robertson Road
    KY15 5YR Cupar
    29
    Fife
    ScotlandNorthern Irish43853920001
    SMITH, Stephen Rushworth
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    White Cottage 33 Heathfield
    SG8 5BN Royston
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6894950002
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Segretario
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    British55010900001
    COX, Philip Allan
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    Segretario
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    British45742480001
    GIBBINS, Malcolm
    6 Merion Grove
    DE23 4YR Derby
    Derbyshire
    Segretario
    6 Merion Grove
    DE23 4YR Derby
    Derbyshire
    British106989750001
    HUGHES, Philip John
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    Segretario
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    British1601150001
    ADCOCK, John Robert
    Baddesley Holt
    Cressetts Wood Road
    B26 6EX Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Baddesley Holt
    Cressetts Wood Road
    B26 6EX Lapworth
    Warwickshire
    British13991270001
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Amministratore
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    United KingdomBritish55010900001
    BARLOW, John
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    Amministratore
    43 Durleston Park Drive
    KT23 4AJ Great Bookham
    Surrey
    United KingdomBritish55010900001
    BERWICK, Gerald Richard Gray
    Garden Lodge
    Hill House Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Hampshire
    Amministratore
    Garden Lodge
    Hill House Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Hampshire
    EnglandBritish81937150001
    BOWDEN, Philip
    3 Tealby Close
    Gilmorton
    LE17 5PT Lutterworth
    Leicestershire
    Amministratore
    3 Tealby Close
    Gilmorton
    LE17 5PT Lutterworth
    Leicestershire
    British28032710001
    BREALEY, Peter Ian
    Southfield House 67 High Street
    Braunston
    NN11 4BQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Southfield House 67 High Street
    Braunston
    NN11 4BQ Daventry
    Northamptonshire
    EnglandBritish9847020001
    BROWN, Graham Marshall
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Tudor Lodge
    14 Cressington Drive Four Oaks Park
    B74 2SU Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish9631280002
    COX, Philip Allan
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    Amministratore
    10 Tetchill Close
    Great Sutton
    L66 2WJ South Wirral
    British45742480001
    CUTTER, Andrew James
    Oakwood 38 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Oakwood 38 Lovelace Avenue
    B91 3JR Solihull
    West Midlands
    British82531800001
    ELLIOTT, Mark
    6116 New Pembroke Lane
    IRISH Fredricks Burg
    Virginia, Va 22407
    Usa
    Amministratore
    6116 New Pembroke Lane
    IRISH Fredricks Burg
    Virginia, Va 22407
    Usa
    British104226710001
    GADSDEN, Eric John Spencer
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hawridge Place
    Hawridge
    HP5 2UG Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish13515270003
    HOWE, William Henry
    Tollbar House
    Hassop
    DE45 1NX Bakewell
    Derbyshire
    Amministratore
    Tollbar House
    Hassop
    DE45 1NX Bakewell
    Derbyshire
    British42418700001
    HUGHES, Philip John
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    Amministratore
    2 Meadow Grange Drive
    WV12 5YT Willenhall
    West Midlands
    British1601150001
    MARRIOTT, Philippa Ann
    9 Stratford Grove
    Putney
    SW15 1NU London
    Amministratore
    9 Stratford Grove
    Putney
    SW15 1NU London
    British12342520001
    MAWDSLEY, Jack
    The Old Vicarage
    Bishops Castle
    SY9 5AF Shropshire
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Bishops Castle
    SY9 5AF Shropshire
    British33669120001
    MCLEOD, Colin Vaughan
    The Homestead
    Ratcliffe Road
    LE7 4UF Thrussington
    Leicester
    Amministratore
    The Homestead
    Ratcliffe Road
    LE7 4UF Thrussington
    Leicester
    EnglandBritish32924830001
    ROSS, Timothy Stuart
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    Amministratore
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    EnglandBritish33564830003
    ROSS, Timothy Stuart
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    Amministratore
    Old Passage House
    Passage Road Aust
    BS35 4BG Bristol
    Avon
    EnglandBritish33564830003
    SCANNELL, Patrick John
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    20 Rugby Road
    Dunchurch
    CV22 6PN Rugby
    Warwickshire
    British8097790001
    SCOBIE, Kenneth Charles
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Path Hill House Path Hill
    Goring Heath
    RG8 7RE Reading
    Berkshire
    EnglandBritish8867190001
    TAYLOR, Robert
    Mill House
    Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Mill House
    Burnhill Green
    WV6 7JU Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1601190001
    WOOD, John Humphrey Askey
    Albyn House 239 New Kings Road
    SW6 4XG London
    Amministratore
    Albyn House 239 New Kings Road
    SW6 4XG London
    United KingdomBritish2109820001
    WOODMAN, Peter Brian
    31 High Street
    Albrighton
    WV7 3JF Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    31 High Street
    Albrighton
    WV7 3JF Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish1601200001

    ENNSTONE PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 04 mar 2009
    Consegnato il 12 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon details of charged account number 53029107 sort code 200771 account name bb re ennstone PLC.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 23 mag 2008
    Consegnato il 02 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and ennstone concrete products limited and each company (as defined) to the chargee on any account whatosever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future interest in the real property being breedon hall, breedon on the hill, derby LT331613, together with all buildings, fixtures, fittings and fixed plant and machinery and the benefit of any covenants for title given or entered into in respect of that property see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brian Watkins and John Campbell and Hr Trustees Limited, as Trustees of the Johnston Management Holdings Limited Pension and Life Assurance Scheme (Together as the Trustees and Each a Trustee)
    Transazioni
    • 02 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental security deed
    Creato il 17 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Parzialmente soddisfatta
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the relevant obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All property undertaking and assets of the company charged under the security documents to which the company is a party. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for Itself and Each of the Secured Parties
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2007
    Consegnato il 25 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 25 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 11 nov 2004
    Consegnato il 22 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7,717,351 ordinary shares of 10P each in the share capital of johnston group PLC and any further or other securities deposited or transferred by the company to the bank or its trustees or nominees in substitution for or in addition to such securities all dividends and interest all such rights moneys or property accruing or offered at any time by way of redemption bonus preference option or otherwise any bonus stock or shares or other new securities of a similar nature be deposited or transferred to the bank and become part of the securities.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 2001
    Consegnato il 29 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a debenture dated 7TH july 1997
    Brevi particolari
    Land and buildings at northwest hadley.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 19 ott 2000
    Consegnato il 26 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Barclays bank PLC re ennstone PLC gts bid deposit deal number 87811522. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 07 ago 1998
    Consegnato il 14 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account no 00716405. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 set 1996
    Consegnato il 12 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the counter-indemnity in respect of (a) the guarantees and (b) the charge over credit balances
    Brevi particolari
    (A) albrighton house 135 allport street cannock staffs t/n-SF279216. (B) bolton woods quarry shipley bradford west yorkshire and (c) all estates or interest in any other f/h or l/h property wheresoever situate now belonging to the company; .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Colin Vaughan Mcleod
    • Pontylue Development Company Limited
    Transazioni
    • 12 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 31 mar 1995
    Consegnato il 04 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £750,000.00 together with all sums due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Various chattels which include: telescopic 18T mobile crane serial number 17108, swivel head bridge type crane serial number 5032, instln GB110 edge polishing h/c serial number 29318. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 04 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 10 mag 1994
    Consegnato il 16 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sun alliance defective title indemnity policy number 937Y308347 policy dated 1/3/90.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1994
    Consegnato il 16 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bolton woods quarry, shipley, bradford, west yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £110,250
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tarmac Quarry Products Limited
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 03 feb 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £209,500
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tarmac Building Materials Limited
    Transazioni
    • 03 feb 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 gen 1993
    Consegnato il 26 gen 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Albrighton house 135 allport street cannock staffordshire t/n SF279216.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 22 gen 1992
    Consegnato il 07 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or transplastix limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sum of £250,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account no:78238218 and earmarked or designated by reference to the company.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 16 feb 1990
    Consegnato il 28 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the former regional offices of british coal & situate at all port street cannock staffordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 28 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 feb 1990
    Consegnato il 16 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 43 marquis park wimblebury road, littleworth cannock staffordshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Single debenture
    Creato il 30 ago 1989
    Consegnato il 02 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 21 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mar 1989
    Consegnato il 31 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 31 mar 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 30 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 lug 1987
    Consegnato il 30 lug 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Including trade fixtures l/h property k/a 15A, high street, bargoda. L/h propety k/a 4, alderney street newport gwent. Property k/a rexville newport gwent.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kirby & West Limited.
    Transazioni
    • 30 lug 1987Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 18 nov 1985
    Consegnato il 26 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kirby & West Limited
    Transazioni
    • 26 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 14 ott 1985
    Consegnato il 23 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £150,000
    Brevi particolari
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kirby & West Limited
    Transazioni
    • 23 ott 1985Registrazione di un'ipoteca

    ENNSTONE PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 mar 2009Inizio dell'amministrazione
    10 mar 2010Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicholas James Dargan
    Po Box 810
    66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Praticante
    Po Box 810
    66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    2
    DataTipo
    10 mar 2010Inizio della liquidazione
    07 set 2012Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Nicholas James Dargan
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Praticante
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0