ERS (A&H) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ERS (A&H) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00192785 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ERS (A&H) LIMITED?
- Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova ERS (A&H) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 52 - 54 Leadenhall Street EC3A 2BJ London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ERS (A&H) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EQUITY RED STAR (ACCIDENT & HEALTH) LIMITED | 02 ago 2004 | 02 ago 2004 |
| ANTHONY KIDD AGENCIES LIMITED | 29 set 1923 | 29 set 1923 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ERS (A&H) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per ERS (A&H) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian David Parker il 05 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian David Parker il 01 ott 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr David Charles Turner come segretario in data 14 lug 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Haviland Bacon come amministratore in data 06 giu 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James David Seton Adams come segretario in data 14 lug 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Haviland Bacon il 16 dic 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr James David Seton Adams come segretario in data 07 dic 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Terence Hunter Griffin come segretario in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD a 52 - 54 Leadenhall Street London EC3A 2BJ in data 16 lug 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 3 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Victoria Louise Cuggy come segretario in data 01 mag 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Stato del capitale al 31 dic 2014
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ERS (A&H) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURNER, David Charles | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 236361500001 | |||||||
| PARKER, Ian David | Amministratore | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | England | British | 165728150009 | |||||
| WADE, Katharine Anne | Amministratore | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | England | British | 152543610003 | |||||
| ADAMS, James David Seton | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 203469020001 | |||||||
| CUGGY, Victoria Louise | Segretario | Library House, New Road Brentwood CM14 4GD Essex | British | 105782010002 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | 186665480001 | |||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | Holliwell Chandlers CM0 8NY Burnham On Crouch Essex | British | 85213650001 | ||||||
| GRIFFIN, Steven Terence Hunter | Segretario | 21 Burrow Road SE22 8DU London | British | 63143680001 | ||||||
| NURCOMBE, Brian William Frank | Segretario | Dabrian 21 Palace View Road Chingford E4 9EN London | British | 16018470001 | ||||||
| RINGROSE, Christopher James | Segretario | Lindum Lodge, Orchard Close Risby IP28 6QL Bury St Edmunds Suffolk | British | 46372950001 | ||||||
| WILKINSON, Sidney James | Segretario | 67 Chessfield Park Little Chalfont HP6 6RU Amersham Buckinghamshire | British | 1138390001 | ||||||
| AYRTON, Robert | Amministratore | 14 Chigwell Rise IG7 6AB Chigwell Essex | British | 16029460002 | ||||||
| BACON, Mark Haviland | Amministratore | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52 - 54 England | United Kingdom | British | 251875420001 | |||||
| BAREHAM, Robert Edward | Amministratore | Squirrels 33 Bidborough Ridge TN4 0UT Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 8522090001 | |||||
| BURNHAM, John Richard | Amministratore | 16 Tufted Close Great Notley Garden Village CM7 8YE Black Notley Essex | British | 77862640001 | ||||||
| CHARLES, Colin David | Amministratore | The Holt 48 Woodcote Avenue SM6 0QY Wallington Surrey | England | British | 46667150002 | |||||
| DODDS, Paul Gavin | Amministratore | Badgers Barn Sparrow Lane CM22 7BA Hatfield Broad Oak Hertfordshire | England | British | 160890670001 | |||||
| FOY, Ian Russell | Amministratore | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex | United Kingdom | British | 154913420002 | |||||
| GIBSON, Andrew James | Amministratore | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex United Kingdom | England | British | 51599670003 | |||||
| GREENMAN, Stephen Mark | Amministratore | 22 Mayflower Gardens CM23 4PA Bishops Stortford Hertfordshire | British | 51025590002 | ||||||
| GREENMAN, Stephen Mark | Amministratore | 6 Normill Terrace Aston Clinton HP22 5AG Aylesbury Buckinghamshire | British | 51025590001 | ||||||
| HEATH, Duncan Rodney | Amministratore | Larkins Farm Stondon Road CM4 0JY Blackmoor Essex | British | 13823360001 | ||||||
| HEATH, Stuart Roger | Amministratore | Fair Green House Vantorts Road, Fair Green CM21 9AJ Sawbridgeworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 64352350003 | |||||
| JOSIAH, John Edward | Amministratore | 22 Norsey Close CM11 1AP Billericay Essex | England | British | 76943870001 | |||||
| KENT, Alan James | Amministratore | Fir Tree Lodge School Road CM7 8ST Rayne Essex | British | 31429740001 | ||||||
| KIER, Michael Hector | Amministratore | 23 Belmont Road TW2 5DA Twickenham Middlesex | Danish | 8719670001 | ||||||
| MORGAN, Douglas Michael | Amministratore | New Road CM14 4GD Brentwood Library House Essex | United Kingdom | British | 164736290001 | |||||
| MOWL, Donald William | Amministratore | 4 Ridgeway CM12 9NT Billericay Essex | British | 2850940001 | ||||||
| NICE, Richard Frederick | Amministratore | 70 Heritage Drive ME7 3EH Gillingham Kent | British | 2850930001 | ||||||
| PEXTON, Richard Anthony | Amministratore | 5 Endlesham Road SW12 8JX London | British | 36011070002 | ||||||
| SLAUGHTER, Anne Patricia | Amministratore | Trinest Beehive Chase Hook End CM15 0PG Brentwood Essex | British | 43304840002 | ||||||
| TIMBRELL, Sharon | Amministratore | 33 Glenton Way Rise Park RM1 4AG Romford Essex | British | 70189110001 | ||||||
| WARBURTON, Brian | Amministratore | Great Mead Standon Green End High Cross SG11 1BP Ware Hertfordshire | British | 8514310001 | ||||||
| WHITE, Raymond Leonard | Amministratore | 6 Greenways Goffs Oak EN7 5JY Cuffley Hertfordshire | British | 56012860001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ERS (A&H) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ers Insurance Group Limited | 16 apr 2016 | Leadenhall Street EC3A 2BJ London 52-54 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
ERS (A&H) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 13 ott 2004 Consegnato il 27 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 22 mag 2002 Consegnato il 31 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders"). | Creato il 25 apr 2002 Consegnato il 07 mag 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Second guarantee and debenture | Creato il 03 dic 1997 Consegnato il 22 dic 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of variation | Creato il 18 ott 1993 Consegnato il 29 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito For varying the terms of a lloyds brokers security and trust deed dated 18/10/89 | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of or pursuant to the byelaw. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security and trust deed | Creato il 18 ott 1989 Consegnato il 25 ott 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for creditors for the time being of the company in respect of insurance transactions under the terms of the deed | |
Brevi particolari All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trust deed | Creato il 23 feb 1983 Consegnato il 04 mar 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (for full details see doc M122). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 apr 1975 Consegnato il 14 ott 1975 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Freehold property known as "fairlawns" 79 crossbrook street, cheshunt, herts. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0