ERS (A&H) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàERS (A&H) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00192785
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ERS (A&H) LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ERS (A&H) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    52 - 54 Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ERS (A&H) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EQUITY RED STAR (ACCIDENT & HEALTH) LIMITED02 ago 200402 ago 2004
    ANTHONY KIDD AGENCIES LIMITED29 set 192329 set 1923

    Quali sono gli ultimi bilanci di ERS (A&H) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per ERS (A&H) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian David Parker il 05 apr 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian David Parker il 01 ott 2016

    2 pagineCH01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr David Charles Turner come segretario in data 14 lug 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Mark Haviland Bacon come amministratore in data 06 giu 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di James David Seton Adams come segretario in data 14 lug 2017

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mag 2016

    Stato del capitale al 16 mag 2016

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Haviland Bacon il 16 dic 2015

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr James David Seton Adams come segretario in data 07 dic 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Steven Terence Hunter Griffin come segretario in data 30 set 2015

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Library House, New Road Brentwood Essex CM14 4GD a 52 - 54 Leadenhall Street London EC3A 2BJ in data 16 lug 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    15 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 3

    2 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4

    2 pagineMR05

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 mag 2015

    Stato del capitale al 12 mag 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Victoria Louise Cuggy come segretario in data 01 mag 2015

    1 pagineTM02

    Stato del capitale al 31 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    4 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di ERS (A&H) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TURNER, David Charles
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    236361500001
    PARKER, Ian David
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Amministratore
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    EnglandBritish165728150009
    WADE, Katharine Anne
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Amministratore
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    EnglandBritish152543610003
    ADAMS, James David Seton
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    203469020001
    CUGGY, Victoria Louise
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    Segretario
    Library House, New Road
    Brentwood
    CM14 4GD Essex
    British105782010002
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Segretario
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    186665480001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Segretario
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    British85213650001
    GRIFFIN, Steven Terence Hunter
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    Segretario
    21 Burrow Road
    SE22 8DU London
    British63143680001
    NURCOMBE, Brian William Frank
    Dabrian 21 Palace View Road
    Chingford
    E4 9EN London
    Segretario
    Dabrian 21 Palace View Road
    Chingford
    E4 9EN London
    British16018470001
    RINGROSE, Christopher James
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    Segretario
    Lindum Lodge, Orchard Close
    Risby
    IP28 6QL Bury St Edmunds
    Suffolk
    British46372950001
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    AYRTON, Robert
    14 Chigwell Rise
    IG7 6AB Chigwell
    Essex
    Amministratore
    14 Chigwell Rise
    IG7 6AB Chigwell
    Essex
    British16029460002
    BACON, Mark Haviland
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    Amministratore
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52 - 54
    England
    United KingdomBritish251875420001
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish8522090001
    BURNHAM, John Richard
    16 Tufted Close
    Great Notley Garden Village
    CM7 8YE Black Notley
    Essex
    Amministratore
    16 Tufted Close
    Great Notley Garden Village
    CM7 8YE Black Notley
    Essex
    British77862640001
    CHARLES, Colin David
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    Amministratore
    The Holt 48 Woodcote Avenue
    SM6 0QY Wallington
    Surrey
    EnglandBritish46667150002
    DODDS, Paul Gavin
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    Amministratore
    Badgers Barn
    Sparrow Lane
    CM22 7BA Hatfield Broad Oak
    Hertfordshire
    EnglandBritish160890670001
    FOY, Ian Russell
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Amministratore
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United KingdomBritish154913420002
    GIBSON, Andrew James
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish51599670003
    GREENMAN, Stephen Mark
    22 Mayflower Gardens
    CM23 4PA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    22 Mayflower Gardens
    CM23 4PA Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British51025590002
    GREENMAN, Stephen Mark
    6 Normill Terrace
    Aston Clinton
    HP22 5AG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Normill Terrace
    Aston Clinton
    HP22 5AG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British51025590001
    HEATH, Duncan Rodney
    Larkins Farm Stondon Road
    CM4 0JY Blackmoor
    Essex
    Amministratore
    Larkins Farm Stondon Road
    CM4 0JY Blackmoor
    Essex
    British13823360001
    HEATH, Stuart Roger
    Fair Green House
    Vantorts Road, Fair Green
    CM21 9AJ Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fair Green House
    Vantorts Road, Fair Green
    CM21 9AJ Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish64352350003
    JOSIAH, John Edward
    22 Norsey Close
    CM11 1AP Billericay
    Essex
    Amministratore
    22 Norsey Close
    CM11 1AP Billericay
    Essex
    EnglandBritish76943870001
    KENT, Alan James
    Fir Tree Lodge
    School Road
    CM7 8ST Rayne
    Essex
    Amministratore
    Fir Tree Lodge
    School Road
    CM7 8ST Rayne
    Essex
    British31429740001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    Danish8719670001
    MORGAN, Douglas Michael
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    Amministratore
    New Road
    CM14 4GD Brentwood
    Library House
    Essex
    United KingdomBritish164736290001
    MOWL, Donald William
    4 Ridgeway
    CM12 9NT Billericay
    Essex
    Amministratore
    4 Ridgeway
    CM12 9NT Billericay
    Essex
    British2850940001
    NICE, Richard Frederick
    70 Heritage Drive
    ME7 3EH Gillingham
    Kent
    Amministratore
    70 Heritage Drive
    ME7 3EH Gillingham
    Kent
    British2850930001
    PEXTON, Richard Anthony
    5 Endlesham Road
    SW12 8JX London
    Amministratore
    5 Endlesham Road
    SW12 8JX London
    British36011070002
    SLAUGHTER, Anne Patricia
    Trinest Beehive Chase
    Hook End
    CM15 0PG Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Trinest Beehive Chase
    Hook End
    CM15 0PG Brentwood
    Essex
    British43304840002
    TIMBRELL, Sharon
    33 Glenton Way
    Rise Park
    RM1 4AG Romford
    Essex
    Amministratore
    33 Glenton Way
    Rise Park
    RM1 4AG Romford
    Essex
    British70189110001
    WARBURTON, Brian
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Amministratore
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British8514310001
    WHITE, Raymond Leonard
    6 Greenways
    Goffs Oak
    EN7 5JY Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Greenways
    Goffs Oak
    EN7 5JY Cuffley
    Hertfordshire
    British56012860001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ERS (A&H) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52-54
    England
    16 apr 2016
    Leadenhall Street
    EC3A 2BJ London
    52-54
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLaw Of England And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02925652
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ERS (A&H) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 ott 2004
    Consegnato il 27 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (The "Trustee")
    Transazioni
    • 27 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 mag 2002
    Consegnato il 31 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank PLC (As Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 31 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A subordination and security trust deed dated 25 april 2002 made between the company and the obligors listed in schedule 3 to this form 395 (the "original obligors), hsbc investment bank PLC (the "trustee" and "agent") and the lenders listed in schedule 4 to this form 395 (the "orignal lenders").
    Creato il 25 apr 2002
    Consegnato il 07 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities now or at any time in the future due, owing or incurred by the obligors to secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company has covenanted and agreed that in the event of payment or discharge (whether in cash, by way of transfer of shares or other assets, set-off or counterclaim or otherwise) being made to, or an encumbrance being held by, the company in breach of clause 3.2 (prohibited payments and security) of the subordination and security trust deed, it will pay or transfer to the trustee for application in accordance with the terms of clause 7 (application of proceeds) of the subordination and security trust deed any sums or other assets which shall have been received or retained by it in consequence of such breach (whereupon the underlying subordination debt equivalent to the payment made shall be deemed not to have been reduced) and, until such payment or transfer, the company shall hold such sums or other assets or such encumbrance (as the case may be) on trust for the trustee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank Plcas Agent and Trustee for the Secured Parties Under the Subordination and Security Trust Deed
    Transazioni
    • 07 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second guarantee and debenture
    Creato il 03 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 ott 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of variation
    Creato il 18 ott 1993
    Consegnato il 29 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For varying the terms of a lloyds brokers security and trust deed dated 18/10/89
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of or pursuant to the byelaw. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds
    Transazioni
    • 29 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security and trust deed
    Creato il 18 ott 1989
    Consegnato il 25 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for creditors for the time being of the company in respect of insurance transactions under the terms of the deed
    Brevi particolari
    All monies for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyd's
    Transazioni
    • 25 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 15 giu 2015Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 20 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust deed
    Creato il 23 feb 1983
    Consegnato il 04 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (for full details see doc M122).
    Persone aventi diritto
    • The Corporation of Lloyd's
    Transazioni
    • 04 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 14 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 1975
    Consegnato il 14 ott 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Freehold property known as "fairlawns" 79 crossbrook street, cheshunt, herts. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyn's Bank LTD.
    Transazioni
    • 14 ott 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0