LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED

LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00201028
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Shackleton House
    4 Battlebridge Lane
    SE1 2HX London Bridge City
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHEAPSIDE LAND DEVELOPMENT CO.,LIMITED (THE)15 ott 192415 ott 1924

    Quali sono gli ultimi bilanci di LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Richard Gordon Ratcliffe come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Sanders come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Donald Corner come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Anthony White come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di David Bithell come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Timothy James Sanders come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Rodney Nigel Pearson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nigel Brown come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 04 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Card come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CORNER, Stephen Donald
    Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    57
    Kent
    England
    Segretario
    Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    57
    Kent
    England
    159292600001
    PEARSON, Rodney Nigel
    4 Battlebridge Lane
    London Bridge City
    SE1 2HX London
    Shackleton House
    Amministratore
    4 Battlebridge Lane
    London Bridge City
    SE1 2HX London
    Shackleton House
    EnglandBritishExecutive Director149103360001
    RATCLIFFE, Richard Gordon
    Shirley Avenue
    CR0 8SQ Croydon
    117
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Shirley Avenue
    CR0 8SQ Croydon
    117
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishExecutive Director159287250001
    WHITE, Anthony John
    4 Greencourt Road
    Petts Wood
    BR5 1QW Orpington
    Kent
    Segretario
    4 Greencourt Road
    Petts Wood
    BR5 1QW Orpington
    Kent
    British90266920001
    BALL, Trevor David
    53 Old Park Avenue
    EN2 6PJ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    53 Old Park Avenue
    EN2 6PJ Enfield
    Middlesex
    BritishSenior Investment Manager3864690001
    BELLHOUSE, Christopher Edward
    Merrie Oak
    Warmlake Sutton Valence
    ME17 3JA Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Merrie Oak
    Warmlake Sutton Valence
    ME17 3JA Maidstone
    Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor15552970001
    BETTS, David Roland
    35 High Street
    Foxton
    CB2 6SP Cambridge
    Amministratore
    35 High Street
    Foxton
    CB2 6SP Cambridge
    British33369690001
    BITHELL, David
    89 North Road
    TW9 4HQ Kew
    Surrey
    Amministratore
    89 North Road
    TW9 4HQ Kew
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant79659200001
    BROWN, Nigel Anthony
    Floreal
    51 Wray Park Road
    RH2 0EQ Reigate
    Surrey
    Amministratore
    Floreal
    51 Wray Park Road
    RH2 0EQ Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Surveyor68890990002
    BUCHANAN, David Fordyce
    Hastings Pennymead Drive
    East Horsley
    KT24 5AH Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Hastings Pennymead Drive
    East Horsley
    KT24 5AH Leatherhead
    Surrey
    BritishChief Investment Manager3864680001
    CARD, Stephen Paul
    137 Butchers Lane
    Mereworth
    ME18 5QD Maidstone
    Kent
    Amministratore
    137 Butchers Lane
    Mereworth
    ME18 5QD Maidstone
    Kent
    EnglandBritishChartered Surveyor69334840001
    SANDERS, Timothy James
    Shackleton House
    4 Battlebridge Lane
    SE1 2HX London Bridge City
    London
    Amministratore
    Shackleton House
    4 Battlebridge Lane
    SE1 2HX London Bridge City
    London
    EnglandBritishChartered Accountant147690940001
    SAVAGE, Malcolm George Piercy
    Hallams Farm House Littleford Lane
    Shamley Green
    GU5 0RH Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Hallams Farm House Littleford Lane
    Shamley Green
    GU5 0RH Guildford
    Surrey
    BritishChartered Surveyor5237820001

    LISTER HOSPITAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 apr 1954
    Consegnato il 03 ago 1954
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and whole the subjects known as princes square glasgow with the buildings erected thereon excepting fire shops and bank premises on the ground floor of the buildings facing buchanon st. And basements.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1954Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed by way of substituted security
    Creato il 09 giu 1953
    Consegnato il 26 gen 1953
    In corso
    Importo garantito
    In securing £ 900,000 debenture stock together with a premium of 3% secured by a trust deed dated 18 dec 51.
    Brevi particolari
    247 high st, camden town 836 london road, north chicam 65/79 (odd) maidston rd, sidcup.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 26 gen 1953Registrazione di un'ipoteca
    Charge by way of substituted security supplemental to legal charge dated 31/7/47
    Creato il 30 set 1952
    Consegnato il 17 ott 1952
    In corso
    Importo garantito
    £ 285000 secured by a charge dtd 31 jul 47
    Brevi particolari
    Empire house st martins le grand london ec 1.
    Persone aventi diritto
    • The St. Martins Le Grand Property Co. LTD.
    Transazioni
    • 17 ott 1952Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed by way of substituted security
    Creato il 30 set 1952
    Consegnato il 15 ott 1952
    In corso
    Importo garantito
    For securing £900,000 debenture stock together with a premium of 3% secured by a trust deed dated 18-12-51.
    Brevi particolari
    The property specific in the trust deed with one exception. ( see doc 193 for further details)first fixed charge on empire house st. Martins le grnd and on the issued ordinary capital of hasilwood properties LTD. The undertaking assets buildings uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Corporation LTD
    Transazioni
    • 15 ott 1952Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge registered persuant to an order of court,23-1-1953.
    Creato il 19 dic 1951
    Consegnato il 30 gen 1953
    In corso
    Importo garantito
    £ 285,000 secured by a charge dated 31 jul 47.
    Brevi particolari
    Various properties (for details of which see doc 200.).
    Persone aventi diritto
    • The St. Martins Le Grand Property Co LTD.
    Transazioni
    • 30 gen 1953Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0