LITESOME SPORTSWEAR LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LITESOME SPORTSWEAR LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00207867 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit A Brook Park East NG20 8RY Shirebrook |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021 | 7 pagine | AA | ||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020 | 7 pagine | AA | ||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019 | 7 pagine | AA | ||||||
Nomina di Mr Thomas James Piper come segretario in data 01 lug 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||
Cessazione della carica di Cameron John Olsen come segretario in data 01 lug 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alastair Peter Orford Dick il 01 mag 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||
Nomina di Mr Alastair Peter Orford Dick come amministratore in data 14 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2018 | 7 pagine | AA | ||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 gen 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2017 | 7 pagine | AA | ||||||
Conti modificati per una società dormiente redatti al 30 apr 2016 | 7 pagine | AAMD | ||||||
legacy | 17 pagine | CS01 | ||||||
| ||||||||
Nomina di Miss Rachel Isabel Lilian Stockton come amministratore in data 14 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di David Michael Forsey come amministratore in data 14 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Nomina di Adedotun Ademola Adegoke come amministratore in data 14 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||
Cessazione della carica di Michael James Wallace Ashley come amministratore in data 14 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||
Chi sono gli amministratori di LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPER, Thomas James | Segretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 260021610001 | |||||||
| ADEGOKE, Adedotun Ademola | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 203129860001 | |||||
| DICK, Alastair Peter Orford | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 256598390002 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Segretario | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MELLORS, Robert Frank | Segretario | The Warrener Warren Row RG10 8QS Reading Berkshire | British | 30104540002 | ||||||
| MOODIE, Gordon Murray | Segretario | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| OLSEN, Cameron John | Segretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | 183504980001 | |||||||
| RITCHIE, Alistair John, Sol | Segretario | Waterman's Lodge 15 Beales Lane KT13 8JS Weybridge Surrey | British | 6417760002 | ||||||
| SIMPSON, Brian Charles | Segretario | 15 Langham Way RG10 8AX Wargrave Berkshire | British | 47141350001 | ||||||
| TYLEE-BIRDSALL, Rebecca Louise | Segretario | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | British | 131967270001 | ||||||
| INVENSYS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Invensys House Carlisle Place SW1P 1BX London | 75491680001 | |||||||
| ASHLEY, Michael James Wallace | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | England | British | 95500210002 | |||||
| AUSTEN, Patrick George | Amministratore | 14 Chantry View Road GU1 3XR Guildford Surrey | British | 55015730001 | ||||||
| BROWN, Robert Casson | Amministratore | 38 Newlands Avenue Melton Park NE3 5PX Newcastle Upon Tyne | British | 6343100001 | ||||||
| FORSEY, David Michael | Amministratore | NG20 8RY Shirebrook Unit A Brook Park East United Kingdom | England | British | 147207580002 | |||||
| GRIFFITHS, Andrew Lawrence | Amministratore | Galane House Kimbers Drive SL1 8JE Burnham Berkshire | British | 66013840001 | ||||||
| JACOBS, David Michael | Amministratore | Riverside House Hall Cottages Lodden Drive RG10 8ND Reading Berkshire | British | 47141160001 | ||||||
| LOVELL, Alan Charles | Amministratore | The Palace House Bishops Lane SO32 1DP Bishops Waltham Hampshire | England | British | 149625410001 | |||||
| MARCHETTI, Carlo Antonio | Amministratore | Glenwood Woodland Rise TN15 0HZ Sevenoaks Kent | British | 1229580001 | ||||||
| MARNOCH, Alasdair, Mr. | Amministratore | Bramble Bottom Wedmans Lane RG27 9BX Rotherwick Hampshire | England | British | 216655900001 | |||||
| MELLORS, Robert Frank | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 30104540005 | |||||
| MOODIE, Gordon Murray | Amministratore | 1 Forest Lodge Epsom Road KT21 1JX Ashtead Surrey | British | 66078560001 | ||||||
| PARNELL, Philip John | Amministratore | The Old Bell House The Common HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | 57485400001 | |||||
| PETERS, Andrew Robert Gerald, 151298 | Amministratore | 1 Josephine Avenue KT20 7AB Lower Kingswood Surrey | British | 56810170001 | ||||||
| RONNIE, Christopher | Amministratore | 18 Macclesfield Road SK9 2AA Wilmslow Cheshire | British | 79360390001 | ||||||
| STOCKTON, Rachel Isabel Lilian | Amministratore | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | United Kingdom | British | 245592990001 | |||||
| THOM, James Demmink | Amministratore | Tollgate Cottage Turners Hill Road RH10 4HG Crawley Down West Sussex | British | 38683120002 | ||||||
| WILLIAMS, Stanley Killa | Amministratore | White Raven Park Lane KT21 1EU Ashtead Surrey | England | British | 34401400001 | |||||
| WYCHERLEY, Peter | Amministratore | 394 Barnsley Road Sandal WF2 6BW Wakefield West Yorkshire | British | 130910001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LITESOME SPORTSWEAR LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slazenger Carlton (Holdings) Ltd | 16 dic 2016 | Brook Park East NG20 8RY Shirebrook Unit A United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LITESOME SPORTSWEAR LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture | Creato il 10 mar 1996 Consegnato il 26 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to the financing documents (as therein defined) and all liabilities payable or owing by pixelframe limited (to be renamed dunlop slazenger group limited) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed, as therein defined) under or in connection with the vendor a note (as defined in the inter-creditor deed) including (without limitation) the guarantee liabilities of the company to pay all monies due and owing to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trade marks & patents charge | Creato il 10 mar 1996 Consegnato il 26 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) under or pursuant to the financing documents (as therein defined) and all liabilities payable or owing by pixelframe limited (to be renamed dunlop slazenger group limited) to any vendor note creditor (as defined in the inter-creditor deed, as therein defined) under or in connection with the vendor a note (as defined in the inter-creditor deed) including (without limitation) the guarantee liabilities of the company to pay all monies due and owing to any of the secured parties by any company within the group (as defined in the credit agreement) under or pursuant to any of the financing documents and the vendor a note | |
Brevi particolari First fixed charge all the trade marks as set out in the schedule to form 395 together with all the goodwill of the business and any other rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 mag 1984 Consegnato il 06 giu 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All f/hold and l/hold property with all fixtures thereon the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital for further details see doc M121. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0