THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED

THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00208036
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gleadhill House Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Lancashire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SAVOY HYDRO LIMITED(THE)25 ago 192525 ago 1925

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2011

    Stato del capitale al 06 lug 2011

    • Capitale: GBP 516,176
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 97 Church Street Blackpool Lancashire FY1 1HL in data 05 ott 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Craig John Hemmings il 26 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Lorimer Widders il 26 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Mark Lorimer Widders il 26 giu 2010

    2 pagineCH03

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    6 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    5 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Segretario
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    British2272770002
    HEMMINGS, Craig John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Amministratore
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish180952730001
    WIDDERS, Mark Lorimer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Amministratore
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    EnglandBritish2272770002
    DREGENT, Patricia Ann Taylor
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    Segretario
    17 Spinney Close
    RM13 8LR Rainham
    Essex
    British6369240002
    REVITT, Kathryn
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Segretario
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British49315020001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Segretario
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    British66825690001
    WRIGHT, David William
    The Oast House
    Shernfold Park Farm
    TN3 9DL Frant
    East Sussex
    Segretario
    The Oast House
    Shernfold Park Farm
    TN3 9DL Frant
    East Sussex
    British83417990001
    ASHWORTH, Paul Richard
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    Amministratore
    118 St Anns Hill
    Wandsworth
    SW18 2RR London
    EnglandBritish46410260001
    CHAPMAN, David Thomas
    7 Highcross Hill
    FY6 8BT Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    7 Highcross Hill
    FY6 8BT Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British43071850005
    COLES, Charles Graham
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    Amministratore
    Willow Cottage
    Chalfont Lane
    WD3 5PP Chorleywood
    Hertfordshire
    EnglandBritish12337010002
    CONLAN, John Oliver
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Sunnydale
    Bellingdon
    HP5 2XU Chesham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish9020510001
    ETCHES, Marc Warren
    East Dene
    Brettargh Drive Haverbreaks
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    Amministratore
    East Dene
    Brettargh Drive Haverbreaks
    LA1 5BN Lancaster
    Lancashire
    British61366690003
    FOSTER, Michael Raymond
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    Amministratore
    4 Church Close
    Westoning
    MK45 5DH Bedford
    EnglandBritish53280440001
    IRENS, Nicholas James
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Whitegates Farm
    Grants Lane
    RH8 0RQ Oxted
    Surrey
    British65447080002
    KILBY, Eric Melvyn
    White Lodge Broadway
    Hale
    WA15 0PQ Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    White Lodge Broadway
    Hale
    WA15 0PQ Altrincham
    Cheshire
    British165870002
    REVITT, Kathryn
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    3 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish49315020001
    SHILLINGLAW, Gary Preston
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Wynsdale
    9 Monkshanger
    GU9 8BU Farnham
    Surrey
    EnglandBritish66825690001
    SULLIVAN, Christopher John
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    Amministratore
    8 Spring Gardens
    Waddington
    BB7 3HH Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritish101400140001

    THE SAVOY HOTEL (BLACKPOOL) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 set 1998
    Consegnato il 14 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The clifton hotel talbot square 9/11 market street and 110/112 promenade blackpool (including basement under clifton arcade) 13-15 market street blackpool, the savoy hotel blackpool. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 set 1998
    Consegnato il 14 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The savoy hotel kings drive blackpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 01 set 1998
    Consegnato il 14 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The clifton hotel talbot square and 9/11 market street blackpool t/n LA481063. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 14 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 1987
    Consegnato il 29 gen 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £300,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The new clifton hotel talbot square, blackpool.
    Persone aventi diritto
    • Bass North Limited
    Transazioni
    • 29 gen 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 15 ago 1986
    Consegnato il 16 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land & buildings the clifton hotel, talbot square and 9 & 11, market st, blackpool, lancs. Title no. La 481063.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 24 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 set 1985
    Consegnato il 14 set 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £120,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee including moneys due for goods & services supplied.
    Brevi particolari
    Legal charge on the savoy hotel, queens promenade, blackpool together with the goodwill of the business carried on at such property and the book debts & other debts of the business.
    Persone aventi diritto
    • Wilson Brewery Limited
    Transazioni
    • 14 set 1985Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 24 mar 1971
    Consegnato il 13 apr 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant & machinery fixed & floating charge (see doc 76 for details).
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank LTD
    Transazioni
    • 13 apr 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 24 lug 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0