SITA CONTAINERS LIMITED

SITA CONTAINERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSITA CONTAINERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00208371
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SITA CONTAINERS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SITA CONTAINERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SITA CONTAINERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    A & J BULL CONTAINERS LIMITED02 giu 200002 giu 2000
    MARCO(CROYDON)LIMITED12 set 192512 set 1925

    Quali sono gli ultimi bilanci di SITA CONTAINERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SITA CONTAINERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Hedley Thompson come amministratore in data 31 ott 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 set 2013

    Stato del capitale al 20 set 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 21 dic 2012

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    3 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dividend shares 01/11/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Dividend approved and copy of res sent to auditors 19/07/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christophe Andre Bernard Chapron il 26 giu 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Hedley Thompson il 27 gen 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Hedley Thompson come amministratore in data 01 set 2010

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr David Courtenay Palmer-Jones come amministratore

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SITA CONTAINERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KNIGHT, Joan
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    British80543820001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandFrench122645500003
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish125070620001
    COOPER, Elizabeth Jayne Clare
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    Segretario
    39 Church Road
    LU5 6LE Harlington
    Bedfordshire
    British3540250005
    LEWIS, Jack Malcolm
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Saddlers Croft Road
    TN6 1DS Crowborough
    East Sussex
    British14038510001
    CARTWRIGHT, Keith Charles
    Redwood Cottage Church Way
    Hurst Green
    RH8 9EA Oxted
    Surrey
    Amministratore
    Redwood Cottage Church Way
    Hurst Green
    RH8 9EA Oxted
    Surrey
    EnglandBritish14038540002
    GOODFELLOW, Ian Frederick
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    Highlands Harewood Drive
    Cold Ash
    RG18 9PF Thatcham
    Berkshire
    EnglandBritish28725450004
    GORDON, Marek Robert
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    7 Woodbank Avenue
    SL9 7PY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish20420300002
    MILLS, Stephen Terence
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    Amministratore
    Bonnibur Copthill Lane
    Kingswood
    KT20 6HL Tadworth
    Surrey
    EnglandBritish14038520001
    MILLS, Terrence George
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    Amministratore
    Headley Hill House Lorretta Lodge
    Tilley Lane, Headley
    KT18 6EP Epsom
    Surrey
    British71438230001
    MOXON, Terrence Frederick
    19 Pointers Hill
    RH4 3PF Westcott
    Surrey
    Amministratore
    19 Pointers Hill
    RH4 3PF Westcott
    Surrey
    British14174250001
    SCARBOROUGH, Philip John
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Galedon House
    Hogs Back, Seale
    GU10 1JX Farnham
    Surrey
    EnglandBritish71437540001
    SEXTON, Ian Anthony
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Dedmere Road
    SL7 1PE Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish33971310004
    SHERWIN, David Andrew
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    Amministratore
    212 Ferrymead Avenue
    Greenford
    UB6 9TP Middlesex
    British10025660001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Sita House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish162837220002
    WATKINS, Steven Thomas
    42 Pauls Place
    KT21 1HN Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    42 Pauls Place
    KT21 1HN Ashtead
    Surrey
    EnglandBritish53589530002

    SITA CONTAINERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 63 hampton road croydon t/n SY71139 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property being 73 hampton road croydon together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the busines (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 33 and 35 hampton road croydon t/n SY275017 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2012Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Debenture
    Creato il 19 dic 1996
    Consegnato il 20 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 mar 1976
    Consegnato il 31 mar 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33, 35, 47, 51, 63, 65, 67, 73 hampton road, croydon. Land on the south west side of hampton road, croydon 49 to 67 (add nos) hanpton road croydon fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. (See doc 99 for full details).
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank LTD
    Transazioni
    • 31 mar 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 03 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0