SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED

SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00210591
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    31st Floor 40 Bank Street Canary Wharf
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WESTCOUNTRY PUBLICATIONS LIMITED12 apr 199612 apr 1996
    THE PRINT WORKS (PLYMOUTH) LIMITED25 ago 198825 ago 1988
    WEST COUNTRY PUBLICATIONS LIMITED23 dic 192523 dic 1925

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da Northcliffe House 2 Derry Street Kensington London W8 5TT a 31st Floor 40 Bank Street Canary Wharf London E14 5NR in data 06 mag 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    1 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 apr 2016

    LRESSP

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    5 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 28 set 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    AR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 apr 2015

    Stato del capitale al 22 apr 2015

    • Capitale: GBP 279,677
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 mag 2014

    Stato del capitale al 08 mag 2014

    • Capitale: GBP 279,677
    SH01

    Cessazione della carica di Paul Collins come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Paul Collins come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Frances Louise Sallas come segretario

    3 pagineAP03

    Indirizzo della sede legale modificato da * Northcliffe Accounting Centre Po Box 6795 St George Street Leicester LE1 1ZP* in data 07 apr 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di Mr Adrian Perry come amministratore

    3 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2013

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    Nomina di Mr Paul Simon Collins come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Auckland come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 02 ott 2011

    27 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SALLAS, Frances Louise
    Canary Wharf
    E14 5NR London
    31st Floor 40 Bank Street
    Segretario
    Canary Wharf
    E14 5NR London
    31st Floor 40 Bank Street
    British186662170001
    PERRY, Adrian
    2 Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    United Kingdom
    Amministratore
    2 Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    United Kingdom
    United KingdomBritish22614160003
    COLLINS, Paul Simon
    5 Weare Close
    Billesdon
    LE7 9DY Leicester
    Segretario
    5 Weare Close
    Billesdon
    LE7 9DY Leicester
    British44213280003
    GLASS, Roland Edmondson
    24 Martin Dene
    DA6 8NA Bexleyheath
    Kent
    Segretario
    24 Martin Dene
    DA6 8NA Bexleyheath
    Kent
    British2756690001
    ANDERSON-DIXON, Steve
    41 The Burgage
    Prestbury
    GL52 3DL Cheltenham
    Cressy House
    Gloucestershire
    Amministratore
    41 The Burgage
    Prestbury
    GL52 3DL Cheltenham
    Cressy House
    Gloucestershire
    EnglandBritish165738760001
    ANDREW, Tony George
    Kentony Baileys Meadow
    Stoke Fleming
    TQ6 0QD Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    Kentony Baileys Meadow
    Stoke Fleming
    TQ6 0QD Dartmouth
    Devon
    British47787950001
    AUCKLAND, Stephen Andrew
    Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House 2
    United Kingdom
    Amministratore
    Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House 2
    United Kingdom
    EnglandBritish271190100001
    BEATTY, Kevin Joseph
    1 Lansdowne Copse
    Off Lansdowne Court The Avenue
    KT4 7FB Worcester Park
    Surrey
    Amministratore
    1 Lansdowne Copse
    Off Lansdowne Court The Avenue
    KT4 7FB Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritish51345160003
    BLAIR, Andrew Gordon
    Alwyn Park
    PL6 5HU Plymouth
    1
    England
    United Kingdom
    Amministratore
    Alwyn Park
    PL6 5HU Plymouth
    1
    England
    United Kingdom
    EnglandBritish95436240003
    COLLINS, Paul Simon
    Weare Close
    Billesdon
    LE7 9DY Leicester
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Weare Close
    Billesdon
    LE7 9DY Leicester
    5
    United Kingdom
    EnglandEnglish172172370001
    COWARD, Christopher Vincent
    9 Aller Park Road
    TQ12 4NG Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    9 Aller Park Road
    TQ12 4NG Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritish67532460003
    CURRALL, Duncan James Steel
    Knighton Coombe
    PL21 0SR Modbury
    Devon
    Amministratore
    Knighton Coombe
    PL21 0SR Modbury
    Devon
    United KingdomBritish52502190004
    DAVIDSON, Alexander Lindsay
    19 Hyde Park Gardens Mews
    W2 2NU London
    Amministratore
    19 Hyde Park Gardens Mews
    W2 2NU London
    British30544090003
    GALE, Paul Francis
    14 Century Quay
    130-132 Vauxhall Street The Barbican
    PL4 0EP Plymouth
    Devon
    Amministratore
    14 Century Quay
    130-132 Vauxhall Street The Barbican
    PL4 0EP Plymouth
    Devon
    British25382760002
    GLYNN, Edward Paul
    The Bell House
    Burley On The Hill
    LE15 7TE Oakham
    Rutland
    Amministratore
    The Bell House
    Burley On The Hill
    LE15 7TE Oakham
    Rutland
    United KingdomBritish150541220001
    GOUGH, Andrew Paul
    Langdale Meavy Lane
    PL20 6AP Yelverton
    Devon
    Amministratore
    Langdale Meavy Lane
    PL20 6AP Yelverton
    Devon
    British49669060004
    GRABHAM, Anthony James
    36 Larch Road
    St Thomas
    EX2 9DG Exeter
    Devon
    Amministratore
    36 Larch Road
    St Thomas
    EX2 9DG Exeter
    Devon
    British26093860001
    GRIFFIN, James Ernest
    10 Orchard Close
    Woodbury
    EX5 1ND Exeter
    Devon
    Amministratore
    10 Orchard Close
    Woodbury
    EX5 1ND Exeter
    Devon
    EnglandBritish49611540002
    HAZELL, Antony John
    Gillan
    14 Tredenham Road
    TR2 5AN St Mawes
    Cornwall
    Amministratore
    Gillan
    14 Tredenham Road
    TR2 5AN St Mawes
    Cornwall
    British6770730002
    HINDLEY, Martyn John
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    Amministratore
    Upper Wield
    SO24 9RT Arlesford
    The Barn
    Hampshire
    EnglandBritish134332760001
    HOULT, Christopher
    Minchin House
    Aylesbeare
    EX5 2BY Exeter
    Amministratore
    Minchin House
    Aylesbeare
    EX5 2BY Exeter
    United KingdomBritish119982630001
    HUGHES, Linn May
    Bellhangers 2 Church Road
    Lympstone
    EX8 5JU Exmouth
    Devon
    Amministratore
    Bellhangers 2 Church Road
    Lympstone
    EX8 5JU Exmouth
    Devon
    British41675310003
    LEAN, David Geoffrey
    51 Higher Polsue Way
    Tresillian
    TR2 4BG Truro
    Cornwall
    Amministratore
    51 Higher Polsue Way
    Tresillian
    TR2 4BG Truro
    Cornwall
    British113495470001
    MACCOLL, Alastair Angus
    6 Beatty Close
    Derriford
    PL6 6LJ Plymouth
    Amministratore
    6 Beatty Close
    Derriford
    PL6 6LJ Plymouth
    British49587570004
    PARK, Ian Grahame
    6 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    Amministratore
    6 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    United KingdomBritish2756710001
    PELOSI, Michael Paul
    2 Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    Amministratore
    2 Derry Street
    Kensington
    W8 5TT London
    Northcliffe House
    United KingdomBritish43743750001
    PERSENT, Jonathan Abraham James
    The Grange
    Harts Lane Pinhoe
    EX1 3RD Exeter
    Devon
    Amministratore
    The Grange
    Harts Lane Pinhoe
    EX1 3RD Exeter
    Devon
    EnglandBritish44934760004
    SAUNDERS, Peter John
    Little Willows 45 West Common Way
    AL5 2LQ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Little Willows 45 West Common Way
    AL5 2LQ Harpenden
    Hertfordshire
    British1995550001
    SAUNDERS, Timothy Simon
    Beverley
    10 Rydon Lane Countess Wear
    EX2 7AW Exeter
    Amministratore
    Beverley
    10 Rydon Lane Countess Wear
    EX2 7AW Exeter
    British83062330003
    WARD, Kevin William
    Elm House
    The Street
    BS27 3TH Draycott
    Somerset
    Amministratore
    Elm House
    The Street
    BS27 3TH Draycott
    Somerset
    EnglandBritish84928700001

    SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Trust deed supplemental to trust deed of 19 july 1928
    Creato il 28 set 1928
    Consegnato il 01 ott 1928
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £50,000 deb stock.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • A. Hutchison
    • Sir D. Maclean
    Transazioni
    • 01 ott 1928Registrazione di un'ipoteca
    • 22 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    SOUTH WEST MEDIA GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 apr 2016Inizio della liquidazione
    26 lug 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Vivian Murray Bairstow
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0